Home
Bob's Side
Cath's Side
Steed Side
TNG Link
First Name:
Last Name:
Whispers Past
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Robert Glendunying
1580 - 1668 (88 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Robert Glendunying
[1]
b. 1580 d. From 1668 to
Margaret Maxwell
b. Abt 1580 d. 1647
2
James Glendinning
[1.1]
b. 1612 d. 10 Sep 1696
Agnes Affleck
b. Abt 1616 d. 27 Nov 1664
3
James Glendinning
[1.1.1]
b. Abt 1661
Agnes Little
b. Abt 1680
4
Archibald Glendinning
[1.1.1.1]
b. Feb 1704 d. 7 Nov 1751
Janet Beattie
b. 1699 d. 21 Feb 1773
5
James Glendinning
[1.1.1.1.1]
b. 17 Dec 1738 d. 9 Jan 1810
Isabella Beattie
b. 16 Jul 1744 d. 25 Sep 1816
6
Mary Glendinning
[1.1.1.1.1.1]
b. 28 Jan 1768 d. 8 Nov 1847
David Thomson
b. 30 Sep 1763 d. 22 Jun 1834
7
James D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 29 Apr 1789 d. 26 Mar 1867
Isabella Johnston
b. 26 Jun 1794 d. 11 Aug 1854
8
Sonny Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. Jul 1817 d. 9 Jul 1817
8
Jannet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 31 Aug 1818 d. 12 Mar 1819
8
David James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 5 Jun 1821 d. 28 Nov 1894
Agnes Burns
b. 24 May 1844 d. 8 Jan 1917
9
James B. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 9 Apr 1866 d. 4 Nov 1940
9
Margaret Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. May 1868 d. 31 Dec 1935
Edwin Thompson
b. 24 Jan 1863 d. 8 May 1922
10
David James Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. 19 May 1887 d. 1938
Mable A.
b. Abt 1891
11
Donald L. Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.1]
b. Abt 1918
10
Bertha May Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.2]
b. 10 Jan 1891 d. Mar 1978
Frederick C. Brinker
b. Abt 1890
11
Irene L. Brinker
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.2.1]
b. Abt 1915
10
Annie Ethel Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.3]
b. 14 Jun 1896
Henry Belcher
11
Leona M. Belcher
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.3.1]
10
Thomas Andrew Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.4]
b. Abt 1902 d. 1962
Amy L. Thurston
b. Abt 1899
11
Donald Hages
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.4.1]
b. Abt 1916
10
Gladys Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.5]
b. Abt 1904
+
Donald MacCallum
9
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 2 Mar 1871 d. 8 Jul 1948
James Albert Pherrill
b. 17 Jan 1861 d. 10 Apr 1931
10
David James Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 13 Sep 1889 d. 5 Jan 1965
Kate Fudge
11
David Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.1]
b. 15 Jul 1931
10
Charles Frederick Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 29 Aug 1893 d. 16 Jun 1967
Violet May Burgess
b. Abt 1897
11
Ruth Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.1]
b. 10 Feb 1917
+
William Cooper
11
Georgina Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.2]
b. 5 Mar 1919
+
Robert Charles Chiddenton
11
Isabella Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.3]
b. 16 Aug 1921
+
David Jeffrey
11
Alberta Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.4]
b. 7 Jan 1929
+
James E. Spicer
10
Arthur George Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 18 Nov 1895
Ethel May Ball
b. Abt 1897
11
Nelda Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1]
b. 27 Apr 1916
+
George Miller
11
Lorraine Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.2]
b. 6 Oct 1923
+
Donald Giddings
11
John Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3]
b. 22 May 1930
10
Mary Isabella Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 20 Jun 1897 d. 1982
Fred Bennett
b. Abt 1894
11
Arthur Bennett
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.4.1]
b. 29 Dec 1915
11
Marie Bennett
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.4.2]
b. 31 Jul 1917
+
William McNalley
11
Pherrill Bennett
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.4.3]
b. 15 Sep 1924
+
Ruth Ellen McGowan
10
Albert Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 12 Apr 1899 d. Jan 1901
10
Andrew Thomson Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.6]
b. 12 Apr 1899 d. 1974
Eva Corbett
b. 30 May 1898
11
Alexander Thomson Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.1]
b. 10 Feb 1929 d. 3 Feb 2020
11
Ronald Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.2]
b. 15 May 1932
11
Harold Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.3]
11
Paul Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4]
9
Andrew J Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 16 Sep 1873 d. 2 Feb 1947
Margaret Harper
b. 12 May 1880 d. Oct 1958
10
Evelyn Agnes Burns Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 24 Mar 1903
Frederick Edge
b. 9 Aug 1899
11
Dennis Frederick Edge
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
b. 17 Sep 1930
10
Ethel Gladys Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.2]
b. 29 Jun 1905
+
Joseph F Frevele
b. 29 May 1897 d. 1969
10
Elsie May Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
b. 23 Dec 1908
John J. Jones
b. 8 Apr 1903 d. 19 May 1948
11
Kenneth John Jones
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.1]
b. 9 Jun 1930
10
Andrew J. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.4]
b. 16 Apr 1910 d. 28 Oct 1911
10
Angus Ethbert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 26 Jan 1913 d. 13 Aug 1993
Rose Gurther
b. 8 Apr 1916
11
Jacqueline Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.1]
11
Jeffrey Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.2]
10
Margaret Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.6]
b. 4 Sep 1915
Herbert John Henry
b. 9 Oct 1909
11
Herbert Angus Henry
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.6.1]
b. 7 Nov 1932
11
Allen John Henry
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.6.2]
9
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 30 Jul 1875 d. Jan 30 1938
Mary Frances Rogerson
b. 10 Dec 1885 d. 18 Feb 1945
10
Morgan Jeffery Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.5.1]
b. 14 Mar 1906
10
Gerald "Gordon" Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.5.2]
b. 14 Nov 1909 d. 28 May 1990
9
Elizabeth Ann (Janie) Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 12 Jul 1877 d. 20 Jul 1942
Alexander G. Hough
b. 8 May 1850 d. 7 Aug 1945
10
Agnes Jane Hough
[1.1.1.1.1.1.1.3.6.1]
b. 2 Dec 1895
Alfred Edward Clary
b. Abt 1896 d. Apr 1956
11
Gordon Alexander Clary
[1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.1]
b. 25 Mar 1921
11
Herbert Angus Clary
[1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.2]
b. 28 Jan 1925
11
Shirley Clary
[1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.3]
b. 29 Jan 1927
10
Alexander Wilfred Hough
[1.1.1.1.1.1.1.3.6.2]
b. 6 Nov 1897 d. 1 Mar 1967
10
Herbert Stanley Hough
[1.1.1.1.1.1.1.3.6.3]
b. 3 Dec 1899
+
Mary Priscilla McCauley
b. Abt 1902
10
Gordon Wellington Hough
[1.1.1.1.1.1.1.3.6.4]
b. 3 Mar 1905
9
Robert Burns Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 2 Jun 1880 d. Abt 1902
+
Sophia R. Hough
b. 4 Jun 1878
9
Thaddeus A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 7 Apr 1889 d. Aft 1920
9
Richard John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3.9]
b. 2 Jun 1884 d. 24 May 1887
8
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 12 Feb 1823 d. 30 Jan 1895
John Underwood
b. 1 May 1822 d. 24 Oct 1906
9
Archibald Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 6 Feb 1848 d. Aft 1881
9
Catherine Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 7 Oct 1849 d. 10 Jan 1929
Rueben Wilson
b. 1 Apr 1853 d. 13 May 1926
10
Mary Ann Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 23 Jul 1876
James Alexander Mickle
b. 28 Jan 1872
11
Robert James Mickle
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 6 Jun 1899
11
Catherine Janet Mickle
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.2]
b. 1 Aug 1903
11
Barbara Weir Mickle
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 21 Mar 1909 d. 21 Mar 1909
11
Barbara Weir Mickle
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1.4]
b. 1 Mar 1910 d. 1 Mar 1910
10
James Rufus Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 16 Oct 1880
Etta Pearl Page
b. 19 Sep 1887
11
Olive Irene Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.1]
b. 7 Dec 1907
11
Nola Pearl Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2.2]
10
Janet Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 19 Mar 1878
10
Caroline Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 5 Jan 1885
+
Malcolm McAlpine
b. 24 Jul 1877 d. 16 Aug 1926
10
Robert James Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 7 Feb 1881
10
Frederick Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.6]
b. 22 Sep 1882
9
Jannet Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 14 Aug 1852 d. 31 Jan 1931
Henry Shank
b. 16 Feb 1835 d. 21 May 1909
10
David James Shank
[1.1.1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 6 Apr 1888
+
Addie M. Wisner
b. 1886
10
John W Shank
[1.1.1.1.1.1.1.4.3.2]
b. 4 Apr 1891
9
Elizabeth Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 26 Apr 1855 d. 24 Aug 1932
James McCloy
b. 29 Aug 1855 d. 25 Sep 1928
10
Nancy McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 24 Apr 1877 d. 14 Apr 1956
10
John McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2]
b. 28 Feb 1879 d. 2 Aug 1964
Helen Elizabeth Winter
b. 18 Oct 1890 d. 8 Aug 1959
11
Jean McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.1]
11
Doris McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.2]
11
Nancy M McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.3]
11
Charles E McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.4]
11
Gernith A McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.5]
11
John C McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.6]
10
Mary McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.3]
b. 23 Apr 1882 d. 30 Jun 1882
10
Archibald McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.4]
b. 6 Jun 1883 d. 22 Dec 1968
Andis Stilson
b. 1888 d. 22 Jul 1943
11
Hazel E McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.4.1]
b. 22 Sep 1914 d. 7 Dec 1991
+
Merton E Luther
b. 27 Aug 1909 d. 21 Nov 1991
11
Mary Ruth McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.4.2]
10
Mary Margaret McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.5]
b. 6 Jun 1887 d. 4 Sep 1962
James C. Kirk
b. 4 May 1887 d. 27 Oct 1968
11
Fred J Kirk
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.5.1]
b. 20 Mar 1911 d. 4 Apr 1996
11
Wilson Kirk
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.5.2]
b. 5 Jun 1913 d. 4 Sep 2007
11
Margaret E Kirk
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.5.3]
11
John M Kirk
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.5.4]
b. 4 May 1917 d. 29 Nov 1998
+
Genevieve O.
b. 19 Aug 1917 d. 21 Oct 2003
11
Robert D Kirk
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.5.5]
b. 16 Sep 1920 d. Nov 1978
11
Francis R Kirk
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.5.6]
b. 21 May 1924 d. 22 May 1987
10
Flossie McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.6]
b. 10 Jul 1889 d. 22 Nov 1918
10
Robert James McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.7]
b. 9 Nov 1891 d. 5 Dec 1934
Clara C Arnesen
b. 14 Sep 1899
11
Dorothy McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.7.1]
b. 14 Dec 1922 d. 2 Aug 1993
10
Frederick McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.8]
b. 21 Oct 1894 d. 15 Sep 1955
Myrtle Dailey
b. 22 Nov 1890
11
Vernon D McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.8.1]
b. 28 Feb 1916 d. 28 Aug 1998
11
Louise E McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.8.2]
11
James C McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.8.3]
11
Beatrice McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.8.4]
11
Neva McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.8.5]
11
Wanda McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.8.6]
11
Eugene McCloy
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.8.7]
9
Rebecca Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 1860 d. 13 Sep 1900
Thomas Brophey
b. 18 Sep 1854 d. 28 Jan 1923
10
Margaret Elizabeth Brophey
[1.1.1.1.1.1.1.4.5.1]
b. 28 Aug 1884 d. 14 May 1897
10
Howard E. Brophey
[1.1.1.1.1.1.1.4.5.2]
b. 9 Jan 1892
Mary
b. 1896
11
Dorothy Brophey
[1.1.1.1.1.1.1.4.5.2.1]
10
Rose May Brophey
[1.1.1.1.1.1.1.4.5.3]
b. 12 Dec 1886
10
Lincoln Abraham Brophey
[1.1.1.1.1.1.1.4.5.4]
b. 30 Apr 1890 d. 30 Dec 1891
9
James Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.4.6]
b. Apr 1858 d. 16 Oct 1879
9
Mary Ann Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 3 Oct 1853 d. 25 Jun 1904
George Weir
b. 14 Sep 1846 d. 6 Mar 1931
10
Janet Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.1]
b. 12 Nov 1880 d. 4 Mar 1962
William James Clayton
b. 17 Nov 1875 d. 2 Oct 1929
11
Elsie Whilomina Clayton
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.1.1]
b. 11 Mar 1900 d. Mar 1900
11
Elda Marie Clayton
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.1.2]
b. 4 Apr 1906 d. 22 Dec 1950
Horace Bertram Hope
b. 28 Jun 1903
12
Lois Hope
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.1.2.1]
b. 15 Sep 1923 [
=>
]
11
Ruth Clayton
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.1.3]
b. 5 Aug 1916
Donald McConnell
12
Barry McConnell
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.1.3.1]
11
Wilbur S. Clayton
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.1.4]
b. 1 Nov 1910 d. 1910
10
Georgina Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.2]
b. 2 Nov 1888 d. 8 Nov 1918
William Bell
11
Wifred Bell
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.2.1]
11
Percy Bell
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.2.2]
11
Myrtle Bell
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.2.3]
+
Noel Burrows
10
Elizabeth Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.3]
b. 9 Jan 1877 d. 17 Mar 1942
Archibald Ashford Walton
b. 26 Mar 1878 d. 1 Sep 1961
11
Ashford Walton
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.3.1]
b. 28 Oct 1905
11
Stanley Irwin Walton
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.3.2]
b. Nov 1910
11
Francis (Frank) Walton
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.3.3]
b. Nov 1908
11
Violet Walton
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.3.4]
b. 28 May 1912
Joseph Bloom
d. 1958
12
Shirley Bloom
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.3.4.1]
12
Faye Rosella Bloom
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.3.4.2]
12
Carol Bloom
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.3.4.3]
10
James Underwood Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.4]
b. 13 Dec 1882 d. 18 Oct 1933
Minnie Elizabeth Coxworth
b. Mar 1885 d. 22 Dec 1957
11
Marion Velma Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.4.1]
b. 10 May 1904
+
Coxworth Dunstan
11
Alvin Thomas Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.4.2]
b. 5 Mar 1906
11
Reta Gladys Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.4.3]
b. 19 Apr 1909
+
A Hodgkinson
11
Jean Millicent Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.4.4]
+
Arthur Henry Wright
10
John Haddow Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.5]
b. 9 Sep 1887 d. 22 Jul 1960
Norah Lily May Webber
b. Nov 1902
11
Georgina Frances Marie Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.5.1]
b. 1 Sep 1923
+
William Bayes
11
John William Bruce Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.5.2]
b. 12 Dec 1921 d. 2 May 1966
Evelyn Mary Clodd
12
Bruce Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.5.2.1]
11
Robert Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.5.3]
b. 31 Jan 1925
Mary Richie
12
Susanne Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.5.3.1]
12
Michelle Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.5.3.2]
12
Lorne Scott Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.5.3.3]
11
Pansy Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.5.4]
b. 27 May 1928
10
Mary Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.6]
b. 27 Nov 1902 d. 20 Sep 1924
10
Catherine (Katie) Ethel Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7]
b. 7 Jul 1891 d. 18 Jun 1972
Albert Franklin Clements
b. 9 Sep 1891 d. 22 Feb 1960
11
Marjorie Evelyn Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.1]
b. 20 Apr 1914 d. 17 Aug 1928
11
Jean Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.2]
b. 3 Feb 1916 d. 17 Aug 2002
Samuel Morris
12
Virginia Gail Morris
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.2.1]
11
Myrna Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.3]
b. 28 Oct 1921
James Murray
12
Bonnie Jean Murray
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.3.1]
12
John Murray
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.3.2]
11
Reginald C Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.4]
b. 1 Sep 1923
Bernice Lanigan
12
Susan Lynne Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.4.1]
12
Karen Ann Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.4.2]
12
Norman Franklin Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.4.3]
12
Elda Marie Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.4.4]
12
Robert Michael Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.4.5]
11
John Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.5]
b. 11 Jul 1917
Margaret Dolly Chamberland
12
James Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.5.1]
12
Robert Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.5.2]
12
Gloria Clements
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.7.5.3]
+
David Wagg
b. 21 Jan 1886
10
Mary Margaret Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.8]
b. 27 Nov 1873 d. 20 Sep 1924
10
Weir
[1.1.1.1.1.1.1.4.7.9]
b. 16 Jul 1875
8
Robert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 4 May 1825 d. 11 Apr 1894
Mary Sellers
b. 25 Feb 1847 d. 7 Dec 1926
9
Sarah Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 26 Dec 1872 d. 27 Jun 1952
+
Thomas Slipper
b. 23 May 1883 d. 4 Oct 1965
9
James A Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 9 Sep 1874 d. 20 Jan 1940
+
Minnie O'Hara
b. 28 Jan 1876 d. 27 Jun 1954
9
William David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.5.3]
b. 20 Sep 1876 d. 30 Jan 1949
9
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.5.4]
b. 1 May 1879 d. Jul 1940
+
Dr. Andrew Pritchard MacKinnon
b. Jul 1880 d. 9 Jun 1945
9
Stephen Sidney Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.5.5]
b. 26 May 1883 d. 30 Oct 1969
Kathryn Dean Courtney
b. 27 May 1886
10
Shirley Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.5.5.1]
b. 1 Nov 1928 d. 27 Oct 2013
Gerald James Jenvey
b. 13 Aug 1925 d. 28 Aug 1992
11
Lorne Geraldine Jenvey
[1.1.1.1.1.1.1.5.5.1.1]
11
Stephen Frederick Jenvey
[1.1.1.1.1.1.1.5.5.1.2]
9
Sophie Annie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.5.6]
b. 2 Oct 1885 d. 27 Feb 1962
William John Pollard
b. 1881 d. 18 Sep 1947
10
Verna Rozella Pollard
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.1]
b. 20 Aug 1909 d. 11 Feb 1996
Ferdy Fiedler
11
Marjory Fiedler
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.1.1]
11
Dwayne Fiedler
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.1.2]
11
Adele Fiedler
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.1.3]
11
Lyle Fiedler
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.1.4]
11
Bryan Fiedler
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.1.5]
11
Dale Fiedler
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.1.6]
10
Della Pollard
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.2]
b. 16 Jul 1914
Gordon Dunbar
11
Robert Dunbar
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.2.1]
11
David Dunbar
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.2.2]
11
Joyce Dunbar
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.2.3]
10
James Edward Pollard
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.3]
b. 18 Mar 1922
Gladys Simmerson
11
Arthur Pollard
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.3.1]
11
May Pollard
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.3.2]
11
Douglas James Pollard
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.3.3]
11
Gwendolyn Pollard
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.3.4]
11
Betty Pollard
[1.1.1.1.1.1.1.5.6.3.5]
+
Frank Lulems
d. 3 Dec 1960
8
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 1829
8
Andrew James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 27 Jan 1830 d. 20 Oct 1907
Mary McKirgan
b. 15 Jul 1837 d. 18 Jan 1931
9
James Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 29 Jan 1865 d. 2 Apr 1924
Hannah Ellen Sylvester
b. 6 Jul 1861 d. 6 Jan 1890
10
Hannah Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1]
b. 21 Dec 1889 d. 9 Oct 1962
Richard Thomas Sylvester
b. 1 Mar 1880 d. 4 Mar 1968
11
Willard Earl Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.1]
b. 18 Feb 1908 d. 28 Oct 1976
+
Mary Lena Blonden
b. 8 Jan 1912 d. 26 Sep 1989
11
Edwin George Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.2]
b. 3 Jan 1909 d. 24 Mar 1994
Ida Dorothy Ash
b. 16 Feb 1915 d. 9 May 1968
12
Francis Jean Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.2.1]
12
Richard James Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.2.2]
12
Jeffery Thomas Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.2.3]
11
James Lowell Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.3]
b. 5 Feb 1914 d. 9 May 1968
Avis Delores Huffstutler
b. 4 Mar 1919
12
Peggy Laurene Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.3.1]
12
Richard Thomas Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.3.2]
12
Georgia Elaine Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.1.3.3]
Isabella Jane Sanderson
b. 17 Nov 1865 d. 9 Mar 1936
10
Medford Ryerson Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.2]
b. 14 Dec 1894 d. 2 Jul 1918
10
George Aviner Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.3]
b. 13 Jan 1897 d. 1 Jan 1961
Edythe Roston Monet
b. 14 Feb 1899 d. 4 Dec 1970
11
Calvin Dean Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.1]
b. 1 Mar 1928 d. 2 Mar 1928
11
Jack Beverly Eugene Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.2]
b. 27 Mar 1931
Carol Chase
b. 27 Feb 1933
12
Scott Eugene Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.2.1]
12
Carolynn Marie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.2.2]
12
Paul Douglas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.3.2.3]
10
Ethel Muriel Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.4]
b. 18 Sep 1898 d. 28 May 1972
+
Hughbert Winston MacPherson
b. 28 Aug 1900 d. 19 Apr 1973
10
Ross Sanderson Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.5]
b. 27 May 1901 d. 23 Dec 1923
10
Mary Edna Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6]
b. 2 Jan 1904 d. 10 Feb 1988
Nelson James Thomson
b. 9 Nov 1895 d. 21 Sep 1950
11
Ethel Marie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.1]
b. 10 Feb 1923 d. 1998
+
Edmund Trudeau
b. 11 Jun 1926
11
Myrel Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.2]
b. 18 Apr 1924 d. 27 Jun 1993
James William McCowan
b. 28 Feb 1927 d. 15 Nov 2004
12
Wendy Lou McCowan
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.1]
12
James Bruce McCowan
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.2]
12
Beverley Marie McCowan
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.3]
11
Bertha May Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.3]
b. 3 Sep 1925
Ross Bedore
b. 14 Jan 1927
12
Eleanor Audrey Bedore
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.3.1]
12
Douglas James Bedore
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.3.2]
11
Bernice Mabel Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.4]
b. 11 Sep 1927 d. 31 Oct 2015
Joseph William Ingles
b. 28 Aug 1929 d. 2003
12
Ronald Joseph Ingles
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.4.1]
12
Debra Lynn Ingles
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.4.2]
12
Kenneth William Ingles
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.4.3]
11
David Nelson Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.5]
b. 31 Dec 1929 d. 14 Sep 2008
Helen Grove
b. 28 Apr 1928
12
David Timothy Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.5.1]
12
Kimberley Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.5.2]
12
Michael James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.5.3]
12
Lori Louann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.5.4]
11
Roy Nelson Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.6]
b. 22 Nov 1931 d. 15 Jun 1932
11
Doris Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.7]
b. 22 Nov 1933 d. 17 Mar 2015
Lawrence Wilson
b. Apr 1924 d. 24 Mar 1961
12
Kelly James Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.7.1]
12
Jackie Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.7.2]
Alvin Young
12
Adele Young
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.6.7.3]
+
Thomas Melanson
b. 27 Aug 1911
10
James Orival Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7]
b. 15 Apr 1910 d. 22 Jun 1980
Sadie Lillian Sipprell
b. 20 Feb 1916 d. 3 Jul 1995
11
Hughbert Ross Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.1]
b. 5 Dec 1936 d. 5 Aug 1938
11
Robert Allen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.2]
Catherine Jean Cooke
b. 23 Dec 1940 d. 25 Nov 2022
12
David Allen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.2.1]
12
Leslie Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.2.2]
11
James Edward Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.3]
Mary Kerr
12
James David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.3.1]
b. 17 Oct 1963 d. 3 Oct 1987
12
Susan Elaine Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.3.2]
[
=>
]
+
Leta Carolyn Easto
Aileen Irene Steele
b. 1922 d. 19 Apr 2008
11
William George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.4]
b. 14 Feb 1946 d. 10 Jun 2011
Barbara June Piggott
b. 23 Feb 1929 d. 8 Oct 1991
11
Valerie Dawn Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.5]
b. 26 Mar 1957 d. 22 Sep 2004
+
Randall William McMullen
+
Simon Fraser MacDonald
11
Patricia Lynn Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.6]
+
Edward Joseph Bechberger
+
Drew Bryant Taylor
11
Kevin Bruce Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.7]
11
Tracy Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.8]
+
Brett Jonathan Hudson
+
Krestian Milo Hatashita
11
Colleen Dale Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.9]
11
Roberta (Bobbi) Heather Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.1.7.10]
+
Gary Gomm
9
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 30 Apr 1863 d. 14 Jul 1943
Robert Gordon Taylor
b. 8 Jun 1851 d. 18 Apr 1933
10
James Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.7.2.1]
b. 24 Jan 1884 d. 8 Nov 1967
Nellie Florence Elizabeth Cook
b. 30 Sep 1900
11
William James Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.7.2.1.1]
b. 6 Nov 1926
Mary
b. 25 Jul 1926
12
Robert William James Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.7.2.1.1.1]
10
Andrew John Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.7.2.2]
b. 17 Apr 1886 d. Apr 1962
+
Edna Annie Holmes
b. 12 Dec 1891 d. 1962
10
Gordon Neil Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.7.2.3]
b. 21 Sep 1897 d. 19 Nov 1918
9
Martha Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 7 Apr 1867 d. 11 Mar 1909
James Ogg
b. 31 Jul 1862 d. 21 Apr 1935
10
Mary Bella Ogg
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1]
b. 16 Nov 1884 d. 6 Feb 1968
John Henry Wesley Bond
b. 11 Aug 1872 d. 5 Jul 1948
11
Harvey James Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.1]
b. 20 Jul 1903 d. 7 Mar 1967
Margaret Irwin
b. 29 Nov 1908
12
John Harvey Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.1.1]
b. 13 Apr 1927
12
Irwin George Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.1.2]
b. 14 Apr 1927 [
=>
]
12
Russell Henry Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.1.3]
b. 15 Mar 1928 [
=>
]
11
Alexander Joseph Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.2]
b. 18 Sep 1904
Daisy Lowe
12
Stuart Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.2.1]
12
Leonard Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.2.2]
11
Gordon John Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.3]
b. 29 Sep 1906 d. Abt 1994
Grace Rose Williams
b. Abt 1910
12
Lloyd Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.3.1]
b. 11 Mar 1930
12
Doreen Mary Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.3.2]
b. 18 Mar 1931 [
=>
]
12
Gerald Gordon Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.3.3]
b. 26 Sep 1932 d. 22 Jun 1981 [
=>
]
12
Donald Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.3.4]
11
Martha Elizabeth Hazel Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.4]
b. 19 Aug 1910
Rev. Cecil Charles Percy Brown
b. 22 Apr 1904
12
William David Brown
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.4.1]
12
Gloria Darlene Brown
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.4.2]
11
Ivan George Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.5]
b. 15 Aug 1914
Ethel Berwick
b. 12 Jun 1917
12
Judith Mary Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.5.1]
12
Bruce Ivan Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.5.2]
12
Sandra Ethel Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.5.3]
11
Wallace Charles Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.6]
b. 31 Aug 1917 d. 3 Sep 1994
Rose Doneral
b. 22 Jun 1920 d. 21 Aug 2020
12
Shirley June Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.6.1]
12
Patsy Jean Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.6.2]
[
=>
]
12
Betty Pearl Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.6.3]
12
Sharon Mary Elizabeth Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.6.4]
12
Beverly Diana Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.6.5]
11
Jean Isabella Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.7]
b. 28 Sep 1919 d. 19 Sep 2010
Harold Doner
b. 25 Mar 1918 d. 11 Jan 2016
12
Shirley Jean Doner
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.7.1]
12
Fern Beverly Doner
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.7.2]
12
Kenneth Harold Doner
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.7.3]
12
Keith Robert Doner
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.7.4]
12
Nancy Marie Doner
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.7.5]
11
Pearl Mary Bond
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.8]
b. 7 Sep 1921
John O'Connell
12
Ronald John O'Connell
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.8.1]
12
Carol Pearl O'Connell
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.8.2]
12
Susan O'Connell
[1.1.1.1.1.1.1.7.3.1.8.3]
9
George McKergan Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4]
b. 10 Feb 1874 d. 22 Jul 1940
Ella May Raymer
b. 18 Jan 1891 d. 1973
10
Margarette Ruth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.1]
b. 28 Aug 1917 d. 25 Jun 2005
Clarence Alvin Smith
b. 1 Jul 1916
11
Susan Elizabeth Smith
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.1.1]
b. 13 May 1948 d. 28 May 1952
11
Margaret Smith
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.1.2]
10
James Walter Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2]
b. 7 Apr 1921 d. 2 Jan 1979
Mildred Ornetta Reesor
b. 5 Aug 1928
11
Sharon May Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.1]
b. 26 Apr 1948 d. 7 Dec 2008
+
Robert Bentley
11
David George Arthur Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.2]
Sarah Marie Brown
12
Darrell F. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.2.1]
12
Sarah C. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.2.2]
11
Walter Douglas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.3]
b. 10 Sep 1952 d. 16 Aug 1969
11
Margaret Rebekah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.4]
11
Robert Craig Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.5]
11
Gregory James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.6]
11
Paul Douglas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.7]
8
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 4 Jan 1831 d. 14 Feb 1899
James Walter Miller
b. 15 Sep 1830 d. 23 Nov 1918
9
Robert Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 11 Dec 1852 d. 23 Nov 1902
Margaret Gilbraith
b. 7 Aug 1858
10
Robert Jr. Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.1]
10
John Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2]
b. 23 Dec 1883
Ms. Maylo
11
Elmer Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1]
12
Larry Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.1.1]
11
Kieth Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.2.2]
10
Wellington Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.3]
b. 3 Jan 1886 d. 29 Sep 1950
Ada
b. Jul 1885
11
Verna Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.3.1]
11
Jean Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.3.2]
10
James Gilbraith Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.1.4]
b. 9 Nov 1878
9
Isabella Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 15 Jun 1857 d. 3 Jun 1936
Robert Nimmo
b. 29 Jan 1852 d. 21 Aug 1927
10
Ellen Thomson Nimmo
[1.1.1.1.1.1.1.8.2.1]
b. 21 May 1878 d. 26 May 1939
George Albert Mitchell
b. 2 Aug 1875 d. 11 Jun 1944
11
G A Nimmo Mitchell
[1.1.1.1.1.1.1.8.2.1.1]
b. 9 Apr 1900 d. 17 Jul 1967
10
William J. Nimmo
[1.1.1.1.1.1.1.8.2.2]
b. 14 May 1880 d. 11 Jan 1907
10
Marion Elizabeth Nimmo
[1.1.1.1.1.1.1.8.2.3]
b. 12 Oct 1883 d. 4 Apr 1963
+
William George Patton
b. Abt 1884 d. 3 Mar 1960
10
Janet Victoria Nimmo
[1.1.1.1.1.1.1.8.2.4]
b. 31 Jul 1891 d. 21 Mar 1950
9
Elizabeth Jane Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.3]
b. 18 Aug 1859 d. 3 Feb 1893
Robert W. Thomson
b. 7 Jun 1843 d. 13 Mar 1916
10
James Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.8.3.1]
b. 6 Nov 1889 d. 25 Nov 1926
10
Elizabeth Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.8.3.2]
b. 20 Jan 1893 d. 7 Mar 1933
10
Ellen Gertrude Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.8.3.3]
b. 8 Jul 1891
+
Charles Smith
9
Janet T. Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 2 May 1862 d. 30 Nov 1930
William Alex Latham
b. 29 Feb 1852
10
Mabel Latham
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.1]
b. Jan 1902
10
G Kingsford Latham
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.2]
b. 30 Jun 1896
10
Allan James Latham
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.3]
b. 27 Oct 1898 d. 7 Jan 1933
Mildred Irene Bertram
11
Mary Latham
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.3.1]
+
Mildred Irene Ruse
11
William Latham
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.3.2]
10
William Robert Latham
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.4]
b. Jun 1905
Mabel Stokes
11
Barbara Latham
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.4.1]
11
Roger Latham
[1.1.1.1.1.1.1.8.4.4.2]
9
James Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.5]
b. 31 Mar 1864 d. 1888
9
David Andrew Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.6]
b. 24 Apr 1870 d. 26 May 1882
9
John Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.7]
b. 17 Aug 1872 d. 1 Sep 1883
9
Mary Ida Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.8]
b. 23 Mar 1866 d. 29 Jul 1900
Robert Gallander
b. 1866 d. 31 May 1938
10
John Edward Gallander
[1.1.1.1.1.1.1.8.8.1]
b. 12 Sep 1896 d. 6 Jun 1969
9
William Robert Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9]
b. 15 Feb 1869 d. 17 Aug 1937
Margaret Smith
b. 13 Oct 1872 d. 21 Apr 1938
10
James Arthur Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.1]
b. 7 Apr 1897 d. 30 Apr 1981
Marjorie Harriet Keeler
b. 10 Jul 1911
11
William Donald Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.1.1]
11
Marion Elsie Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.1.2]
11
Ruth Isabell Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.1.3]
10
Margaret Winnifred Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.2]
b. 19 Aug 1898
Henry Vincent Everest
b. 2 Jan 1899 d. May 1964
11
John William Everest
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.2.1]
b. 18 Apr 1928
10
William Alfred Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.3]
b. 5 Aug 1901
Olive Tibbles
b. 17 Feb 1902
11
James Winston Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.3.1]
b. 13 May
Rosemary Vivian Horton
12
James Joseph Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.3.1.1]
11
Velma Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.3.2]
b. 23 Feb
+
Dr. Donald Otis
11
Rena Marie Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.3.3]
b. 26 Nov
+
Paul William Mingay
11
Robert William Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.3.4]
b. 9 Feb
10
Ellen Irene (Nellie) Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.4]
b. 25 Apr 1904
Leslie Tibbles
b. 13 Nov
11
Edward A. Tibbles
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.4.1]
b. 30 Sep 1928
11
Bruce Miller Tibbles
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.4.2]
b. 14 Dec 1931
10
George Robert Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5]
b. 11 Mar 1907 d. 11 Nov 1965
Margaret Bernetta Empringham
b. 21 Sep 1907 d. 12 Feb 1980
11
Eileen Margaret Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.1]
Thomas George Rowlands
12
Carl Miller Rowlands
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.1.1]
[
=>
]
12
Scott Thomas Rowlands
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.1.2]
12
Jayne Margaret Rowlands
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.1.3]
11
Shirley May Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.2]
James Sheldon Miller
12
Lori Ann Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.2.1]
12
James Lynn Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.2.2]
12
Steven Robert Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.2.3]
11
Nelda Karen Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.3]
11
Joyce Elenore Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.4]
Peter Russell Fuller
12
Meredith Leigh Fuller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.4.1]
12
Meaghan Elizabeth Fuller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.4.2]
12
Erin Ashley Fuller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.4.3]
11
Helen Muriel Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.5]
James Edward Marshall
12
Darren James Marshall
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.5.1]
12
Kevin George Marshall
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.5.2]
12
Brent Andrew Marshall
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.5.3]
12
Karen Lindsay Marshall
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.5.5.4]
10
John Walter Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.6]
b. 23 Aug 1910
Elsie Keeler
b. 14 Feb 1918
11
John Murray Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.6.1]
11
Walter Ernest Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.6.2]
11
Margaret Ann Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.6.3]
11
Elsie Jean Miller
[1.1.1.1.1.1.1.8.9.6.4]
7
Andrew D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 23 Nov 1790 d. 27 Jul 1854
Clarissa (Clarcy) Stevens
b. Feb 1799 d. 28 Jan 1888
8
Susanah Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 9 Aug 1829 d. 20 Mar 1898
Charles Sanderson
b. 16 Jan 1819 d. 16 Jul 1884
9
Isabella Jane Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 17 Nov 1865 d. 9 Mar 1936
James Andrew Thomson
b. 29 Jan 1865 d. 2 Apr 1924
10
Medford Ryerson Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 14 Dec 1894 d. 2 Jul 1918
10
George Aviner Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 13 Jan 1897 d. 1 Jan 1961
Edythe Roston Monet
b. 14 Feb 1899 d. 4 Dec 1970
11
Calvin Dean Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 1 Mar 1928 d. 2 Mar 1928
11
Jack Beverly Eugene Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.2]
b. 27 Mar 1931
Carol Chase
b. 27 Feb 1933
12
Scott Eugene Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.1]
12
Carolynn Marie Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.2]
12
Paul Douglas Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.2.2.3]
10
Ethel Muriel Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 18 Sep 1898 d. 28 May 1972
+
Hughbert Winston MacPherson
b. 28 Aug 1900 d. 19 Apr 1973
10
Ross Sanderson Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.4]
b. 27 May 1901 d. 23 Dec 1923
10
Mary Edna Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5]
b. 2 Jan 1904 d. 10 Feb 1988
Nelson James Thomson
b. 9 Nov 1895 d. 21 Sep 1950
11
Ethel Marie Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.1]
b. 10 Feb 1923 d. 1998
+
Edmund Trudeau
b. 11 Jun 1926
11
Myrel Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.2]
b. 18 Apr 1924 d. 27 Jun 1993
James William McCowan
b. 28 Feb 1927 d. 15 Nov 2004
12
Wendy Lou McCowan
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.2.1]
12
James Bruce McCowan
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.2.2]
12
Beverley Marie McCowan
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.2.3]
11
Bertha May Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.3]
b. 3 Sep 1925
Ross Bedore
b. 14 Jan 1927
12
Eleanor Audrey Bedore
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.3.1]
12
Douglas James Bedore
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.3.2]
11
Bernice Mabel Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.4]
b. 11 Sep 1927 d. 31 Oct 2015
Joseph William Ingles
b. 28 Aug 1929 d. 2003
12
Ronald Joseph Ingles
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.4.1]
12
Debra Lynn Ingles
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.4.2]
12
Kenneth William Ingles
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.4.3]
11
David Nelson Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.5]
b. 31 Dec 1929 d. 14 Sep 2008
Helen Grove
b. 28 Apr 1928
12
David Timothy Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.5.1]
12
Kimberley Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.5.2]
12
Michael James Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.5.3]
12
Lori Louann Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.5.4]
11
Roy Nelson Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.6]
b. 22 Nov 1931 d. 15 Jun 1932
11
Doris Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.7]
b. 22 Nov 1933 d. 17 Mar 2015
Lawrence Wilson
b. Apr 1924 d. 24 Mar 1961
12
Kelly James Wilson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.7.1]
12
Jackie Wilson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.7.2]
Alvin Young
12
Adele Young
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.5.7.3]
+
Thomas Melanson
b. 27 Aug 1911
10
James Orival Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6]
b. 15 Apr 1910 d. 22 Jun 1980
Sadie Lillian Sipprell
b. 20 Feb 1916 d. 3 Jul 1995
11
Hughbert Ross Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.1]
b. 5 Dec 1936 d. 5 Aug 1938
11
Robert Allen Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.2]
Catherine Jean Cooke
b. 23 Dec 1940 d. 25 Nov 2022
12
David Allen Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.2.1]
12
Leslie Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.2.2]
11
James Edward Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.3]
Mary Kerr
12
James David Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.3.1]
b. 17 Oct 1963 d. 3 Oct 1987
12
Susan Elaine Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.3.2]
[
=>
]
+
Leta Carolyn Easto
Aileen Irene Steele
b. 1922 d. 19 Apr 2008
11
William George Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.4]
b. 14 Feb 1946 d. 10 Jun 2011
Barbara June Piggott
b. 23 Feb 1929 d. 8 Oct 1991
11
Valerie Dawn Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.5]
b. 26 Mar 1957 d. 22 Sep 2004
+
Randall William McMullen
+
Simon Fraser MacDonald
11
Patricia Lynn Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.6]
+
Edward Joseph Bechberger
+
Drew Bryant Taylor
11
Kevin Bruce Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.7]
11
Tracy Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.8]
+
Brett Jonathan Hudson
+
Krestian Milo Hatashita
11
Colleen Dale Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.9]
11
Roberta (Bobbi) Heather Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.1.1.6.10]
+
Gary Gomm
9
Hannah Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 13 Jun 1853 d. 30 Aug 1926
James Edward Herron
b. 22 Oct 1850 d. 2 Jul 1935
10
Ethel Elma Herron
[1.1.1.1.1.1.2.1.2.1]
b. 5 Mar 1881 d. 3 Nov 1956
John Andrew McKitrick
b. 2 Sep 1880 d. 14 Sep 1958
11
Alvena Mae McKitrick
[1.1.1.1.1.1.2.1.2.1.1]
b. 27 Oct 1919 d. 13 Mar 1920
9
John Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 6 Aug 1856 d. 22 Jun 1925
Louisa Emily Scrivens
b. 22 Jun 1860 d. 22 Mar 1937
10
Mary Hannah Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1]
b. 24 Apr 1880 d. 9 May 1913
James Johnathan Burgess
b. 10 Jun 1879 d. 21 Jan 1945
11
Laura May Burgess
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.1]
b. 21 Nov 1898 d. 18 Sep 1985
Alfred John Taylor
b. 31 May 1897 d. 21 Oct 1982
12
Donald Albert Taylor
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.1.1]
b. 26 Apr 1923 [
=>
]
12
Norman Alfred Taylor
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.1.2]
b. 25 Mar 1925 d. Jun 2001 [
=>
]
12
John Stewart Taylor
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.1.3]
b. 17 May 1927 [
=>
]
12
Melville Graham Taylor
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.1.4]
b. 10 Nov 1928 [
=>
]
12
Marilyn Louise Taylor
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.1.5]
b. 2 Sep 1931 d. 14 May 2006 [
=>
]
12
David George Taylor
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.1.6]
11
Melville James Burgess
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.2]
b. 15 Jun 1901 d. 2 Feb 1952
Nettie Luella Trivett
b. 28 Nov 1909 d. 5 Jan 1991
12
Marjorie Jeanne Burgess
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.2.1]
b. 8 Mar 1930 [
=>
]
12
Betty Evelyn Joan Burgess
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.2.2]
b. 21 Jun 1931 [
=>
]
12
Carole Ann Burgess
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.2.3]
[
=>
]
11
Alberta Mildred Burgess
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.3]
b. 19 Nov 1903 d. 22 Jan 2000
Percy Kindree
d. 1950
12
Melville Bryce Kindree
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.3.1]
b. 2 Nov 1922 [
=>
]
12
Russel Craig Kindree
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.1.3.2]
b. 7 May 1924 d. 1998 [
=>
]
+
Ernest B. Fraser
d. May 1973
10
Charles Daniel Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.2]
b. 28 Apr 1883 d. 5 May 1947
Emma Amelia Morris
b. 1 Sep 1881 d. 8 Apr 1958
11
Audrey Louise Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1]
b. 26 Nov 1914
Charles Clifford Galster
b. 15 Dec 1914
12
Janis Audrey Galster
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.1]
12
Margaret Ardean Galster
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.1.2]
11
Morris Charles Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2]
b. 26 Dec 1919
Helen Wineck
12
Alexander Charles Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.2.2.1]
10
Clarissa Ann Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.3]
b. 16 Sep 1885
John Chesser Armstrong
b. 12 Mar 1884 d. 19 Dec 1960
11
Margaret McLean Armstrong
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.3.1]
b. 28 Aug 1910 d. 13 Apr 1967
James Douglas Harnett
b. 9 Aug 1911 d. Abt 1963
12
John Murray Harnett
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.3.1.1]
12
Beverley Ann Harnett
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.3.1.2]
11
Helen Louisa Armstrong
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.3.2]
b. 18 Apr 1912 d. 24 Apr 1921
10
Laura Mabel Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.3.4]
b. 19 Jun 1888 d. 20 Jul 1952
+
James Alexander Blackburn
b. 8 Nov 1886 d. 3 Feb 1963
9
Seneca Charles Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 11 Sep 1859 d. 18 Sep 1865
9
Clarissa Ann Sanderson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 21 Oct 1863 d. 6 Dec 1948
Louis Robertson
b. 18 Sep 1872 d. 14 Sep 1951
10
Henry Belcher Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1]
b. 3 Sep 1902 d. 29 Apr 1952
Pansy Ione Franklin
b. 31 Aug 1906 d. 15 Sep 1977
11
Dorothy Agnes Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.1]
b. 14 Feb 1929 d. 5 Aug 1988
William Chalmers
b. 26 Oct 1928 d. 26 Oct 1982
12
Dorothy Chalmers
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.1.1]
12
Steven William Chalmers
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.1.2]
12
Terry Harold Chalmers
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.1.3]
12
Darrell Fredrick Chalmers
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.1.4]
11
John Donald Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.2]
b. 4 Sep 1931
Phylis Elizabeth Staples
12
Paul Donald Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.2.1]
b. 3 Aug 1950 d. 29 Dec 1988
12
Harry George Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.2.2]
[
=>
]
12
Dale Russell Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.2.3]
12
Denise Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.2.4]
[
=>
]
11
David Ross Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.3]
b. 23 Dec 1932 d. 12 Dec 2003
Rose Marie Desjardins
b. 26 Dec 1933
12
Karen Louise Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.3.1]
[
=>
]
12
Michael David Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.3.2]
12
Darcy Phillip Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.3.3]
12
Charlene Rose Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.3.4]
[
=>
]
12
Joanne Marie Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.3.5]
[
=>
]
11
Marilyn Clarissa Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.4]
Munden Seward Butt
12
Laurie Marion Butt
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.4.1]
[
=>
]
12
Tamara Pansy Butt
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.4.2]
[
=>
]
12
Sandra Lynn Butt
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.4.3]
[
=>
]
12
Jennifer Marilyn Butt
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.4.4]
[
=>
]
12
Kyle Munden Butt
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.1.4.5]
10
Louis Alvin Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.2]
b. 19 Dec 1904 d. 20 Feb 1949
Margaret Emily White
b. 1 Mar 1911 d. 17 Mar 1998
11
Roy Carson Alvin Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.2.1]
b. 4 Nov 1931
+
Cecil Marie Lecuyer
+
Nancy Jo Yacullo
+
Camilla Marie Bernardi
11
Ruth Carol Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.2.2]
b. 10 Mar 1933 d. 5 May 1962
Fred Ledger
12
Stephanie Ruth Ledger
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.2.2.1]
[
=>
]
Frank Ledger
12
Bradley J. Ledger
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.2.2.2]
[
=>
]
11
Bruce Anthony Robertson
[1.1.1.1.1.1.2.1.5.2.3]
8
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 25 Sep 1820 d. 20 Oct 1897
Richard Sylvester
b. 1819 d. 22 Jul 1876
9
Clarissa Adelaide Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 4 Jun 1842 d. 15 Jul 1921
Samuel Cherry
b. Abt 1839 d. 4 Mar 1927
10
Isabella Harriet Cherry
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.1]
b. 11 Aug 1872 d. 1953
10
Clarissa Anne Cherry
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2]
b. 8 Oct 1877 d. 15 May 1952
Robert Nicol
b. Abt 1879
11
Clara Nicol
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2.1]
11
Belle Nicol
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.2.2]
10
Caroline Delphine Cherry
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3]
b. 1 Aug 1868 d. 1913
John Close
b. 26 Jan 1863 d. 27 Apr 1910
11
John Hamilton Close
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.1]
b. 4 Jul 1896 d. Jul 1993
Olive Brown Parkinson
b. 27 Sep 1897 d. 27 May 1939
12
Margaret Jane Close
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.1.1]
b. Private [
=>
]
12
Kathleen Olive Close
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.1.2]
b. Private [
=>
]
12
Lorraine Caroline Close
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.1.3]
b. Private [
=>
]
12
Jean Anne Close
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.1.4]
b. Private [
=>
]
+
Grace Ratcliffe
11
Charles Samuel Close
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.2]
b. 9 Jan 1899 d. 8 Jan 1970
Mary Eleanor Turner
b. 14 Dec 1906 d. 25 Mar 1989
12
Charles Wilfred Close
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.3.2.1]
b. Private [
=>
]
10
Olive Jane Cherry
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.4]
b. 1 Jan 1874 d. 28 Mar 1905
Peter Close
b. 17 May 1870 d. 8 Jul 1945
11
Olive Winnifred Close
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.4.1]
b. Jun 1902 d. 11 Apr 1981
+
Jeffrey C. Heaslip
11
Arthur W. Close
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.4.2]
b. 24 Jan 1899 d. 17 Jan 1979
+
Stella Bailey
10
William Hamilton Cherry
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5]
b. 18 May 1883 d. 15 May 1952
Ethel Walker
b. Nov 1882
11
Gladys Maud Cherry
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.1]
b. 22 Nov 1907
11
Gordon Leslie Cherry
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.5.2]
10
Irena Cherry
[1.1.1.1.1.1.2.2.1.6]
b. 1885 d. 1892
9
Elizabeth Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.2]
b. 18 Jul 1843 d. 24 Jul 1854
9
Charles Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 6 Dec 1844 d. 7 May 1917
Elizabeth Armstrong
b. 7 Aug 1847 d. 14 Feb 1934
10
Charles Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.1]
b. 1872
10
Adelaide Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.2]
b. 1875
+
Walter James Scott
b. Abt 1879
10
Richard Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.3]
b. 19 Jul 1877
Maud Eleanor Weir
b. Feb 1870 d. 1948
11
Isabel Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.3.1]
b. 27 May 1911
+
Stuart Louis Ravelle
b. 1911
10
Florence Louise Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.4]
b. 29 Jul 1892
+
John Melville McKay
b. Abt 1894
10
Isabella J. Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.3.5]
b. 1 Apr 1883
9
Mary Isabella Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 29 Jan 1847
Duncan Andrew Fitzpatrick
b. 1838
10
Mary Isabella Fitzpatrick
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.1]
b. 12 Jul 1870
10
Adelaide Fitzpatrick
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.2]
b. 2 May 1872
10
Richard Duncan Fitzpatrick
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.3]
b. 4 Oct 1873
10
William Andrew Fitzpatrick
[1.1.1.1.1.1.2.2.4.4]
b. 1874
9
Boyd Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 29 Jan 1849 d. 21 Nov 1885
+
Mary A. Lackey
b. Abt 1856
9
Hannah Delphina Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.6]
b. 1 Jul 1850 d. 28 Jan 1883
Abraham Cornell
b. 22 Oct 1845
10
Harriette Violet Cornell
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.1]
b. 10 Mar 1879
10
Mary Ada Cornell
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.2]
b. 5 Oct 1875
10
Boyd Cornell
[1.1.1.1.1.1.2.2.6.3]
b. 1877
9
Experience Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.7]
b. 23 Dec 1851 d. 10 Oct 1859
9
Richard Thomson Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.8]
b. 3 May 1854 d. Aft 1881
Alice Cecilia House
b. 18 Jun 1860 d. 11 Jan 1938
10
Edith Violet Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.8.1]
b. 8 Jul 1879
9
Andrew Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.9]
b. 10 Aug 1857 d. 1934
Ann Truan
b. 12 Oct 1861 d. 7 Feb 1902
10
Boyd Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.1]
b. 1881
Ellen Maria King
b. Sep 1877
10
Edith Violet Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.2]
b. 18 Jul 1904
10
Adaliade Ellen Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.3]
b. 6 Jun 1907
10
Andrew Richard Boyd Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.4]
b. 20 Jul 1909
10
Frank Henry Reuben Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.5]
b. 1 May 1913 d. 1989
Ms. Kidd
11
Frank Daniel Andrew Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.2.9.5.1]
8
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 7 Aug 1821 d. 19 Nov 1894
James Seneca Palmer
b. 11 May 1821 d. 1881/1891
9
Mary Ann Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 9 Jan 1855 d. 15 Jun 1934
John Vanhorne
b. 1851 d. 12 Jan 1916
10
Armanda Christine Vanhorne
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.1]
b. 10 Dec 1873 d. 3 Nov 1954
Theodore Charles Upper
b. 19 Sep 1863
11
Walter Earl Upper
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.1]
b. 26 Feb 1897 d. 13 Feb 1969
11
Charles Arthur Upper
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.2]
b. 31 Jul 1891
11
John Stanley Upper
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.1.3]
b. 28 Feb 1894 d. 1 May 1894
10
John Arthur Vanhorne
[1.1.1.1.1.1.2.3.1.2]
b. Sep 1886 d. 10 Nov 1890
9
Ida H. Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.2]
b. 23 Mar 1860 d. 18 Oct 1924
John James O'Sullivan
b. 11 Oct 1850 d. 22 Aug 1929
10
Daniel Alexius O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.1]
b. 22 Jul 1881 d. 12 May 1969
10
William James O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2]
b. 6 Sep 1882 d. 7 Dec 1938
Margaret E. McAndress
b. 30 Oct 1890 d. 16 May 1955
11
Joseph William O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.1]
b. 4 Nov 1911 d. 23 Jun 1975
Thelma Ruth Walstad
b. 16 Jun 1920 d. 11 May 1999
12
Ruth Josephine O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.1.1]
[
=>
]
12
Jeanette Marie O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.1.2]
[
=>
]
12
William Joseph O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.1.3]
[
=>
]
12
James Lawrence O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.1.4]
[
=>
]
11
James MacKenzie O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.2]
b. 12 May 1913 d. 15 Aug 1919
11
Margaret Genevieve O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.3]
b. 31 Jul 1914 d. 19 Jul 1999
Edward Stanley Misialek
b. 28 Jul 1909 d. 8 Oct 1973
12
Mary Margaret Misialek
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.3.1]
b. 11 Jul 1933 d. 11 Jul 1933
12
Margaret Joan Misialek
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.3.2]
[
=>
]
12
Mary Ellen Misialek
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.3.3]
[
=>
]
12
Katharine Frances Misialek
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.3.4]
[
=>
]
12
Patricia Genevieve Misialek
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.3.5]
[
=>
]
12
James Edward Misialek
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.3.6]
[
=>
]
+
John David Rockwell
b. 23 Aug 1913 d. 15 Jan 1972
+
Floyd C. Miller
b. 1 May 1894 d. 23 Dec 1984
+
Erling Robert Lee
11
John Richard O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.4]
b. 5 Jul 1916 d. 7 Jun 1928
11
Ida Elizabeth O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.5]
b. 21 Feb 1918 d. 18 Aug 2009
Emery Alvin Dailey
b. 12 Dec 1920 d. 5 Feb 2002
12
James Emery Dailey
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.5.1]
11
Charles Michael O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6]
Annie Evelyn Stabo
12
Daniel John O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6.1]
[
=>
]
12
Evelyn Maureen O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6.2]
[
=>
]
12
Jennifer Jean O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6.3]
12
Marie Louise O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6.4]
12
William Charles O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6.5]
[
=>
]
12
Colleen Ann O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6.6]
12
Susan Margaret O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6.7]
[
=>
]
12
Lori Dawn O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6.8]
[
=>
]
12
Carrie Jo O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.6.9]
11
Louis Palmer O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.7]
b. 17 Jul 1922 d. 21 Aug 1985
Theresa Margaret Kelly
b. 13 Mar 1918 d. 14 Nov 1977
12
Patricia Ann O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.7.1]
+
Maria Josefina Figueroa
11
Ann Bernice O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.8]
b. 3 May 1924 d. 26 Aug 2008
11
Helene Louise O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.9]
b. 6 Feb 1926 d. 15 Feb 2013
Laurence Alton Ramsey
b. 6 Aug 1920 d. 30 Jan 2011
12
Laurence Thomas Ramsey
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.9.1]
12
Michael Lewis Ramsey
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.9.2]
12
Bruce Lowell Ramsey
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.9.3]
[
=>
]
12
Douglas Lee Ramsey
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.9.4]
12
Edward William Ramsey
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.9.5]
[
=>
]
12
Kathleen Ann Ramsey
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.9.6]
[
=>
]
12
Theresa Patricia Ramsey
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.9.7]
12
Mary Jo Bernadette Ramsey
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.9.8]
[
=>
]
11
Mary Katharine O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.10]
b. 27 Mar 1928 d. 21 Feb 1999
Johann Sigurd Isfeld
b. 6 May 1919 d. 22 Sep 2010
12
Anna Katharine Isfeld
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.10.1]
[
=>
]
11
Theresa Claire O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.11]
b. 29 Jan 1931 d. 28 Oct 2006
Samuel John Eagleson
12
Marguerite June Eagleson
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.2.11.1]
[
=>
]
10
Helen Amelia O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3]
b. 6 Feb 1884 d. 31 Mar 1979
Charles Patrick McGarry
b. 10 Nov 1881 d. 2 Jun 1952
11
John Leo McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.1]
b. 6 Jun 1910 d. 22 Sep 1950
Rachel Louise Johnston
b. 31 Dec 1916 d. 27 Jan 2004
12
Thomas Anthony McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.1.1]
[
=>
]
12
Ann Louise McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.1.2]
[
=>
]
12
John Louis McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.1.3]
[
=>
]
11
Mildred C. McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.2]
b. 11 Aug 1913 d. 18 Aug 1988
Frank C Sutton
b. 3 Aug 1894 d. 15 Apr 1966
12
Ruth Ann Sutton
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.2.1]
[
=>
]
12
Mary Margaret Sutton
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.2.2]
[
=>
]
12
Helen Elizabeth Sutton
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.2.3]
[
=>
]
12
Lorraine Carolyn Sutton
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.2.4]
[
=>
]
12
Jean Marie Sutton
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.2.5]
12
Frank C Sutton
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.2.6]
[
=>
]
12
Harry Allen Sutton
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.2.7]
11
Margaret M. McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.3]
b. 18 Sep 1912 d. 18 Jan 1916
11
Helen Isabelle McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.4]
b. 15 Jan 1914 d. 22 Oct 1993
11
Ida McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.5]
b. 7 Aug 1915 d. Feb 1994
George L Reichert
b. 21 Feb 1916 d. 29 Dec 1992
12
Helen Isabelle Reichert
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.5.1]
[
=>
]
12
Catherine ann Reichert
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.5.2]
[
=>
]
11
Charles Francis McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.6]
b. 18 May 1920 d. 14 Apr 1986
Ellen Mary Barr
b. 25 Jul 1921 d. 6 Dec 1995
12
William Charles McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.6.1]
12
Daniel Joseph McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.6.2]
b. 31 Oct 1949 d. 22 May 1979
11
Jennie Ann McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7]
b. 18 May 1920 d. 29 Jan 1996
Julian Joseph McShane
b. 18 Aug 1919 d. 22 Mar 1992
12
Paul A McShane
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7.1]
[
=>
]
12
Marie T McShane
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7.2]
[
=>
]
12
Mark J McShane
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7.3]
12
Christopher J McShane
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7.4]
[
=>
]
12
Joseph edward McShane
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7.5]
[
=>
]
12
Jeanne M McShane
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7.6]
12
Michael J McShane
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7.7]
12
Edward Joseph McShane
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7.8]
[
=>
]
12
Therese Anne McShane
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.7.9]
[
=>
]
11
Geraldine McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8]
b. 21 Sep 1921 d. 10 Nov 1999
Herbert Edward Niederberger
b. 9 Sep 1919 d. 13 Nov 1989
12
Philip Anthony Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.1]
12
Caroline Amelia Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.2]
[
=>
]
12
Michael Alaysius Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.3]
12
Daniel Edward Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.4]
[
=>
]
12
Frances Annette Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.5]
12
Charles Anthony Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.6]
12
Mary Amelia Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.7]
[
=>
]
12
Helen Ernestine Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.8]
12
Herbert Edward Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.9]
[
=>
]
12
Joseph christopher Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.10]
[
=>
]
12
Peter Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.11]
b. 20 Jan 1964 d. 20 Jan 1964
12
Therese Marie Niederberger
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.8.12]
[
=>
]
11
Philip McGarry
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.3.9]
b. 10 Mar 1924 d. 11 Nov 1944
10
Jennie Anne O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.4]
b. 29 Sep 1887 d. 9 Jan 1922
10
Francis John O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.5]
b. 16 Feb 1890 d. 29 Nov 1945
10
Margaret Mary O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6]
b. 20 Nov 1897 d. 1 Oct 1979
Archie Brennan O'Connor
b. 10 Aug 1896 d. 12 Jan 1963
11
Gerald Lewis O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.1]
Ellen Jane Ebert
12
Mark O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.1.1]
12
Maria O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.1.2]
12
Meghan O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.1.3]
11
Archie Robert O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.2]
b. 24 Nov 1921 d. 18 Feb 1967
Barbara Jean Morrison
d. 16 Nov 1959
12
Eileen O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.2.1]
12
Rory O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.2.2]
12
John O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.2.3]
[
=>
]
12
Kevin O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.2.4]
12
Kathleen O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.2.5]
12
Dennis O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.2.6]
+
Mary Ann Bakvica
11
John Palmer O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.3]
b. 19 Mar 1923 d. 12 Oct 1997
Hazel Jean Grandy
12
Patricia O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.3.1]
12
Michael O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.3.2]
11
Margaret Ann O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.4]
b. 4 Aug 1924 d. 25 Jan 2003
Robert William McLean
b. 17 Feb 1924 d. 2 Jun 1997
12
William Ernest McLean
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.4.1]
[
=>
]
12
Robert Lee McLean
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.4.2]
[
=>
]
12
Patrick David McLean
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.4.3]
12
Andrew John McLean
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.4.4]
[
=>
]
12
Margaret Lois McLean
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.4.5]
[
=>
]
12
Eileen Ann McLean
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.4.6]
[
=>
]
11
Agnes Joan O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.5]
b. 25 Jan 1926 d. 26 Jan 2008
Marvin Bronken
b. 6 Jul 1922 d. 1 Mar 2008
12
Barbara Colleen Bronken
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.5.1]
[
=>
]
12
Beth Elise Bronken
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.5.2]
[
=>
]
12
Holly Bronken
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.5.3]
12
James Bronken
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.5.4]
[
=>
]
12
Margaret Mary Bronken
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.5.5]
[
=>
]
12
Richard Bronken
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.5.6]
12
Peter Bronken
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.5.7]
11
James Daniel O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.6]
b. 6 Jul 1927 d. 19 Sep 1930
11
Thomas Francis O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.7]
b. 10 Feb 1929 d. 25 Aug 1968
Ola Mae Anderson
12
Deborah O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.7.1]
11
Edward Neil O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.8]
b. 6 Oct 1930 d. 10 Jan 1979
Beverly Jean Preusse
12
Kimberly Ann O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.8.1]
[
=>
]
12
Colleen mary O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.8.2]
[
=>
]
12
Thomas Kelly O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.8.3]
[
=>
]
12
Keller Jean O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.8.4]
[
=>
]
12
Christopher James O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.8.5]
11
Richard Brennan O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.9]
b. 24 Jun 1934 d. 13 Aug 1960
11
Mary Jane O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.10]
b. 24 Jun 1934 d. 2009
George Bresnahan
d. Bef 1 Sep 2009
12
George Bresnahan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.10.1]
12
Amy Bresnahan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.10.2]
12
Patricia Bresnahan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.10.3]
12
Brennan Bresnahan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.10.4]
12
Ned Bresnahan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.10.5]
12
Mary Bresnahan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.10.6]
12
John Bresnahan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.10.7]
11
Patricia Helen O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.11]
Patrick William Fisher
12
Catherine Patricia Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.11.1]
12
Karen Jane Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.11.2]
12
Heidi Margaret Fisher
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.11.3]
11
Daniel Clarence O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.12]
Patricia Fay Harvey
12
Daniel Brennan O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.12.1]
12
Kathleen Mary O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.12.2]
12
Jennifer Ellen O'Connor
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.6.12.3]
10
Bernice Isabel O'Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7]
b. 10 Mar 1903 d. 4 Sep 1972
Cleophis John O'Keefe
b. 2 Apr 1902 d. 13 Jan 1969
11
Muriel Bernice O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.1]
b. 24 May 1926 d. 13 Apr 2018
Herman Dennis Nelson
b. 24 Sep 1926 d. 29 Jan 1986
12
Paul Dennis Nelson
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.1.1]
[
=>
]
12
Carol Ann Nelson
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.1.2]
12
Mark Stephen Nelson
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.1.3]
[
=>
]
12
William Charles Nelson
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.1.4]
[
=>
]
12
Muriel Denise Nelson
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.1.5]
[
=>
]
12
Jill Michele Nelson
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.1.6]
12
John Michael Nelson
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.1.7]
12
Herman Dennis Nelson
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.1.8]
11
John Daniel O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.2]
Gloria Jean Becker
12
John Michael O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.2.1]
[
=>
]
12
Daniel Paul O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.2.2]
[
=>
]
12
Robert Charles O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.2.3]
[
=>
]
12
Catherine Ann O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.2.4]
[
=>
]
12
James William O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.2.5]
[
=>
]
11
William Joseph O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.3]
b. 7 Oct 1928 d. 20 Oct 1995
Ellen Margret Reynolds
12
Michael John O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.3.1]
[
=>
]
12
James Patrick O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.3.2]
12
Kathleen Margaret O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.3.3]
12
Brian William O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.3.4]
[
=>
]
12
Terry Joseph O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.3.5]
11
Cathrine Cleona O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.4]
b. 26 Sep 1930 d. 3 Jul 1998
Francis Joseph Luibel
b. 4 Aug 1928 d. 23 Sep 2005
12
Ann Marie Luibel
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.4.1]
[
=>
]
12
George Joseph Luibel
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.4.2]
[
=>
]
12
Paul Louis Luibel
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.4.3]
12
Catherine Bernice Luibel
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.4.4]
12
Thomas Jerome Luibel
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.4.5]
12
Helen Rita Luibel
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.4.6]
11
Charles Dennis O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.5]
b. 18 Sep 1932 d. 6 Feb 2000
11
Helen Lorraine O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.6]
+
T Jerome Miller
11
Claire Janet O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.7]
James Albert Lipp
12
Michael James Lipp
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.7.1]
12
Steven Patrick Lipp
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.7.2]
12
Mary Frances Lipp
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.7.3]
12
Marcia Ann Lipp
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.7.4]
11
Francis Paul O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.8]
Carol Ann Hunter
12
Timothy Paul O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.8.1]
[
=>
]
12
Thomas Lloyd O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.8.2]
[
=>
]
12
Patrick Ray O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.8.3]
12
Jane Ann O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.8.4]
11
Ida Madrienne O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.9]
Robert Schuler
12
Robert Anthony Schuler
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.9.1]
12
William Joseph Schuler
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.9.2]
11
C Michael O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.10]
11
Mary Eleanor O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.11]
+
Daniel Clarence O'hearn
11
Ruth Ann O'Keefe
[1.1.1.1.1.1.2.3.2.7.12]
+
Terry Ratzlaff
9
Jennie Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 23 Mar 1850
9
Etta Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 23 Mar 1860 d. 8 Aug 1925
James Philcox
b. 16 Jun 1852 d. 8 Oct 1915
10
Ida Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1]
b. 27 Aug 1877 d. 27 Apr 1956
Alfred John Booth
b. 18 Dec 1875 d. 24 Jun 1953
11
Irene Ida Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1]
b. 3 Feb 1901 d. 8 Jun 1968
Basil Michael Sullivan
b. 11 Dec 1899 d. 27 Jun 1983
12
Eleanor Dorothy Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1.1]
b. 1 Jun 1920 [
=>
]
12
John Lawrence Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1.2]
b. 29 Apr 1922 d. 8 Nov 1994 [
=>
]
12
Lucille Marie Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1.3]
b. 22 Dec 1923 [
=>
]
12
Arthur James Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1.4]
b. 15 Oct 1925 d. 2 Nov 1987 [
=>
]
12
Lorraine Kathleen Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1.5]
b. 6 Jan 1931 [
=>
]
12
Marilyn Adele Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1.6]
b. 28 Jun 1933 [
=>
]
12
Kenneth Basil Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1.7]
[
=>
]
12
Harvey Marshall Sullivan
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1.8]
[
=>
]
11
Arthur Alvin Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2]
b. 28 Jun 1904 d. 1971
Mona Aileen Worsdall
b. 6 May 1905 d. 1995
12
Shirley Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2.1]
b. 1925 [
=>
]
12
Yvonne Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2.2]
b. 1927 [
=>
]
12
Ernest Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2.3]
b. 1928 [
=>
]
12
Fay Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2.4]
b. 1931 [
=>
]
12
Arthur Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2.5]
[
=>
]
12
Marlene Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2.6]
[
=>
]
11
Alfred John Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.3]
b. 7 Jun 1910 d. 29 Jun 1980
Audrey Jean Arnold
b. 3 Jul 1910 d. 29 Jun 1984
12
Alfred John Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.3.1]
[
=>
]
12
Gary Douglas Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.3.2]
11
Gordon Booth
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.4]
b. 4 Feb 1912 d. Oct 1982
+
Bessie Leonora Thelma Allison
b. 25 Sep 1911 d. 15 May 1998
10
John Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.2]
10
Mary Jane (Minnie) Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.3]
b. 29 Dec 1880 d. 1973
+
William John Vaisey
b. 1875 d. 1953
10
James Warren Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.4]
b. 1 Aug 1883 d. 1958
+
Margaret Magdalen Grady
b. Jul 1881 d. 1969
10
Margaret Annie Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.5]
b. 5 May 1888 d. 9 Mar 1973
Arthur Lee Gill
b. 23 Sep 1886 d. 3 Jun 1962
11
Helen L. Gill
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.5.1]
b. 30 Apr 1916 d. 8 Sep 1994
+
Edward Lewis
b. 1916 d. 1946
+
Lloyd Moore
10
Helen Amanda (Nell) Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.6]
b. 14 Sep 1890 d. 16 Oct 1964
William John Philpot
b. 6 Jun 1888 d. 11 Feb 1972
11
Mildred Philpot
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.6.1]
b. 16 May 1914 d. 1 Jan 1992
William S Thompson
b. 22 Jul 1916
12
Lynda Thompson
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.6.1.1]
[
=>
]
11
June M. Philpot
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.6.2]
b. 8 Jun 1918
+
Vernon W. Griffin
b. 15 Jan 1911 d. 29 Sep 1992
10
Arthur Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.7]
b. 20 Feb 1886
10
Edna M. Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.8]
b. 30 Mar 1893 d. 1960
+
Percy J Norris
b. 1892 d. 1976
10
Myrtle Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.9]
10
Reta E. Philcox
[1.1.1.1.1.1.2.3.4.10]
b. 27 Aug 1900 d. 3 Jun 1989
+
Richard R. David
b. 1 Sep 1900 d. 8 Nov 1982
9
Seneca Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5]
b. 2 Apr 1851
Hannah Maria Richardson
b. Feb 1861 d. 18 Feb 1927
10
Richard Arthur Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.1]
b. 4 Mar 1881 d. 4 Dec 1965
Catherine Serena Brown
b. Oct 1881
11
Laura Leana Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.1.1]
b. 27 May 1902 d. 14 Jun 1990
11
Etta May Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.1.2]
b. 24 Feb 1904
+
Stanley Smith
10
Frank Birch Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.2]
b. 31 Aug 1883
10
Ida Jane Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.3]
b. 21 Mar 1885 d. 3 Mar 1919
Walter Oswald Parker
b. 15 Jan 1886 d. 8 Oct 1943
11
Elsie Aileen Parker
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.3.1]
b. 17 Mar 1908
11
Francis Lloyd Parker
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.3.2]
11
James Walter Parker
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.3.3]
11
George Seneca Parker
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.3.4]
b. 4 Sep 1914 d. 17 Jan 1925
11
Harry Edgar Parker
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.3.5]
b. 17 Oct 1916 d. 8 Apr 2005
+
Olive Vera Nesbitt
b. 2 Feb 1922 d. 9 Jun 1986
11
Douglas C. Parker
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.3.6]
b. 1918 d. 2010
+
Elsie L.
b. 1914 d. 1998
10
Mark Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.4]
b. 1888
10
James Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.5]
b. 22 Mar 1892
10
Vera Lizette Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.6]
b. 29 Aug 1895
10
Clara Agnes Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.7]
b. 19 Aug 1900 d. 25 Mar 1986
Charles Grimaldi
b. 17 Dec 1887 d. 6 Jun 1961
11
Vera McKay Grimaldi
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.7.1]
b. 20 Nov 1920 d. 28 Nov 2014
+
Earl William Gokey
b. 18 Sep 1918 d. 25 Jan 1993
11
Charles Garnet Grimaldi
[1.1.1.1.1.1.2.3.5.7.2]
b. 22 Sep 1932 d. 20 Jul 1994
9
James Thomson Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.6]
b. 20 Apr 1862
Emma Taylor
b. 18 Jan 1868
10
Viola Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.6.1]
b. 6 Mar 1895
9
William Palmer
[1.1.1.1.1.1.2.3.7]
b. 25 Mar 1846 d. 16 Sep 1854
8
William Andrew David Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 21 Jan 1823 d. 16 Feb 1902
Elizabeth Douglas
b. 14 Dec 1836 d. 9 Jan 1917
9
Sarah J. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.4.1]
b. 15 May 1858
9
Adelaide Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.4.2]
b. 1860 d. Oct 1881
9
Sarah Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.4.3]
b. 29 Jun 1868 d. 26 Nov 1924
Thomas McKenney
b. 30 Jun 1871 d. 1 Mar 1950
10
Eugenie McKenney
[1.1.1.1.1.1.2.4.3.1]
b. May 1904
9
Janet E. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.4.4]
b. 18 Jun 1873 d. 17 Feb 1949
+
Thomas McKenney
b. 30 Jun 1871 d. 1 Mar 1950
9
Clarissa Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.4.5]
b. 27 Oct 1875 d. 28 Oct 1938
George Henry Wixon
b. 26 Dec 1876 d. 10 Oct 1952
10
William George Wixon
[1.1.1.1.1.1.2.4.5.1]
b. 24 Oct 1896 d. 13 Apr 1955
Hazel Victoria Page
b. 1900 d. 13 Feb 1969
11
Elwood Wixon
[1.1.1.1.1.1.2.4.5.1.1]
11
Marilyn Wixon
[1.1.1.1.1.1.2.4.5.1.2]
+
Allen E. Hughes
10
Hazel Wixon
[1.1.1.1.1.1.2.4.5.2]
b. 7 Oct 1900
10
Gladys Wixon
[1.1.1.1.1.1.2.4.5.3]
10
Grace Wixon
[1.1.1.1.1.1.2.4.5.4]
George Cresswell
11
Arlene Cresswell
[1.1.1.1.1.1.2.4.5.4.1]
9
Agnes Bella Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.4.6]
b. 18 Aug 1877 d. 23 Mar 1958
Hubert Edward Taylor
b. 16 Feb 1877 d. 11 May 1957
10
Florella Mabel Taylor
[1.1.1.1.1.1.2.4.6.1]
b. 8 Nov 1900 d. 25 Jul 2006
Ernest Topping
d. Abt 1987
11
Robert Ernest Topping
[1.1.1.1.1.1.2.4.6.1.1]
b. 1929
11
William George Topping
[1.1.1.1.1.1.2.4.6.1.2]
b. 1930
10
Lloyd Roseborough Taylor
[1.1.1.1.1.1.2.4.6.2]
10
Audrey Muriel Taylor
[1.1.1.1.1.1.2.4.6.3]
b. 18 Sep 1903 d. Abt 1988
Harold William Whately
d. 22 Mar 1992
11
Audrey Muriel Whately
[1.1.1.1.1.1.2.4.6.3.1]
11
Muriel Jane Whately
[1.1.1.1.1.1.2.4.6.3.2]
9
Edith Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.4.7]
b. 2 May 1880 d. 26 Jun 1956
Phillip D. Trudelle
b. 2 Dec 1879 d. 19 Oct 1945
10
Manus William Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.1]
b. 31 Jan 1903
Lois Milner
11
Bernice Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.1.1]
10
Marjory Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.2]
b. 25 Oct 1905 d. 19 Aug 1931
10
Harley Rudolph Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.3]
b. 5 Sep 1907
Lorraine
11
Phillip Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.3.1]
10
Francis Malvurn Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.4]
b. 18 Nov 1909 d. 28 Apr 1910
10
Wilbur Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.5]
b. 22 Jun 1911
Clara Atlas
11
Aletha Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.5.1]
10
Elva Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.6]
b. 15 Feb 1915
W.G. Edwards
11
Marjorie Edwards
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.6.1]
11
Buddy Edwards
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.6.2]
10
Earl Trudelle
[1.1.1.1.1.1.2.4.7.7]
b. 26 May 1919
9
Susannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.4.8]
b. 8 Mar 1865 d. 23 Jun 1878
8
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 1826 d. 8 Jun 1879
Robert Heron
b. 1819 d. 1854
9
David Heron
[1.1.1.1.1.1.2.5.1]
b. 1846 d. 1846
9
Andrew Heron
[1.1.1.1.1.1.2.5.2]
b. 1848 d. 1848
9
Caroline Heron
[1.1.1.1.1.1.2.5.3]
b. 4 Dec 1851 d. 14 Feb 1913
Robert Myers
b. 10 Feb 1843 d. 7 Apr 1920
10
Janet May (jennie) Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.1]
b. 24 Mar 1878 d. 1 Jan 1967
10
Margaret (Maggie) Edith Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.2]
b. 7 Oct 1879 d. 29 Dec 1923
+
Robert Martin
b. 1884
10
Adelaide Ellen (Nellie) Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.3]
b. 18 Sep 1882 d. 22 Jun 1965
10
Elgin Robert Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.4]
b. 12 Jun 1886 d. 6 Sep 1966
Ethel Marguerite Nash
b. 1898
11
Margaret Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.4.1]
+
James Walters
10
Leonard Alvin Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.5]
b. 19 Aug 1888 d. 2 Apr 1955
10
Walter Reynold Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.6]
b. 17 Sep 1891
Norma Mabelle Cox
b. 14 Jul 1890 d. 1 Sep 1928
11
Edgar Walter Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.6.1]
b. 5 Aug 1919 d. 21 Jan 1921
11
Donald Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.6.2]
b. 11 Apr 1922
Elva Thatcher
12
John Gordon Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.6.2.1]
12
Lynda Joan Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.6.2.2]
Mabel Henry
11
Joan Patricia Myers
[1.1.1.1.1.1.2.5.3.6.3]
b. 18 Mar 1932
+
Clifford Worthy Lawrence
9
Hannah Heron
[1.1.1.1.1.1.2.5.4]
b. 16 Jan 1855 d. 19 Feb 1910
George Henry Long
b. Nov 1846 d. 6 Nov 1891
10
Janet Edith (Nettie) Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1]
b. 2 Jan 1876 d. 25 Apr 1943
Silas Arthur Hill
b. 15 Apr 1870 d. 4 Jul 1902
11
Hildred Lillian Jean Hill
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.1]
b. 27 May 1898 d. 27 Apr 1984
William Gordon Shuter
b. 18 Jan 1899 d. 16 Dec 1955
12
Russell Gordon Shuter
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.1.1]
b. 8 Apr 1926 d. 26 Feb 1967 [
=>
]
12
Gladys Irene Shuter
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.1.2]
b. 10 Nov 1927 [
=>
]
11
Gladys (Minnie) Wilhemine Hill
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.2]
b. 8 Dec 1899
+
Harold Victor Rowe
b. 5 Jul 1896 d. 29 Sep 1925
11
Sidney Arthur Hill
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.1.3]
b. 25 Jun 1901
10
William James Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2]
b. 7 Feb 1877 d. 29 May 1923
Lydia Louise Langstaff
b. 1881
11
Pricilla Louise Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.1]
b. 6 Sep 1906
11
Jean Hannah Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.2]
b. 21 Jul 1908
11
George William Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.3]
b. Abt 1910
11
Paul Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.4]
b. Abt 1918
11
James Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.5]
b. 1921
11
Reginald Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.2.6]
b. 1921
10
Minnie Hannah Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.3]
b. 12 Feb 1879
Fred Denby
b. 16 Dec 1877 d. 22 May 1951
11
Mildred Denby
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.3.1]
b. 15 Jul 1904
Horace Hudson Marlett
b. Jan 1902
12
Donald Frederick Marlett
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.3.1.1]
11
Della Denby
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.3.2]
b. 27 Oct 1906
+
John Owen Pennington
b. 28 Jul 1923
10
Richard Henry Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.4]
b. 4 Feb 1880
Edith May Mason
b. 17 Jul 1886
11
Olive Adelaide Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.4.1]
b. 15 Nov 1909 d. 6 Mar 1920
11
Dalton Alfred Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.4.2]
b. Abt 1911
11
Irene Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.4.3]
b. Abt 1918
10
Elgin Robert Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.5]
b. 21 Dec 1881
10
Sydney Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.6]
b. 9 Mar 1883 d. 27 Mar 1960
Ruby
b. Abt 1896
11
Gordon Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.6.1]
11
Norma Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.6.2]
10
Harriet Ellen (Nellie) Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.7]
b. 24 Nov 1884 d. 13 Aug 1960
James Herbert Forward
b. Abt 1884
11
James Cecil Herbert Forward
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.7.1]
b. Abt 1917
10
Cecil Herbert Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.8]
b. 28 Jun 1886 d. 28 Jun 1965
Estella Beatrice Mason
b. Abt 1893 d. 19 Jul 1954
11
Marjorie Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.8.1]
+
N E Dawbar
11
Mason Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.8.2]
11
Helen Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.8.3]
+
John C. Young
11
Bessie Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.8.4]
+
Joseph W. Button
10
Bessie Long
[1.1.1.1.1.1.2.5.4.9]
b. 28 Apr 1890 d. 20 Dec 1964
Robert Sisley
b. Abt 1832 d. Circa Apr 11 1866
9
Janet Adelaide Sisley
[1.1.1.1.1.1.2.5.5]
b. 13 Jan 1859 d. 4 May 1949
8
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 1824 d. 8 Jun 1896
8
Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 7 Dec 1827 d. 20 Oct 1908
William Sylvester
b. 20 Mar 1822 d. 22 Oct 1860
9
Richard Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 18 Aug 1847 d. 23 May 1911
Mary Kirk
b. 8 May 1851 d. 8 Mar 1931
10
William Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1]
b. 27 Jul 1873 d. 17 Sep 1957
Mairies Bella Ferguson
b. 20 Aug 1873 d. 14 Jul 1962
11
Maribel Wilma Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.1]
b. 24 Oct 1906 d. 6 Sep 1983
Allan Berg
b. 6 Apr 1898 d. 12 Jun 1974
12
Richard Allan Berg
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.1.1]
[
=>
]
12
William Warren Berg
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.1.2]
b. 16 Feb 1939 d. 28 Feb 1964
11
Marjorie May Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.2]
b. 13 Jan 1904 d. 7 Oct 1986
Carl George Ash
b. 26 May 1903 d. 18 Oct 1967
12
Dean Cederholm Ash
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.2.1]
b. 21 Jul 1937 d. Feb 1992 [
=>
]
12
Wayne Robert Ash
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.2.2]
[
=>
]
12
Lynn Arthur Ash
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.2.3]
11
Arthur Richard Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.3]
b. 15 May 1909 d. Apr 1984
Ester Vanderburgh
b. 28 Jun 1915 d. Jun 1984
12
Pamela Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.3.1]
12
Robert Anthony Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.3.2]
11
Warren Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.4]
b. 4 Mar 1911 d. 22 Feb 1996
Dorothy Dafedt
b. 10 Aug 1913 d. 26 Dec 1992
12
Bette Jo Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.4.1]
12
David Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.1.4.2]
10
Anne Isabella Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.2]
b. 4 Aug 1875 d. 24 Apr 1947
Ole Monson
b. 19 Jan 1872 d. 10 Apr 1948
11
Mary Rena Monson
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.2.1]
b. 3 Jan 1909 d. 21 Jul 1988
11
Annie L Monson
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.2.2]
b. 29 Sep 1902 d. 9 Dec 1989
11
Martin H Monson
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.2.3]
b. Abt 1900
10
Mary Hannah Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3]
b. 23 Apr 1878 d. 11 Feb 1953
Sanford Artinners Balderson
b. 9 Jun 1872 d. 5 Nov 1909
11
Milden Roy Balderson
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.1]
b. 21 Sep 1903 d. 5 Sep 1904
11
Harris Lloyd Balderson
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.2]
b. 21 Apr 1906 d. 28 Feb 1908
11
Della Mary Marilda Balderson
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.3]
b. 11 Feb 1909 d. 24 Sep 1997
Rev. J.H. (Jack) Grothaus
b. 2 Nov 1904
12
Jerry Delton Grothaus
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.3.1]
[
=>
]
Ernest Garfield Gill
b. 2 Jun 1886 d. 6 Jul 1937
11
LaRene Ernestine Gill
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.4]
b. 23 Jul 1915 d. 15 Mar 2007
Glendon T. Winter
b. 26 Jul 1915 d. 27 Apr 1978
12
Robert Allan Winter
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.4.1]
b. 16 Aug 1934 d. 7 Dec 1985 [
=>
]
12
Marilyn Voneta Winter
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.4.2]
[
=>
]
12
Betty Lou Winter
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.4.3]
[
=>
]
11
Eldon Ernest Gill
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.3.5]
b. 23 Jul 1915 d. 4 Jan 1985
10
Andrew Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.4]
b. 15 Sep 1881 d. 24 Apr 1958
10
Lena Helen Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.5]
b. 23 Aug 1886 d. 17 Jun 1963
+
Gould Robert Sugden
b. 1882 d. 23 Sep 1949
10
Leonard Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6]
b. 23 Aug 1886 d. 25 Apr 1973
Bertha May Gill
b. 12 Jun 1888 d. 10 May 1915
11
Kalvin Gill Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6.1]
b. 14 Nov 1914 d. 25 Sep 2001
Anne L. Walters
b. 4 Nov 1921
12
Terrance Kirk Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6.1.1]
[
=>
]
Laura Ethel Hare
b. 3 May 1901 d. 23 Apr 1996
11
Madrienne Fay Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6.2]
b. 1 Aug 1924 d. 12 Jan 2008
Rodney Mochrele
12
Shawn Mochrele
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6.2.1]
+
Robert Johnson
+
Andrew Theisen
11
Hazel Clarie Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6.3]
b. 26 Aug 1926 d. 6 Apr 2010
LaVern Schultz
b. 16 May 1923 d. Sep 1985
12
LaVerne Schultz
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6.3.1]
[
=>
]
12
Keith Schultz
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6.3.2]
b. 1 Mar 1949 d. Nov 1983 [
=>
]
12
Kent Schultz
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6.3.3]
b. 13 Mar 1957 d. 10 Sep 1997 [
=>
]
12
Brian Schultz
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.6.3.4]
10
George Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7]
b. 29 Oct 1889 d. 30 Apr 1973
Helen Olsonoski
b. 3 Aug 1903 d. 27 Nov 2000
11
Marlene Mary Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.1]
b. 13 Mar 1933
James R, Peterson
d. Bef 27 Nov 2000
12
Gabrielle Yvette Peterson
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.1.1]
[
=>
]
12
Ripley James Peterson
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.1.2]
[
=>
]
11
Lois Ann Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.2]
Baen Roger Davis
12
Rikki Davis
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.2.1]
[
=>
]
12
Ronda Davis
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.2.2]
[
=>
]
12
Richard Davis
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.2.3]
11
Jeanette Yvonne Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.3]
Rodney Lysfjord
12
Gina Marie Lysfjord
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.3.1]
[
=>
]
12
Debra Yvonne Lysfjord
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.3.2]
11
Richard Stanley Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.4]
Andrea Norby
12
Alexandra Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.4.1]
12
Cortney G. Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.7.4.2]
10
Richard Thomas Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8]
b. 1 Mar 1880 d. 4 Mar 1968
Hannah Ellen Thomson
b. 21 Dec 1889 d. 9 Oct 1962
11
Willard Earl Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8.1]
b. 18 Feb 1908 d. 28 Oct 1976
+
Mary Lena Blonden
b. 8 Jan 1912 d. 26 Sep 1989
11
Edwin George Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8.2]
b. 3 Jan 1909 d. 24 Mar 1994
Ida Dorothy Ash
b. 16 Feb 1915 d. 9 May 1968
12
Francis Jean Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8.2.1]
12
Richard James Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8.2.2]
12
Jeffery Thomas Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8.2.3]
11
James Lowell Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8.3]
b. 5 Feb 1914 d. 9 May 1968
Avis Delores Huffstutler
b. 4 Mar 1919
12
Peggy Laurene Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8.3.1]
12
Richard Thomas Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8.3.2]
12
Georgia Elaine Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.1.8.3.3]
9
Clarissa Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 14 Jun 1855 d. 16 Jul 1924
Robert G. Herron
b. 5 Feb 1855 d. 3 Jan 1913
10
Hannah Marilda Herron
[1.1.1.1.1.1.2.7.2.1]
b. 23 Sep 1881 d. 28 May 1886
10
Nellie Lydia Heron
[1.1.1.1.1.1.2.7.2.2]
+
Chester Hatherley
10
Robert Walter Heron
[1.1.1.1.1.1.2.7.2.3]
b. 25 Nov 1887 d. 11 Jan 1965
Irma Elveria Weiderstrand
b. 20 Sep 1900 d. 21 Oct 1946
11
Cheleste Evelyn Heron
[1.1.1.1.1.1.2.7.2.3.1]
b. 10 Jul 1921 d. 11 Apr 2000
James Lowell Shields
b. 2 Sep 1914 d. 7 May 2004
12
Lorvel James Shields
[1.1.1.1.1.1.2.7.2.3.1.1]
b. 27 Sep 1941 d. 15 Dec 2021
10
John Heron
[1.1.1.1.1.1.2.7.2.4]
+
Ellen Weiderstand
10
William Heron
[1.1.1.1.1.1.2.7.2.5]
10
Celesta Herron
[1.1.1.1.1.1.2.7.2.6]
+
Lowell Shield
9
Andrew Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 15 Sep 1850
9
William Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.4]
b. 19 Aug 1857
9
Hannah Ellen Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5]
b. 6 Jul 1861 d. 6 Jan 1890
James Andrew Thomson
b. 29 Jan 1865 d. 2 Apr 1924
10
Hannah Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1]
b. 21 Dec 1889 d. 9 Oct 1962
Richard Thomas Sylvester
b. 1 Mar 1880 d. 4 Mar 1968
11
Willard Earl Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1.1]
b. 18 Feb 1908 d. 28 Oct 1976
+
Mary Lena Blonden
b. 8 Jan 1912 d. 26 Sep 1989
11
Edwin George Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1.2]
b. 3 Jan 1909 d. 24 Mar 1994
Ida Dorothy Ash
b. 16 Feb 1915 d. 9 May 1968
12
Francis Jean Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1.2.1]
12
Richard James Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1.2.2]
12
Jeffery Thomas Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1.2.3]
11
James Lowell Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1.3]
b. 5 Feb 1914 d. 9 May 1968
Avis Delores Huffstutler
b. 4 Mar 1919
12
Peggy Laurene Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1.3.1]
12
Richard Thomas Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1.3.2]
12
Georgia Elaine Sylvester
[1.1.1.1.1.1.2.7.5.1.3.3]
8
Seneca George Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 5 Aug 1839 d. 18 Oct 1904
Mary Harriet Fitzpatrick
b. 8 May 1845 d. 3 Jul 1908
9
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 1863 d. 1930
Martha Maxwell
b. 1873 d. 1949
10
Cora A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.1.1]
b. Nov 1895
10
David W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.1.2]
b. Sep 1897
10
Elsie M. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.1.3]
b. 1901
Dexter
11
Donald Dexter
[1.1.1.1.1.1.2.8.1.3.1]
d. Aug 1958
10
George S Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.1.4]
b. 1903
10
Charles M Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.1.5]
b. 1905 d. 1943
9
Mary Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.2]
b. 1871 d. 1895
Edward John Finney
b. 1865 d. 1952
10
Verna Maud Finney
[1.1.1.1.1.1.2.8.2.1]
b. 17 Sep 1892 d. 26 Apr 1893
10
Olive May Finney
[1.1.1.1.1.1.2.8.2.2]
b. 12 Jul 1894 d. 22 Nov 1894
9
Seneca George Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.3]
b. Oct 1874 d. Aft 2 Jan 1920
Elizabeth Cole
b. Nov 1881 d. Aft 2 Jan 1920
10
Lily Laura Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.3.1]
b. Sep 1899
10
Verna M. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.3.2]
b. 1903
10
Charles Harold Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.3.3]
b. 1904
10
Hubert Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.3.4]
b. 1906
9
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.4]
b. May 1866 d. 1945
Hanson Maxwell
b. Feb 1865 d. 1943
10
William J. Elmer Maxwell
[1.1.1.1.1.1.2.8.4.1]
b. Jun 1893
10
Roy Maxwell
[1.1.1.1.1.1.2.8.4.2]
b. 1902 d. 1944
10
May Maxwell
[1.1.1.1.1.1.2.8.4.3]
b. 1909
9
Olive Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.5]
b. Jun 1877 d. 1948
George Finney
b. Jan 1874 d. 1941
10
Dwight Finney
[1.1.1.1.1.1.2.8.5.1]
Jean
11
Darlene Finney
[1.1.1.1.1.1.2.8.5.1.1]
11
Judy Finney
[1.1.1.1.1.1.2.8.5.1.2]
11
Shirley Ann Finney
[1.1.1.1.1.1.2.8.5.1.3]
b. 1947 d. 1952
9
Valtina Maud Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.6]
b. Aug 1879 d. Jul 1946
Emery Finney
b. Dec 1877
10
Olive Irene Finney
[1.1.1.1.1.1.2.8.6.1]
b. 1904 d. 1954
+
Howard Cox
10
Mary Finney
[1.1.1.1.1.1.2.8.6.2]
+
Harry Miller
10
John Finney
[1.1.1.1.1.1.2.8.6.3]
b. 19 Feb 1910 d. 2 Dec 1946
9
Clara C. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.7]
b. Sep 1882
Ernest William Woodruff
b. Abt 1873
10
Edward Woodruff
[1.1.1.1.1.1.2.8.7.1]
b. Abt 1922
10
Iva Woodruff
[1.1.1.1.1.1.2.8.7.2]
b. Abt 1915
9
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.8.8]
b. 15 Dec 1869 d. 5 May 1870
8
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.9]
b. 24 Mar 1833 d. 25 Mar 1915
John Barzillis Mosher
b. 1821 d. 23 Jun 1893
9
Clarissa Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.1]
b. 19 Sep 1850 d. 19 Sep 1924
+
Robert Stephenson
b. 1 Jan 1847 d. 12 May 1897
9
Gertrude Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.2]
b. 1853
Solomon Walker
10
Harold Walker
[1.1.1.1.1.1.2.9.2.1]
9
William Thomson Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3]
b. 1854 d. 11 Feb 1929
Elizabeth Cox
b. Abt 1865 d. Jan 1924
10
David George Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.1]
b. 14 Feb 1889
Gertrude Annabelle Booth
b. Abt 1894
11
Dorothy Ann Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.1.1]
10
Clara B. Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.2]
b. 6 Apr 1884 d. 28 Jul 1950
+
Ivison E. Tucker
b. 1887
10
Gertrude Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.3]
b. 6 Feb 1891
William Schnell
11
Wilmot Schnell
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.3.1]
11
Beatrice Schnell
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.3.2]
10
Lavina Albertha Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.4]
b. 6 Aug 1894 d. 12 Jun 1952
William McIntosh
b. Abt 1889
11
Margaret McIntosh
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.4.1]
11
Carson McIntosh
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.4.2]
11
Sonny McIntosh
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.4.3]
10
Norman Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.5]
b. 7 Jul 1896
10
Archibald Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.6]
b. 25 Jan 1898
Lila Lawson
d. 8 Sep 1965
11
Mary Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.6.1]
11
Russell Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.6.2]
11
Orval Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.6.3]
10
Isabella Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.7]
b. 5 Feb 1893 d. 23 Apr 1938
Charles Laing
11
Norman Laing
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.7.1]
10
Elizabeth Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.3.8]
b. 21 Nov 1900
9
Reuben Andrew Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.4]
b. 15 Jul 1856 d. 12 Jul 1935
+
Sarah Ada Greenbury
b. 2 Nov 1869 d. 25 Sep 1923
9
David George Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.5]
b. 3 Aug 1864 d. 1944
Lucy Ann Sprout
b. 28 Oct 1867 d. 1937
10
Ernest Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.5.1]
b. 20 Apr 1890 d. 1947
+
Violet Luke
10
Mansell Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.5.2]
d. 8 Feb 1970
Myrtle Barnes
11
Harvey Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.5.2.1]
9
Seneca Richard Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6]
b. 22 Jul 1862 d. 7 May 1950
Emile Stotts
b. 9 Apr 1869 d. 27 Jun 1935
10
Hattie Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1]
b. 18 Jan 1889
William Butler
b. 6 May 1878 d. 14 Jan 1914
11
George Butler
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.1]
Mona Skelton
b. 1911 d. 27 May 1959
12
Beverley Butler
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.1.1]
[
=>
]
12
Bonnie Butler
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.1.2]
11
Violet Butler
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.2]
Donald Francis King
12
Barbara France King
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.2.1]
12
Beverley Janet King
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.2.2]
12
Patti Jeanne King
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.2.3]
John Ash
11
Ann Ash
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.3]
Joseph Charles Everest
d. 5 Dec 1968
12
Joan Everest
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.3.1]
12
Diana Everest
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.3.2]
11
Kathleen Ash
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.4]
Oliver McClure
12
James McClure
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.4.1]
12
Linsa Olive McClure
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.4.2]
[
=>
]
12
Bert McClure
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.4.3]
11
Rose Ash
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.5]
+
Jacob Chapman
11
Patre Ash
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.6]
Herbert Marginson
12
Linda Olive Marginson
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.6.1]
12
Penny Marginson
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.6.2]
12
Patty Ann Marginson
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.6.3]
11
Florence Ash
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.7]
Edward Wendland
12
Barbara Wendland
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.7.1]
12
Edwaed Wendland
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.7.2]
11
Frank Ash
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.8]
Betty Lynn
12
Frank Ash
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.8.1]
11
Mary Ash
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.9]
Russell Allen
12
Jerry Allen
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.9.1]
12
Mary Leslie Allen
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.9.2]
11
Ambrose Ash
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.1.10]
10
Clara Bella Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.2]
b. 18 Jan 1889
Walter Foster Toyne
b. 1883 d. 10 Dec 1964
11
Frank Toyne
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.2.1]
Ellen Willis
12
Frances Toyne
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.2.1.1]
12
Frank Toyne
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.2.1.2]
12
Diana Toyne
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.2.1.3]
11
Lillian Toyne
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.2.2]
Louis Tanner
12
Gary Tanner
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.2.2.1]
12
Gail Tanner
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.2.2.2]
10
Arthur Raymond Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.3]
b. 10 Oct 1892 d. 4 May 1958
Marie Smith
d. 7 Sep 1945
11
Lloyd Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.3.1]
Norma Lovell
12
Lynda Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.3.1.1]
12
Susan Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.3.1.2]
10
Amelia Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.4]
10
Clifford R. Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.5]
b. 4 Dec 1897
Winnie Ethel MacKay
b. 27 Jan 1900 d. Oct 1966
11
Margaret Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.5.1]
b. 8 Jun 1925
William Edwards-Jones
12
Clifford Edwards-Jones
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.5.1.1]
12
Michael Edwards-Jones
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.5.1.2]
11
Vera Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.5.2]
b. 1931
+
Douglas Smille
11
Donald Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.5.3]
+
Gwendolyn Bullock
10
Mary Eva Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.6]
b. 25 Jul 1899 d. 16 Jan 1965
Harvey C. Coathup
b. 24 Jul 1897
11
George Richard Coathup
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.6.1]
b. 14 Sep 1920 d. 16 Jun 1944
+
Betty Burgoyne
11
Clifford Harvey Coathup
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.6.2]
b. 17 May 1922 d. 18 Apr 1944
11
Marion Florette Coathup
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.6.3]
b. 18 May 1926
+
Clarence Darwin Green
10
William Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.6.7]
b. 18 Aug 1901
+
Lena Roehl
9
Estella May Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.7]
b. 14 Aug 1871 d. 30 Sep 1960
John H. Lennox
b. 21 Jun 1861 d. 7 Dec 1931
10
John Roy Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.1]
b. 21 May 1894 d. 9 Jun 1965
Jean Mildred Baxter Robertson
b. 4 Mar 1893 d. 1 May 1921
11
Marion Jean Robertson Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.1.1]
b. 28 Apr 1921
Sarah Elizabeth Nelson
b. 14 Aug 1893 d. 6 Feb 1966
11
Sadie Josephine Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.1.2]
b. 22 Jul 1923
Percy S. Dimmock
12
Joan Elizabeth Dimmock
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.1.2.1]
12
John Stuart Dimmock
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.1.2.2]
12
Jean Marie Dimmock
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.1.2.3]
12
Judith Ann Dimmock
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.1.2.4]
12
James Robert Dimmock
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.1.2.5]
10
Gordon Chase Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.2]
b. 17 Apr 1896 d. 17 Apr 1965
Mabel May Hall
b. 20 Nov 1901 d. 10 Nov 1959
11
Muriel Fern Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.2.1]
b. 8 Sep 1928
+
Elmer Harding
10
Hazel Gertrude Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.3]
b. 2 May 1898
Oscar John Hall
b. 20 Sep 1892
11
Lorna Jean Hall
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.3.1]
b. 1 Oct 1922
+
Howard Webb
b. 11 Aug 1915
11
William Gordon Hall
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.3.2]
b. 13 Feb 1927
+
Joan Beverley Lee
b. 14 Nov 1930
11
Kenneth John Hall
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.3.3]
b. 1 Nov 1928
11
Davis Dennis Hall
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.3.4]
10
Josephine May Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.4]
b. 18 Apr 1903
George Arthur Brooks
b. 21 Nov 1902
11
Donald George Brooks
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.4.1]
b. 2 Aug 1925
+
Pearl Evelyn Humphrey
b. 29 Mar 1927
11
William John Brooks
[1.1.1.1.1.1.2.9.7.4.2]
b. 20 Jan 1929
+
Betty Mildred Knisley
b. 14 Nov 1930
9
Agirta Mosher
[1.1.1.1.1.1.2.9.8]
b. 1867
8
Richard A.D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10]
b. 1835 d. 28 Mar 1877
Elizabeth Glendinning
b. 22 Jan 1835 d. 24 Sep 1893
9
Andrew Alexander Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1]
b. 9 Jul 1859 d. 26 Feb 1928
Elizabeth Ann Catherwood
b. 2 Aug 1861 d. 1 Jul 1923
10
John Edward Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.1]
b. 21 Nov 1887 d. 24 Sep 1950
10
Sylvester A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.2]
b. 10 Apr 1891 d. 20 Jan 1946
10
Russel Francis Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.3]
b. 27 Oct 1893
+
Beatrice Arnold Middleton
b. 1893
10
Nelson James Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4]
b. 9 Nov 1895 d. 21 Sep 1950
Mary Edna Thomson
b. 2 Jan 1904 d. 10 Feb 1988
11
Ethel Marie Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.1]
b. 10 Feb 1923 d. 1998
+
Edmund Trudeau
b. 11 Jun 1926
11
Myrel Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.2]
b. 18 Apr 1924 d. 27 Jun 1993
James William McCowan
b. 28 Feb 1927 d. 15 Nov 2004
12
Wendy Lou McCowan
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.2.1]
12
James Bruce McCowan
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.2.2]
12
Beverley Marie McCowan
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.2.3]
11
Bertha May Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.3]
b. 3 Sep 1925
Ross Bedore
b. 14 Jan 1927
12
Eleanor Audrey Bedore
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.3.1]
12
Douglas James Bedore
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.3.2]
11
Bernice Mabel Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.4]
b. 11 Sep 1927 d. 31 Oct 2015
Joseph William Ingles
b. 28 Aug 1929 d. 2003
12
Ronald Joseph Ingles
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.4.1]
12
Debra Lynn Ingles
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.4.2]
12
Kenneth William Ingles
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.4.3]
11
David Nelson Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.5]
b. 31 Dec 1929 d. 14 Sep 2008
Helen Grove
b. 28 Apr 1928
12
David Timothy Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.5.1]
12
Kimberley Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.5.2]
12
Michael James Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.5.3]
12
Lori Louann Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.5.4]
11
Roy Nelson Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.6]
b. 22 Nov 1931 d. 15 Jun 1932
11
Doris Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.7]
b. 22 Nov 1933 d. 17 Mar 2015
Lawrence Wilson
b. Apr 1924 d. 24 Mar 1961
12
Kelly James Wilson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.7.1]
12
Jackie Wilson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.7.2]
Alvin Young
12
Adele Young
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.4.7.3]
10
Elizabeth Myrel Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.5]
b. 29 Oct 1900 d. 21 Dec 1982
Richard Roy Shadlock
11
Dorothy Shadlock
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.5.1]
+
Robert Ginn
10
Mary Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.6]
b. Aug 1885 d. 1 Feb 1889
10
Frances Almira Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.1.7]
b. 2 Sep 1889 d. 17 Oct 1889
9
Archibald Stobo Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.2]
b. 28 Feb 1861 d. 18 May 1877
9
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.10.3]
8
Charles Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.11]
b. 10 Feb 1837 d. 29 Jul 1909
Esther Clementine Stewart
b. 6 Sep 1853 d. 5 May 1926
9
Violet Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.11.1]
b. 30 Nov 1870 d. 23 Aug 1918
9
Clara M. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.11.2]
b. 1 May 1873 d. 2 Feb 1943
David Dennis Crosby
10
Kenneth Crosby
[1.1.1.1.1.1.2.11.2.1]
+
Palfrey
9
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.11.3]
b. 1876 d. 15 Apr 1881
9
Bernice Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.11.4]
b. 25 Sep 1878
Ernest Elmer Preston
b. 1877
10
George Thomson Preston
[1.1.1.1.1.1.2.11.4.1]
10
Laverne Preston
[1.1.1.1.1.1.2.11.4.2]
10
Daughter Preston
[1.1.1.1.1.1.2.11.4.3]
Dawner
11
Beverley Ann Dawner
[1.1.1.1.1.1.2.11.4.3.1]
9
Florence May Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.11.5]
b. 1883 d. Aug 1962
9
Ernest Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.11.6]
b. 1879
8
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.12]
b. 31 Mar 1832 d. Bef 1881
Christina Glendinning
b. 6 Jan 1837 d. 10 May 1920
9
Isabella Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.12.1]
b. 19 May 1859 d. 18 May 1885
+
George Green
b. 27 Mar 1861 d. 26 Aug 1948
9
Andrew Borthwick Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.12.2]
b. 16 May 1862 d. 10 Mar 1877
9
William H. Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.12.3]
b. 1865 d. 12 Mar 1877
9
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.12.4]
b. 1857 d. 29 Mar 1877
Janet Thomson
b. Abt 1796
8
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.2.13]
b. 25 Jul 1813 d. 14 Jul 1890
Joseph Walton
b. 4 May 1804 d. 12 Feb 1888
9
Eunice Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.1]
b. 4 Aug 1834 d. 3 Jan 1904
Thomas A Little
b. 18 Jun 1825 d. 6 Mar 1869
10
Lydia Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.1]
b. 16 Mar 1854 d. 20 Apr 1929
+
Thomas A Ferris
b. 31 Dec
10
Andrew Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.2]
b. 1 Mar 1856 d. 30 Apr 1921
Matilda C Ross
b. 1858 d. 13 Mar 1900
11
Lydia May Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.2.1]
b. 1879
11
Flora Clarabel Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.2.2]
b. 20 May 1880 d. Abt Aug 1961
Grant Smith Wilcox
b. 24 Sep 1874 d. Jun 1955
12
Grant Smith Wilcox
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.2.2.1]
b. 13 Nov 1909 d. 21 Dec 1980
12
Flora Isabel Wilcox
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.2.2.2]
b. 12 Dec 1918 d. 6 Aug 1988
11
Thomas Frederick Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.2.3]
b. 1881
11
Nellie Louise Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.2.4]
b. 7 Jul 1883
11
Laura Gertrude Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.2.5]
b. 5 Jul 1887
11
Robert A Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.2.6]
b. Nov 1890
10
Joseph Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.3]
b. 9 Dec 1858 d. 14 Jan 1935
10
Thomas Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.4]
b. 21 Jan 1861 d. 21 Feb 1907
10
Isabell Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.5]
b. 22 Dec 1864 d. 13 Feb 1935
James Oliver Utley
b. 1865 d. 1 Jun 1941
11
Ellis Andrew Utley
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.5.1]
b. 9 Jun 1888 d. 1957
Myrtle J. Hutchison
b. 11 Sep 1889 d. 11 Nov 1957
12
Donald Utley
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.5.1.1]
b. 12 Dec 1912 d. 11 Apr 1962
11
Minerva Little Utley
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.5.2]
b. 17 Feb 1890
11
Charles Utley
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.5.3]
b. 1896 d. 1960
+
Vera DeWolf
b. 11 Apr 1902 d. May 1981
+
Ruby Morgan
10
Sarah Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.6]
b. 11 May 1865 d. 11 May 1865
10
Charles Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.7]
b. 5 Apr 1867
+
Dora
b. Abt 1887 d. 1980
10
Carrie Little
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.8]
b. 17 Mar 1869 d. 21 Dec 1875
James Marion Brown
b. 11 Mar 1839 d. 15 Apr 1915
10
Ralph Brown
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.9]
b. 15 Apr 1873
Martha McKay
11
Helen Minerva Brown
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.9.1]
b. 2 Feb 1907 d. 7 Nov 1980
10
Jessie Brown
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.10]
b. 17 Jan 1877 d. 30 Apr 1921
Joseph Cook
11
Jessie Carola Cook
[1.1.1.1.1.1.2.13.1.10.1]
9
Esther H. Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.2]
b. 28 Mar 1839 d. 23 Apr 1869
9
Henry Watson Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.3]
b. 4 Feb 1856 d. 20 Aug 1927
Anne Maren Shields
b. 22 Jan 1865
10
Margaret E. Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.3.1]
b. 1 Oct 1889
9
Jane (Jennie) Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.4]
b. 26 Sep 1833 d. 20 Apr 1900
James Simpson
b. 10 Jun 1833 d. 31 Dec 1901
10
Sarah Jane Simpson
[1.1.1.1.1.1.2.13.4.1]
b. 29 Mar 1873 d. 8 Aug 1937
Charles David Lennox
b. 27 Nov 1862
11
Charles Simpson Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.13.4.1.1]
11
Edward James Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.13.4.1.2]
11
Jean Alexandra Luella Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.13.4.1.3]
11
Iris Emmeline Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.13.4.1.4]
John Edward Insley Davis
12
Sonya Davis
[1.1.1.1.1.1.2.13.4.1.4.1]
11
Sarah Erma Lennox
[1.1.1.1.1.1.2.13.4.1.5]
+
John Ingham Sutcliffe
9
Wallace Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.5]
b. 1840 d. 30 Jun 1896
Sarah Wilkins
b. 14 Aug 1839 d. 31 Jan 1921
10
A Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.5.1]
b. 1866
9
Sarah Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.6]
b. Abt 1844
9
William Joseph Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.7]
b. 1845 d. 9 Feb 1917
9
Caroline Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.8]
b. Abt 1848 d. Bef 1881
+
Joseph Smith
9
Andrew Walton
[1.1.1.1.1.1.2.13.9]
b. Abt 1851 d. Aft 1886
7
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 8 Jan 1793 d. 15 Aug 1872
Peter Little
b. 18 Aug 1796 d. 12 Jul 1847
8
Thomas A Little
[1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 18 Jun 1825 d. 6 Mar 1869
Eunice Walton
b. 4 Aug 1834 d. 3 Jan 1904
9
Lydia Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 16 Mar 1854 d. 20 Apr 1929
+
Thomas A Ferris
b. 31 Dec
9
Andrew Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.2]
b. 1 Mar 1856 d. 30 Apr 1921
Matilda C Ross
b. 1858 d. 13 Mar 1900
10
Lydia May Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.1]
b. 1879
10
Flora Clarabel Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2]
b. 20 May 1880 d. Abt Aug 1961
Grant Smith Wilcox
b. 24 Sep 1874 d. Jun 1955
11
Grant Smith Wilcox
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.1]
b. 13 Nov 1909 d. 21 Dec 1980
11
Flora Isabel Wilcox
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.2.2]
b. 12 Dec 1918 d. 6 Aug 1988
+
John Frederick Enot
b. 13 Feb 1917 d. 4 May 1992
10
Thomas Frederick Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.3]
b. 1881
10
Nellie Louise Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.4]
b. 7 Jul 1883
10
Laura Gertrude Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.5]
b. 5 Jul 1887
10
Robert A Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.2.6]
b. Nov 1890
9
Joseph Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.3]
b. 9 Dec 1858 d. 14 Jan 1935
9
Thomas Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 21 Jan 1861 d. 21 Feb 1907
9
Isabell Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.5]
b. 22 Dec 1864 d. 13 Feb 1935
James Oliver Utley
b. 1865 d. 1 Jun 1941
10
Ellis Andrew Utley
[1.1.1.1.1.1.3.1.5.1]
b. 9 Jun 1888 d. 1957
Myrtle J. Hutchison
b. 11 Sep 1889 d. 11 Nov 1957
11
Donald Utley
[1.1.1.1.1.1.3.1.5.1.1]
b. 12 Dec 1912 d. 11 Apr 1962
+
Marjorie Lois Johnson
b. 26 May 1913 d. 7 May 1996
10
Minerva Little Utley
[1.1.1.1.1.1.3.1.5.2]
b. 17 Feb 1890
10
Charles Utley
[1.1.1.1.1.1.3.1.5.3]
b. 1896 d. 1960
+
Vera DeWolf
b. 11 Apr 1902 d. May 1981
+
Ruby Morgan
9
Sarah Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.6]
b. 11 May 1865 d. 11 May 1865
9
Charles Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.7]
b. 5 Apr 1867
+
Dora
b. Abt 1887 d. 1980
9
Carrie Little
[1.1.1.1.1.1.3.1.8]
b. 17 Mar 1869 d. 21 Dec 1875
8
Mary Little
[1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 22 Feb 1822 d. 19 Oct 1886
Robert Sellers
b. 28 Apr 1809 d. 8 Mar 1895
9
Martha Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. 1861 d. 3 Oct 1864
9
Helen Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.2]
b. 27 Feb 1845 d. 22 Apr 1853
9
Robert Peter Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3]
b. 19 Jan 1855 d. 17 Feb 1927
Rhubertha Ellen Fleming
b. 7 Feb 1870 d. 20 Mar 1952
10
Charles Addison Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.1]
b. Oct 1897 d. 5 Feb 1898
10
William Gordon Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2]
b. 3 Dec 1890 d. 4 Feb 1972
Elizabeth Ewart Webster
b. 20 Aug 1889 d. 6 Jan 1974
11
Elizabeth Irene Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.1]
b. 27 Sep 1914
George Sterling
b. 21 Feb
12
Donald William Sterling
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.1.1]
12
Joanne Sterling
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.1.2]
12
Carol Sterling
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.1.3]
11
Robert Hartley Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.2]
b. 26 Mar 1916
Florence Cross
12
Judith Delores Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.2.1]
11
Franklin Ewart Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.3]
b. 12 Jan 1918
Georgina Padget
12
Elizabeth Ruth Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.3.1]
12
Robert Gordon Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.3.2]
12
Frances Joan Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.3.3]
11
Isabel Rhubertha Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.4]
b. 4 Jun 1920
Walter Douglas Rogerson
b. 17 Jul 1918 d. 21 Nov 1986
12
Robert Keith Rogerson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.2.4.1]
10
Mary Louella Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.3]
b. 11 Dec 1892 d. 2 Aug 1982
James Simpson
b. 1887 d. Apr 1966
11
Rhubertha (Ruby) Simpson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.3.1]
b. 20 Aug 1922 d. 15 Jun 2005
Kenneth Simpson
b. 1921 d. 13 Nov 2009
12
Joyce Ellen Simpson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.3.1.1]
12
Gary Simpson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.3.1.2]
11
Robert James Simpson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.3.2]
b. 1 May 1925
Jean Alderson
12
Wayne Simpson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.3.2.1]
12
Douglas Simpson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.3.2.2]
11
Ann Simpson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.3.3]
b. 7 Apr 1927 d. 1974
11
Gordon Fleming Simpson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.3.4]
b. Dec 1930 d. 21 Apr 2010
10
Jennett Leona Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.4]
b. 9 Apr 1906
Walter Atkinson
11
Marion R Atkinson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.4.1]
Grant Wells
12
Christine Wells
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.4.1.1]
11
Isobel Christine Atkinson
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.4.2]
+
Glen Clifford Evans
10
Robert Franklin Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.5]
b. 10 Jan 1896 d. 26 Sep 1946
Mary Grove
b. Abt 1902
11
Carl Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.5.1]
b. 11 Jul 1926
Mildred Ionson
12
Barbara Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.5.1.1]
11
Ila Susan Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.5.2]
b. 25 May 1928
+
Joseph Lafayette Duek
11
Robert Franklin Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.5.3]
b. 13 Feb 1931
Dixie Forrester
12
Debra Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.5.3.1]
12
Darryl Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.5.3.2]
11
Grace Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.3.5.4]
+
K Meeks
9
William Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4]
b. 2 Jul 1851 d. 26 Jan 1932
Hannah Jane Ormrod
b. 3 Feb 1857 d. 9 Sep 1902
10
Gladys Read Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.1]
b. 4 Mar 1897 d. 10 Jan 1898
10
Janet Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.2]
b. 17 Jul 1884 d. 9 Mar 1906
10
Arthur Little Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.3]
b. 21 Jan 1882 d. 26 Mar 1886
10
Robert Franklin Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.4]
b. 24 Nov 1878 d. 30 Mar 1886
10
Ethel Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.5]
b. 13 Jul 1883 d. 25 Mar 1886
10
William Westley Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.6]
b. 28 Jun 1880 d. 30 Mar 1886
10
William Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.7]
b. 11 Oct 1889 d. 28 Oct 1951
Caroline Couperthwaite
b. 28 Aug 1894 d. 22 Mar 1966
11
Marion Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.7.1]
b. 28 Dec 1917 d. 20 Jan 1997
Albert F. Hart
b. 15 Sep 1919 d. 9 Mar 1994
12
Mary Elizabeth Hart
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.7.1.1]
11
Earl Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.7.2]
b. 23 Jun 1921 d. 20 Jan 1987
Claire Marsh
12
Maureen Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.7.2.1]
12
Paul Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.7.2.2]
11
Jean Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.7.3]
b. 10 Feb 1923 d. 16 Oct 1993
John Stanley Harper
b. 24 Jun 1921 d. 29 Jan 1997
12
Catherine Harper
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.7.3.1]
12
Brian Harper
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.7.3.2]
10
Frances Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.8]
b. 1 Jan 1885 d. 19 Nov 1961
+
Robert Franklin Webster
b. 3 Nov 1884 d. 28 Jun 1954
10
Sybil Reeve Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9]
b. 15 Feb 1891 d. 13 Apr 1955
Roy Egbert Weir
b. 30 Sep 1890 d. Apr 1961
11
Margaret Jane Weir
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.1]
b. 1913
+
Herbert Howe
11
Lloyd Weir
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.2]
b. 1915
Marion Anderson
12
Eleanor Weir
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.2.1]
12
Lois Weir
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.2.2]
12
Helen Weir
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.2.3]
12
Roy Lloyd Harvey Weir
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.2.4]
11
Frances Weir
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.3]
b. 1918
Andrew Stewart
b. 1920
12
William Stewart
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.3.1]
12
Donald Stewart
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.3.2]
11
Gladys Weir
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.4]
Carl Strachan
12
Douglas Strachan
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.4.1]
12
Reva Strachan
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.9.4.2]
10
Alberta Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10]
b. 3 Sep 1887 d. 28 Aug 1963
Hugo Victor Goddard
b. 16 Oct 1893 d. Jul 1967
11
Dorothy Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.1]
b. 6 Aug 1915
Leslie Fields
b. 1909
12
Claudia Fields
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.1.1]
12
Barbara Fields
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.1.2]
11
Victor Henry Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.2]
b. 16 Jun 1919
Molly Burden
12
Gloria Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.2.1]
12
Doreen Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.2.2]
12
Carol Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.2.3]
11
Frederick George Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.3]
b. 9 Nov 1921
12
Wayne Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.3.1]
12
Karen Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.3.2]
11
William Arthur Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.4]
b. 19 Apr 1924
Gloria
12
Gregory Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.4.1]
11
John Edward Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.5]
b. 12 Jan 1928
12
Robert Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.5.1]
12
Pamela Goddard
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.10.5.2]
10
Bernice Elaine Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.11]
b. 29 Jun 1898
William Arthur Meyrick
b. Sep 1890
11
Helen Meyrick
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.11.1]
b. 1922
Luke Robert Troke
b. 1919 d. 1965
12
Beverly Troke
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.11.1.1]
12
Mary Troke
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.11.1.2]
12
Nancy Troke
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.11.1.3]
12
Linda Troke
[1.1.1.1.1.1.3.2.4.11.1.4]
9
Frances Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.5]
b. 1 Aug 1860 d. 21 Jun 1914
William Mason Wood
b. 13 Jan 1858 d. 1928
10
Mary Etta Wood
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.1]
b. 16 Feb 1884 d. 17 Mar 1933
Christopher Lamoreaux
b. 15 Sep 1885
11
Ross William Lamoreaux
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.1.1]
10
Isabella Wood
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.2]
b. 9 Aug 1886 d. 24 Jun 1938
Henry Annis Mason
b. 13 Sep 1884 d. 30 Aug 1955
11
Florence Evelyn Mason
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.2.1]
11
Charles Elwood Mason
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.2.2]
b. 13 Jan 1909
11
Murray A. Mason
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.2.3]
Gladys Ruth Pearson
d. 1961
12
Mason
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.2.3.1]
11
Lawrence Henry Mason
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.2.4]
b. 12 Mar 1918 d. 12 Mar 1918
10
Florence Mary Wood
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.3]
b. 11 Feb 1891
Llewellyn John Hamilton Reesor
b. 2 Oct 1888 d. 5 Dec 1968
11
Katherine Florence Reesor
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.3.1]
+
Douglas McLean
11
Lois Reesor
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.3.2]
10
Elizabeth Wood
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.4]
b. 27 Mar 1893 d. 1 Feb 1965
+
Robert Johnston Baird
b. 3 Apr 1897 d. 15 Aug 1963
10
Arthur McLean Wood
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.5]
b. 25 Aug 1897
Olive Jane Honey
b. 1897 d. 7 Dec 1964
11
William Ray Wood
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.5.1]
b. 1922 d. 8 Sep 1961
+
Grace Adeline Moore
11
Leona Wood
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.5.2]
+
Thomas E. Wilson
11
Earl J. Wood
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.5.3]
+
Vera King
11
Joyce Wood
[1.1.1.1.1.1.3.2.5.5.4]
+
C. William Watson
9
Isabella Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.6]
b. 28 Nov 1852 d. 3 May 1889
Richard Underwood
b. 21 Aug 1857 d. 22 Sep 1907
10
Francis Seller Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.1]
b. 19 Mar 1882 d. 15 Apr 1886
10
Mary Little Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2]
b. 8 Nov 1884 d. 18 Jan 1958
William John Wesley Jarvis
b. 19 Jun 1879 d. 27 Sep 1957
11
Willis John Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.1]
b. 21 Dec 1909 d. 3 Oct 1986
Pearl Thaxter
b. 16 Aug 1913
12
Evelyn Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.1.1]
12
Thelma Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.1.2]
11
Donald Francis Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.2]
b. 10 Dec 1910
+
Blanche Raymer
11
Russell Arthur Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.3]
b. 20 Feb 1913
Lorna Raymer
12
Ruth Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.3.1]
12
Audrey Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.3.2]
12
Dorothy Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.3.3]
12
Louise Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.3.4]
12
Betty Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.3.5]
12
Joanne Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.3.6]
12
Laurie Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.3.7]
11
Howard Niel Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.4]
b. 9 Mar 1921 d. 19 Jan 1922
11
Herbert Ross Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.5]
b. 3 Jan 1923
Laurena Joy Timbers
b. 8 Jan 1920 d. 19 Jul 1990
12
Brenda Anne Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.5.1]
b. 20 Feb
12
Linda Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.5.2]
12
Donna Loreen Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.5.3]
12
Wesley Herbert Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.5.4]
11
Leonard James Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.6]
b. 5 Mar 1925
Eileen Baker
12
Keith Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.6.1]
12
Ronald Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.6.2]
11
Richard Wesley Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.7]
b. 21 Jul 1915
Mildred McArthur
12
Howard Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.7.1]
12
Douglas Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.7.2]
11
Norman Robert Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.8]
b. 11 Dec 1917 d. 10 Feb 1997
Mary Steckley
12
Carol Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.8.1]
12
Kenneth Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.8.2]
12
Marilyn Jarvis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.2.8.3]
10
Robert Walter Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3]
b. 15 Apr 1887 d. 22 Aug 1959
Della Jarvis
b. 16 Oct 1888 d. 1972
11
Harvey Richard Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.1]
b. 27 Oct 1908 d. 22 Apr 1982
Mary Edith Gill
b. 31 Jul 1913
12
Richard Edward Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.1.1]
12
Donald Harvey Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.1.2]
12
Ivan Gerald Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.1.3]
11
Lillian Maud Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.2]
b. 25 Mar 1910
Elgin Anthony Walker
b. 1 May 1910 d. 3 Feb 1964
12
William Robert Walker
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.2.1]
b. 17 Sep 1932 [
=>
]
12
James Howard Walker
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.2.2]
b. 7 Dec 1933 [
=>
]
12
Barbara June Walker
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.2.3]
[
=>
]
12
Floyd John Walker
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.2.4]
11
Harold Albert Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.3]
b. 7 Apr 1912
Blanche Miller
b. 10 Nov 1914
12
Shirley Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.3.1]
12
Darleen Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.3.2]
12
Norman Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.3.3]
12
Dorothy Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.3.4]
12
Stephen Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.3.5]
11
Laura Mary Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.4]
b. 18 Jul 1914 d. Aft 2003
Vincent Louis Warmington
b. 19 Feb 1910
12
Douglas Vincent Warmington
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.4.1]
12
Elenore Joan Warmington
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.4.2]
12
Carolyn Laura Warmington
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.4.3]
12
Gordon Louis Warmington
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.4.4]
+
Jack Baliss
11
Nora Elizabeth Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.5]
b. 9 Aug 1915 d. 8 Nov 1981
Harold George Clark
b. 22 Aug 1909
12
Dorothy Clark
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.5.1]
b. 4 Aug 1933 [
=>
]
12
George Kenneth Clark
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.5.2]
11
Frederick Robert Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.6]
b. 21 Jan 1918 d. 1 May 1936
11
Arthur John Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.7]
b. 16 Jan 1921 d. 21 Nov 2006
Joyce Young
b. 2 Sep 1922 d. 8 Aug 2014
12
Ronald Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.7.1]
12
Marilyn Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.7.2]
11
Thomas Willis Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.8]
b. 10 Nov 1923 d. 6 Jun 1944
11
Gordon Ross Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.9]
b. 22 Aug 1924
Thomasina Brown
b. 6 Jul 1929
12
Wendy Susan Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.9.1]
12
Cathy Joan Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.9.2]
12
Judith Ann Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.9.3]
11
May Jean Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.10]
b. 16 May 1926
Morley Davis
b. 21 Jun 1928
12
Raymond Douglas Davis
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.10.1]
11
Lyle Archie Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.11]
b. 26 Jan 1928
Shirley Chapman
b. 20 Apr 1929
12
Ricky Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.11.1]
12
Robert Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.11.2]
12
David Allan Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.11.3]
11
George Walter Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.12]
b. 19 Sep 1929
Evelyn Mayberry
12
Georgia Diane Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.12.1]
12
Thomas James Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.12.2]
+
Mary Geraldine Smith
11
Robert James Underwood
[1.1.1.1.1.1.3.2.6.3.13]
b. 15 Mar 1931
+
Annabelle Mary MacKimmy
b. 31 Dec 1939 d. 26 May 1965
9
Janet (Jennie) B. Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.7]
b. 1 Jan 1858 d. 8 Mar 1886
James McCreight
b. 1 Apr 1848 d. 17 Sep 1921
10
Janet (Jennie) Ellen McCreight
[1.1.1.1.1.1.3.2.7.1]
b. 24 Feb 1886 d. 27 Dec 1933
9
Mary Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.8]
b. 29 Jan 1849 d. 31 Mar 1902
Daniel Hope
b. 1 Apr 1833 d. 22 Feb 1913
10
William Leslie Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.1]
b. 9 Aug 1872 d. 10 Feb 1951
Lillian Dixon
b. 9 Dec 1869 d. 21 Sep 1933
11
Horace Bertram Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.1.1]
b. 28 Jun 1903
Elda Marie Clayton
b. 4 Apr 1906 d. 22 Dec 1950
12
Lois Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.1.1.1]
b. 15 Sep 1923 [
=>
]
11
Frederick Cecil Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.1.2]
b. 2 Aug 1899 d. 9 Jul 1998
Mildred Eileen Reesor
b. 3 Feb 1902 d. 26 Jul 1994
12
Donald William Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.1.2.1]
b. 22 Dec 1931 d. 28 Jun 1998 [
=>
]
12
Janet Joyce Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.1.2.2]
b. 10 Jun 1928
10
Isabella Jane Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.2]
b. 21 Oct 1874 d. 7 Apr 1877
10
Janet May Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.3]
b. 26 Apr 1881 d. 15 Aug 1963
+
Fred Johnston
d. 1937
+
Hugh Boyd
b. 8 Feb 1876 d. 25 May 1954
10
Robert Sellers Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.4]
b. 19 Mar 1878 d. 11 Apr 1961
Lucinda (Cindy) Reynolds
b. 19 Jun 1881 d. 16 Jan 1967
11
Harry David Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.4.1]
b. 5 Jan 1906
+
Marion Williams
11
Ruth Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.4.2]
b. 27 Sep 1910 d. 30 Nov 1996
+
Arthur George Hall
b. 20 May 1906 d. 12 Dec 1993
11
Walter Murray Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.4.3]
b. 4 Dec 1913 d. 25 Jan 1991
Lillian Bacon
12
Allan Walter Hope
[1.1.1.1.1.1.3.2.8.4.3.1]
b. 18 Sep 1952 d. 26 Sep 1952
9
Peter Sellers
[1.1.1.1.1.1.3.2.9]
b. 18 Sep 1846 d. 21 Apr 1853
8
David Little
[1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 1833
Helen
b. 1831
9
Andrew Little
[1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 1859
8
Janet (Jennie) Little
[1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 16 Jan 1828 d. 2 Dec 1893
Andrew Janulet Taylor
b. May 1826 d. 12 Sep 1893
9
Richard Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 7 Oct 1846 d. 7 May 1853
9
Peter Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.2]
b. 30 Sep 1848 d. 30 Apr 1853
9
David Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.3]
b. 4 Apr 1860 d. 8 Feb 1885
9
Isabella Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.4]
b. 17 Mar 1857 d. 28 Jun 1878
9
James Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 1852
9
Robert Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6]
b. 14 Dec 1850 d. 15 Mar 1924
Annie Elizabeth Hunter
b. Abt 1856
10
Edward Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.1]
b. 2 Oct 1881
Nettie Hackney
11
Robert Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.1.1]
Priscilla Baston
b. 4 Sep 1894
11
Muriel Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.1.2]
10
Andrew Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.2]
b. 2 Oct 1883
Mabel Morgason
b. 19 May 1887
11
Mary Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.2.1]
11
Elizabeth Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.2.2]
Wilbert Gower
12
Marie Gower
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.2.2.1]
12
Jean Gower
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.2.2.2]
11
Pearla Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.2.3]
10
Richard (Dick) Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.3]
b. 12 Sep 1885 d. 22 Oct 1968
+
Isabella Clancy
b. 29 Dec 1881 d. 2 Dec 1965
10
Martha Elsie Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.4]
b. 17 Aug 1887
Joseph Stinson Cooper
b. 21 May 1891 d. 11 Jun 1961
11
Mary Helena Cooper
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.4.1]
b. 31 Jan 1917 d. 12 Dec 1996
Leslie George Mitchell
b. 27 Jun 1913 d. 26 Oct 1996
12
Carol Mitchell
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.4.1.1]
12
Doreen Mitchell
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.4.1.2]
11
Ralph Cooper
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.4.2]
b. 23 Dec 1914 d. 21 Sep 1981
+
Marjorie Doreen Hackney
d. 12 Jun 1989
10
Isabella Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5]
b. 20 Apr 1890 d. 29 Mar 1967
George Henry Stewart
b. 16 Nov 1890 d. 8 Feb 1944
11
Murray Stewart
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.1]
Marjorie Thomson
12
Donna Stewart
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.1.1]
12
Ronald Stewart
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.1.2]
12
Keith Stewart
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.1.3]
11
Winnie Stewart
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.2]
Harry Walker
12
Srewart Walker
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.2.1]
12
Lyle Walker
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.2.2]
11
Martha Stewart
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.3]
Arthur Lehman
12
Edward Lehman
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.3.1]
12
Harvey Lehman
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.3.2]
12
Randy Lehman
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.3.3]
12
Gail Lehman
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.5.3.4]
10
Robert Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.6]
b. 9 Jul 1892 d. 14 Oct 1919
Ethel Jones
b. 13 Nov 1894
11
Bertram Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.6.1]
b. 17 Feb 1919 d. 5 Jul 2001
Inez Thomson
12
Earl Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.6.1.1]
12
Garry Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.6.1.2]
12
Wendy Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.6.1.3]
10
Albert Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7]
b. 8 Jan 1895
Alta Floss Amelia McGuigan
b. 25 May 1897
11
Bruce Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.1]
Dorothy Miller
12
Glenda Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.1.1]
12
Larry Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.1.2]
11
Willis Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.2]
Blanche Mortson
12
Wayne Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.2.1]
12
Walter Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.2.2]
12
Dennis Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.2.3]
11
Allan E. Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.3]
Marion Redshaw
12
Diane Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.3.1]
12
Nancy Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.3.2]
12
Gary Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.3.3]
11
Ronald Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.4]
Joyce
12
Brian Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.4.1]
12
Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.4.2]
11
Murray Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.5]
Doris Forsythe
12
Ricky Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.5.1]
11
Richard Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.6]
11
Darlene Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.7]
William Graham
12
William Graham
[1.1.1.1.1.1.3.4.6.7.7.1]
9
Andrew Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.7]
b. 23 Oct 1855
Alice Curtis
10
Gordon Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.7.1]
10
Edwin Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.7.2]
10
George Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.7.3]
+
Agnes Jane Simmons
b. Abt 1881
9
Frances (Fanny) Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.8]
b. 6 Feb 1862 d. 20 Oct 1901
Patrick James Clancy
b. 23 Aug 1856 d. 22 Mar 1935
10
Anna Isabella Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.1]
b. 30 Dec 1882 d. 2 Dec 1965
10
Andrew Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2]
b. 9 May 1878 d. 3 Feb 1963
Emily May Walton
b. 15 Jan 1885 d. 6 Oct 1969
11
Albert David Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.1]
b. 17 Aug 1905 d. 3 Oct 1973
11
Andrew Harvey Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.2]
b. 4 Jun 1907
+
Violet Thomson
11
Emily Annabelle Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.3]
b. 16 Jan 1909 d. 1993
11
Wilfred Ross Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.4]
b. 8 Oct 1911 d. 1991
11
Richard Leslie Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.5]
b. 13 Jul 1913 d. 1987
Glenna
12
Shirley Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.5.1]
12
Sonny Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.5.2]
11
Malcom Arnold Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.6]
b. 8 Jul 1915 d. 1982
Martha W. Rathage
b. 1923 d. 1985
12
Glen Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.6.1]
12
Neil Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.6.2]
12
Roy Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.6.3]
11
Francis Earl Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.7]
b. 4 Oct 1917
+
Margaret Boston
11
Eva Caroline Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.8]
b. 6 Apr 1919 d. 1997
11
Ruby Esther Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.9]
b. 26 Mar 1921 d. 1 Apr 1999
Anthony Glowacki
12
Raymond Daryle Glowacki
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.9.1]
[
=>
]
11
James Edward Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.10]
b. 25 Aug 1923 d. 1968
Doreen Mogenson
12
Douglas Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.10.1]
12
Joyce Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.10.2]
11
Norman Weslry Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.11]
b. 12 Jul 1925 d. 1 Aug 2002
Louise
12
Wayne Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.11.1]
12
Bruce Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.11.2]
11
Olive Minette Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.12]
b. 9 Feb 1927
Michael James Glowacki
12
Melora Dawn Glowacki
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.12.1]
[
=>
]
11
Gerald Valens Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.13]
b. 10 Feb 1929 d. 4 Nov 1985
+
Edna Lenore Brock
b. 1932 d. 1988
11
Inez Bernice Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.2.14]
b. 29 Dec 1930
+
William John Graham
10
David Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.3]
b. 13 Dec 1879
Maud L. Shannon
b. 1875
11
David Alexander Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.3.1]
b. 1908
11
Maud Isabella Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.3.2]
b. 1909
Arnold Otto Gilbertson
12
Marvin Gilbertson
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.3.2.1]
12
Merill Gilbertson
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.3.2.2]
12
Lorne Gilbertson
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.3.2.3]
11
Inez May Clancy
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.3.3]
George Joseph Ebben
b. 27 Nov 1907 d. 23 Jun 1990
12
Naida Ebben
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.3.3.1]
12
Nelda Ebben
[1.1.1.1.1.1.3.4.8.3.3.2]
9
Anthenatte (Nettie) Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.9]
b. 29 Nov 1867 d. 15 Mar 1903
Charles Coathup
b. 3 Apr 1861 d. 28 Jun 1948
10
Richard Coathup
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.1]
b. 22 Aug 1884 d. 11 Jul 1885
10
Janet Coathup
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.2]
b. 1885
10
Mary Elizabeth Coathup
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.3]
b. 23 May 1888
James Butler
b. Aug 1882
11
Frederick Butler
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.3.1]
11
Gordon Butler
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.3.2]
11
Ernest David Butler
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.3.3]
11
Harvey Butler
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.3.4]
11
Stanley Ross Butler
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.3.5]
10
Wilfred Charles Coathup
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.4]
b. 8 Oct 1889
Elizabeth Ann (Bessie) Dix
b. Abt 1894
11
Verna Coathup
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.4.1]
11
Doris Coathup
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.4.2]
10
David Levi Coathup
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.5]
b. 7 Jul 1891
Margaret L. Woods
11
Ethel Beatrice Coathup
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.5.1]
b. 18 May 1908
+
Robert Hewson Martin
b. 24 Jan 1907
11
Ernest Coathup
[1.1.1.1.1.1.3.4.9.5.2]
9
Mary A. Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.10]
b. 30 May 1864
John Clayton
b. 10 Aug 1861
10
David Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.1]
b. 1 Apr 1887
Winnie G. Taylor
b. Abt 1889
11
Eva Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.1.1]
11
Reta Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.1.2]
11
Marie Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.1.3]
10
Janet Anthenetta (Nettie) Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.2]
b. 23 Sep 1888
John William Beck
b. 7 Jul 1889
11
Lloyd Beck
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.2.1]
11
Elgin Beck
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.2.2]
11
Roland Beck
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.2.3]
11
Cecil Beck
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.2.4]
11
Joyce Beck
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.2.5]
10
Martha Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.3]
b. 7 Nov 1890
10
Hartford Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.4]
b. 27 Aug 1892
Gleneta Piton
b. Abt 1897
11
Alexander Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.4.1]
11
Lois Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.4.2]
11
Bernice Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.4.3]
11
Bruce Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.4.4]
11
John Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.4.5]
11
David Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.4.6]
11
Glen Clayton
[1.1.1.1.1.1.3.4.10.4.7]
9
Ellen Taylor
[1.1.1.1.1.1.3.4.11]
b. 8 Aug 1870
Ben Shaddock
b. 13 Jan 1873
10
Edward Cromwell Shaddock
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.1]
b. Abt 1903
Lillian Rowley
b. Abt 1902
11
William R. Shaddock
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.1.1]
b. 1931
10
Mary Janet Shaddock
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.2]
b. 1 Apr 1899
Harold Percival Pegler
b. Abt 1888
11
Kathleen Pegler
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.2.1]
William Thompson
12
Gwen Thompson
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.2.1.1]
12
William Thompson
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.2.1.2]
11
William Pegler
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.2.2]
11
Edward B. Pegler
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.2.3]
11
Harold Pegler
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.2.4]
11
Ruth Pegler
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.2.5]
+
John Ryan
10
Frances Elizabeth Shaddock
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.3]
b. Abt 1902
Joseph P. Symons
b. Abt 1905
11
Jean Symons
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.3.1]
Neil Hunter
12
Robert Hunter
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.3.1.1]
12
Patricia Hunter
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.3.1.2]
12
James Hunter
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.3.1.3]
11
Marie Symons
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.3.2]
Morley Ryan
12
Donna June Marie Ryan
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.3.2.1]
11
Gordon Symons
[1.1.1.1.1.1.3.4.11.3.3]
d. 1938
8
Helen (Ellen) Little
[1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 27 May 1831 d. 19 Jun 1911
William Curtis
b. 1827 d. 19 Jul 1879
9
Andrew Little Curtis
[1.1.1.1.1.1.3.5.1]
b. 11 Feb 1860 d. 25 Jul 1932
9
David Curtis
[1.1.1.1.1.1.3.5.2]
b. 12 Sep 1865 d. Aft 1901
9
Isabella Curtis
[1.1.1.1.1.1.3.5.3]
b. 1867 d. Aft 1901
9
Thomas Curtis
[1.1.1.1.1.1.3.5.4]
b. 1870
7
Richard D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.4]
b. 18 Oct 1794 d. 22 Feb 1878
Harriet Smith
b. Dec 1799 d. 17 May 1881
8
David R. Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 1 Dec 1821 d. 30 Apr 1891
Rebecca Chester
b. 7 Oct 1825 d. 4 Mar 1916
9
Richard D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1]
b. 3 Sep 1850 d. 18 Sep 1934
Agnes Hood Thomson
b. 12 Apr 1857 d. 10 Nov 1935
10
Gertrude Agners Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1]
b. 14 Dec 1881 d. 11 Apr 1947
George Thomson
b. 18 Sep 1875 d. 12 Sep 1933
11
Bertha Hood Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1]
b. 13 Mar 1904
Alvin Scott
b. 24 Oct 1899
12
Dorothy Jean Scott
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1.1]
b. 24 Nov 1924
12
Lois Irene Scott
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1.2]
b. 12 Feb 1926
12
Roy James Scott
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1.3]
b. 27 Mar 1928
12
Kenneth Alvin Scott
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1.4]
b. 15 Mar 1932
12
Barbara Clarissa Scott
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.1.5]
11
Mabel Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.2]
b. 15 Oct 1905 d. 27 Aug 1970
William Richards
b. 10 Apr 1908
12
Nina Marion Richards
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.2.1]
b. 23 Mar 1929
12
Agnes Jean Richards
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.2.2]
12
Gordon Douglas Richards
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.2.3]
12
George Wesley Richards
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.2.4]
12
Donald Scott Richards
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.2.5]
12
Robert Wayne Richards
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.2.6]
11
Gertrude Jean Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.3]
b. 16 Feb 1909 d. 1990
Ralph Ross
b. 2 Jun 1908
12
Lloyd Edwin Ross
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.3.1]
b. 15 Feb 1932
12
Eva Florence Ross
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.3.2]
12
George Andrew Ross
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.3.3]
b. 25 Mar 1936 d. 26 Apr 1955
12
Anna may Ross
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.3.4]
12
Donna Jean Ross
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.3.5]
12
Joan Catherine Ross
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.3.6]
12
Patricia Dianne Ross
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.3.7]
11
Georgina Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.4]
b. 23 Apr 1911 d. 1996
Stanley Jamieson
b. 11 May 1910
12
Harley George Jamieson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.4.1]
12
Betty Leila Jamieson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.4.2]
12
Carol Alice Jamieson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.4.3]
12
Bonnie Doreen Jamieson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.4.4]
12
Douglas Scott Jamieson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.4.5]
11
Walter Harvey Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.5]
b. 22 Apr 1913
Lenore Herrington
b. 23 Jun 1916
12
Marylin Joan Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.5.1]
[
=>
]
12
Velma Maguerite Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.5.2]
[
=>
]
12
Ruth Elaine Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.5.3]
12
Allan Leroy Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.5.4]
12
Arlene Lenore Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.5.5]
12
Keith Walter Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.1.5.6]
10
May Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2]
b. 10 Oct 1883 d. 25 Sep 1960
Archibald Loane Muir
b. 20 Mar 1870 d. 14 Dec 1958
11
Harold Cecil Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.1]
b. 7 Sep 1906 d. 22 Nov 1988
Frances Eileen Hancock
b. 9 Aug 1906 d. 7 Mar 1996
12
Marion Elizabeth Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.1.1]
12
Donald Lawrence Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.1.2]
b. 1934 d. 2009
11
Archibald Richard Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.2]
b. 13 Aug 1913
Elnora Madeline Blakely
b. 18 May 1917 d. 23 Mar 1972
12
April Elenora Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.2.1]
12
Melody Ann Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.2.2]
11
Sarah Myrtle Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.3]
b. 3 Jan 1911 d. 31 Mar 1983
Eric James Courtice
b. 23 May 1906 d. 31 Mar 1983
12
Archibald Frederick Courtice
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.3.1]
12
Carol Ann Courtice
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.3.2]
12
Charlotte Mary Courtice
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.3.3]
11
Alexander Thomson Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.4]
b. 9 Dec 1918
+
Irma Mildred Metcalfe
b. 27 Oct 1927
11
Bruce Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.5]
b. 17 May 1916
11
Robert Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.6]
b. 2 Dec 1922 d. 18 Jan 1996
Gwendolyn Osborne
b. 17 May 1927 d. 24 Jun 1950
12
Gail Patricia Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.6.1]
12
Heather Louise Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.6.2]
12
Linda Diane Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.6.3]
12
Scott Richard Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.6.4]
11
Archibald Loane Muir
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.2.7]
b. Dec 1909 d. Jul 1910
10
Bertha Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.3]
b. 13 Jul 1880 d. 16 Dec 1880
10
Anna Myrtle Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.4]
b. 9 Oct 1892 d. 17 Jan 1968
Marshall Fitchett
b. 17 Jun 1892 d. 8 Mar 1963
11
Helen Marie Fitchett
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.4.1]
b. 5 Aug 1920
+
Joseph Walter Scrivens
b. 15 Feb 1918
11
Arthur Bruce Fitchett
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.4.2]
b. 26 Sep 1918
+
Ethel Marnock
11
Malcom Simeon Fitchett
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.4.3]
b. 3 Nov 1922
+
Mary Blair Spencer
11
John Richard Fitchett
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.4.4]
b. 22 Jul 1924
+
Doris Laird
10
Mabel Rebecca Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.5]
b. 15 Apr 1888 d. 16 Jul 1963
George Fortune MacDonald
b. 13 Dec 1885 d. 3 Jan 1940
11
Margaret Jean MacDonald
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.5.1]
b. 3 Aug 1924
+
Robert Ray Boulware
b. 23 Jun 1919
11
George Thomson MacDonald
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.5.2]
b. 19 Dec 1927
10
Verna Florence Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.6]
b. 19 Oct 1895
+
Gordon Ezekiel Vance
b. 4 Jul 1895 d. 1979
10
David Bruce Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.1.7]
b. 30 Oct 1885 d. 14 Sep 1949
9
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.2]
b. 11 Mar 1852 d. 10 Sep 1937
William Green
b. 19 Mar 1848 d. 3 May 1917
10
Margaret Edith Green
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.1]
b. 24 Feb 1876 d. 27 Jul 1945
John Wesley Walton
b. 6 Oct 1876 d. 5 Jan 1947
11
Eva Walton
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.1.1]
11
William Guy Walton
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.1.2]
b. 1 Dec 1919
+
Ethel Elizabeth Gibb
b. 1917 d. 1976
11
Jean Walton
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.1.3]
Clarence Wallace
12
Kenneth Wallace
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.1.3.1]
12
Carol Wallace
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.1.3.2]
12
Norma Wallace
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.1.3.3]
10
James Arthur Green
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.2]
b. 10 Jul 1878 d. 18 May 1879
10
Florence Hamilton Green
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.3]
b. 23 Apr 1884 d. 12 Nov 1971
Robert Ashbridge McCowan
b. 13 Apr 1886 d. 11 Apr 1963
11
Walter McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.3.1]
b. 25 Feb 1920
+
Mary Nickerson
b. 2 Jul 1918
11
Frank Ashley McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.3.2]
b. 9 Nov 1925 d. 15 Feb 1984
+
Elizabeth (Betty) Coutts
10
Herbert Allan Green
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.4]
b. 2 Jan 1887 d. 14 Apr 1958
10
Walter Thomson Green
[1.1.1.1.1.1.4.1.2.5]
b. 8 Aug 1880 d. 1 Nov 1909
9
Isaac Whiteford Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.3]
b. 1854
Margaret Ellen Gibb
10
Roy Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.3.1]
10
Stewart Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.3.2]
Minnie Taylor
11
Betty Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.3.2.1]
9
Henry Utrech Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.4]
b. 12 Jul 1865 d. 1944
+
Alice Jane Richardson
b. 23 Feb 1875
9
Arthur Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.5]
b. Jun 1859 d. 4 Oct 1863
9
Rebecca Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.1.6]
b. 1 Sep 1862 d. 9 Aug 1948
Hulbert Booth
b. 22 Dec 1865 d. 23 Oct 1946
10
Mabel Booth
[1.1.1.1.1.1.4.1.6.1]
b. 15 Mar 1898 d. 3 May 1990
+
Leslie R. Green
b. Abt 1899
8
Amos R Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 17 Jun 1824 d. 8 Jan 1908
Margaret Rae
b. 1829 d. 9 Aug 1860
9
Agnes Hamilton Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 26 Aug 1856 d. 28 Dec 1928
John Kennedy
b. 28 Apr 1854 d. 26 May 1917
10
Amos Egbert Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.1]
b. 27 Jun 1886 d. 14 Jul 1954
Janet Mabel Weir
b. 23 Oct 1889 d. 20 Jun 1981
11
John Egbert Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.1.1]
b. 6 Dec 1925 d. 9 Jan 1995
Shirley Ellen Brooks
b. 2 Jul 1930 d. Aft 1973
12
Lynda Jeanne Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.1]
12
Glen David Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.2]
12
Murray Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.3]
12
Andrew John Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.4]
b. 24 Apr 1962 d. 8 Jul 1970
12
Elaine Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.5]
12
Mary Ellen Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.1.1.6]
10
Margaret Rae Clark Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2]
b. 15 Jun 1891 d. 9 May 1959
James Scott
b. 3 Apr 1874 d. 29 Dec 1941
11
George William Scott
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.2.1]
b. 1920 d. 1992
+
Shirley Barrett
10
John David Thomson Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.3]
b. 23 Sep 1897 d. 5 Dec 1971
Margaret Bell
b. 19 Dec 1900 d. 21 Mar 1965
11
Elizabeth Agnes Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.3.1]
b. 1924 d. 1995
+
Frederick William Tapscott
11
Jean Hamilton Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.3.2]
b. 5 Mar 1930
Kenneth Herbert John Campbell
b. 2 Feb 1922
12
Kimberlie Margaret Ann Campbell
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.3.2.1]
[
=>
]
12
Carolyn Norma Jean Campbell
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.3.2.2]
[
=>
]
12
Kathryn Kennedy Campbell
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.3.2.3]
[
=>
]
12
Colin Kenneth John Campbell
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.3.2.4]
11
Margaret Isabel Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.3.3]
+
Dr. Allan Angus McNab
10
Dr. William Thomson Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4]
b. 13 Mar 1884 d. 8 Jul 1965
Janet Gordon Camps
b. Abt 1888
11
Martha Clark Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4.1]
Robert Brady
12
William Scott Brady
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4.1.1]
11
Agnes Hamilton Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4.2]
b. 28 Aug 1927 d. Aug 1993
Deforest Thompson Whipple
b. 4 May 1916 d. 2 Oct 1995
12
Dianne King Whipple
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4.2.1]
12
William Thomson Whipple
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4.2.2]
11
Janet Gordon Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.4.3]
+
James Benedict
10
Rev. Samuel Arthur Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.5]
b. 10 Dec 1888 d. 10 Dec 1974
Hannah Lavina McCutcheon
b. 15 Sep 1892
11
Allan Cameron Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.5.1]
11
Murray John Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.5.2]
b. Abt 1923 d. 1992
10
Agnes Isabella Kennedy
[1.1.1.1.1.1.4.2.1.6]
b. 18 Aug 1895 d. 6 Oct 1949
+
Garnet Day
b. Abt 1891
9
Harriet Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 20 Jun 1858 d. Aft 31 Mar 1901
James Alexander Reid
b. 10 Sep 1844
10
Margaret Rae Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.1]
b. 22 Apr 1883 d. 1894
10
Janet Hamilton Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2]
b. 24 Apr 1884 d. 27 Mar 1953
John Andrew Brignall
b. 23 Oct 1878 d. 3 Feb 1953
11
James Brignall
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.1]
b. 7 Feb 1912
11
Mary Isabella Brignall
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.2]
b. 17 Sep 1905
William Samuel Cammack
b. 13 Jan 1890 d. 5 Jan 1966
12
John Rae Cammack
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.2.1]
12
Joyce Mary Jeanette Cammack
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.2.2.2]
10
Robert Amos Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.3]
b. 14 Jun 1887
Helen Wallace Duncan
b. Abt 1893
11
Helen Mavis Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.1]
Alfred Desjardins
12
Francis Alfred Desjardins
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.1.1]
12
Robert Aurel Desjardins
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.1.2]
11
Janet Evelyn Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.2]
Martin Rudolf Schultz
12
Rudolf Martin Schultz
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.2.1]
12
Helen Janet Schultz
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.3.2.2]
10
William Oliver Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.4]
b. 24 Jul 1889
10
Archibald Gordon Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.5]
b. 9 Sep 1891
10
James Alexander Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.6]
b. 26 Jan 1894
10
Gordon Rae Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.7]
b. 23 May 1896 d. 1910
10
John Hamilton Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.8]
b. 18 Dec 1897
10
Walter Andrew Reid
[1.1.1.1.1.1.4.2.2.9]
b. 26 Jul 1902
Isabella Brownlie
b. 20 Dec 1834 d. 1924
9
Jane Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 18 Jul 1862 d. 14 Dec 1934
9
Richard Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 27 Feb 1865 d. 26 Mar 1923
9
John Mark Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 19 Sep 1867 d. 1919
9
Abigail Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.6]
b. 9 May 1870 d. 1954
9
Isabella Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.7]
b. 16 May 1874 d. Dec 1969
David James Davidson
b. 1873 d. 1943
10
Donald Arthur Davidson
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.1]
b. 1910 d. 24 Jun 1959
10
Pte. Gordon Brownlie Davidson
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.2]
b. 1913 d. 1943
10
Kathleen Isabel Davidson
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.3]
b. 1905 d. 1975
Walter Bruce Gibson
b. 1903 d. 1977
11
William David Gibson
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.3.1]
b. 7 Apr 1929
11
Richard Murray Gibson
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.3.2]
11
Nancy Patricia Gibson
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.3.3]
William David McGee
12
Karen Patricia McGee
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.3.3.1]
12
Peter Allen McGee
[1.1.1.1.1.1.4.2.7.3.3.2]
9
Arthur Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.8]
b. 7 Dec 1875 d. 30 Aug 1953
Alice Isabella Ball
b. Abt 1891
10
David Arthur Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.1]
10
Richard Servos Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.2]
Noelle Jackson
11
Janet Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.2.1]
11
Ian Servos Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.2.2]
11
David Gilbart Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.2.3]
11
Alan Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.8.2.4]
9
Mary Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.2.9]
b. 15 Nov 1873 d. 6 Jan 1949
8
Richard R. Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 28 Mar 1827 d. 26 May 1914
Helen Dimma
b. 1826 d. 25 Aug 1885
9
Richard W Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 10 Apr 1853
9
Christina Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.2]
b. 21 Jul 1855 d. 24 Nov 1937
+
John Raeside Crawford
b. 13 Mar 1852 d. 12 Apr 1882
9
James Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3]
b. 31 Aug 1857 d. 8 Dec 1904
Mary French
b. 5 Dec 1864 d. 27 Jun 1948
10
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.1]
b. 29 Nov 1891
Nellie Grant
11
James Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.1.1]
Jean
12
Ronald Grant Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.1.1.1]
12
Margaret Joy Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.1.1.2]
11
Patricia Jean Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.1.2]
10
Robert James Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.2]
b. 31 Oct 1893
Maude Frances College
d. 1 Sep 1966
11
Gertrude May Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.2.1]
Robert Tiffon
12
Sandra Tiffon
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.2.1.1]
11
James Herbert Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.2.2]
11
Shirley Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.2.3]
Robert Steadman
12
Robert Steadman
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.2.3.1]
10
Janet Rae Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.3]
b. 27 Feb 1896
Edward J. Marshall
11
Mary Kate Marshall
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.3.1]
+
Donald Coulter
10
Helen Christine Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.4]
b. 22 Apr 1898 d. 5 Jan 1967
Andrew Grant
b. 29 Jul 1896 d. 9 Jul 1984
11
Ray Ross Grant
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.4.1]
10
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.5]
b. 9 Dec 1900
11
John Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.5.1]
b. 1923 d. 5 Jan 1953
Kathaleen Mertz
12
Michael John Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.3.5.1.1]
9
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.4]
b. 1860
9
David Henry Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5]
b. 25 Jun 1865 d. 28 Dec 1901
Sarah
b. 1865
10
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.1]
b. 1886
10
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.5.2]
b. 1887
9
Cessford Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.6]
b. 30 Aug 1869 d. 1947
+
Mary Alma Richardson
b. 29 Jun 1879 d. 1949
9
Agnes Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.7]
b. 21 Jan 1863 d. Bef 1928
William Kelly
b. 15 Oct 1855 d. 1 Jan 1928
10
Alexander Cessford Kelly
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.1]
b. 1 Oct 1897
10
Richard Gordon Kelly
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.2]
b. 1 Jan 1899 d. 1972
+
Flossie Louise Daly
b. 3 May 1900 d. 1985
10
Flossie Daly Kelly
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.3]
b. 1901 d. Bef 1928
10
William Norman Kelly
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.4]
b. 2 Apr 1904
10
Christina Helen Kelly
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.5]
b. 16 Jan 1903
John William Mathews
b. 1904
11
William Henry Mathews
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.5.1]
11
John Edward Mathews
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.5.2]
11
Douglas Richard Mathews
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.5.3]
11
Donald George Mathews
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.5.4]
11
Christina Margaret Joan Mathews
[1.1.1.1.1.1.4.3.7.5.5]
9
Robert S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.3.8]
b. 1870
8
Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 1828 d. 1 Jun 1900
Elizabeth Bell
b. 1831 d. 21 Aug 1897
9
Isabella Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 6 May 1855 d. Aft 31 Mar 1911
Robert Green
b. 5 Feb 1853 d. 14 Feb 1914
10
Elizabeth Bell Green
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1]
b. 27 Sep 1878 d. 5 Nov 1968
Robert Martin
b. 11 Aug 1875 d. 1948
11
David Hamilton Martin
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.1]
Minnie Irene Hancock
12
Elizabeth Irene Martin
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.1.1]
12
Donald David Martin
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.1.2]
11
Robena Isabelle Martin
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.2]
Robert Austen Scott
12
Robert J. Scott
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.2.1]
12
David Carlyle Scott
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.2.2]
11
Janet Evelyn Martin
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.3]
William Hancock
12
Margaret Olive Hancock
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.3.1]
12
Janet Marilyn Hancock
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.3.2]
11
Margaret Winifred Martin
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.4]
b. 29 May 1915 d. 25 Jul 2004
Donald Douglas Marr
b. 29 May 1915 d. 1 Dec 2004
12
Catherine Janice Marr
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.4.1]
12
Ian Marr
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.1.4.2]
10
Agnes Hamilton Green
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2]
b. 26 Nov 1881 d. 1940
Herbert John Stobo
b. 19 Oct 1874 d. 6 May 1949
11
Isabel Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.1]
b. Aft 1904 d. 1905
11
Robert Mervin Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.2]
d. 1962
Margaret Rice
12
John Leonard Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.2.1]
12
Robert Marvin Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.2.2]
11
Douglas Herbert Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.3]
d. 1984
Margaret Coleman
12
Marjorie Agnes Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.3.1]
+
Margaret Stoddart
11
Marion Grace Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.4]
Elmer George Stoddart
12
Beverly Ann Stoddart
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.4.1]
11
John Ray Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.5]
Eileen
12
Brian Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.5.1]
12
Heather Marie Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.5.2]
12
Rosaline Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.5.3]
12
Caroline Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.5.4]
11
Lester Campbell Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.6]
Margaret
12
Robin Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.6.1]
12
Ina Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.6.2]
12
Gerald Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.6.3]
12
Timothy Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.6.4]
12
Elizabeth Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.6.5]
12
Robert Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.6.6]
11
Mildred Bernice Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.7]
d. 1987
Clayton Hawkins
d. 1962
12
Patrick Hawkins
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.7.1]
11
Elizabeth Jean Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.8]
Frank Tucker
12
Ronald Tucker
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.8.1]
12
Bradley Tucker
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.8.2]
11
Gwendolyn Mabel Stobo
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.9]
Donald Dove
12
Deborah Dove
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.9.1]
12
Douglas Dove
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.9.2]
12
Colleen Dove
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.9.3]
12
John Dove
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.2.9.4]
10
Ethel May Green
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.3]
b. 8 Nov 1883 d. 20 Feb 1905
10
Gordon Smith Green
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.4]
b. 28 Oct 1885 d. 27 Sep 1908
10
Rubena (Ruby) Green
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5]
b. 10 Feb 1888 d. 1966
George McFarlane
b. 1881 d. 1938
11
John Stuart McFarlane
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.1]
b. 1914
+
Emeline (Emily) Burton
d. 1980
11
Jean Isabel McFarlane
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.2]
b. 1917 d. 1974
Harkness W. (Harry) Black
12
Kathleen Patricia Black
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.2.1]
12
Ruth Margaret Black
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.2.2]
12
Maureen Jean Black
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.2.3]
11
Robert Grant McFarlane
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.3]
b. 1920 d. 1955
Daisey Elizabeth Dobush
12
Liana Elizabeth McFarlane
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.3.1]
11
Rubena Helen McFarlane
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.4]
b. 1928
Ray Wilbur Davis
12
Brian Andrew Davis
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.4.1]
b. 1962 d. 1990
12
Kathy Darlene Davis
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.4.2]
12
Kelly Glenn Davis
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.5.4.3]
10
Margaret Isabella Green
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.6]
b. 13 May 1890 d. 23 Aug 1891
10
Mabel Green
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.7]
b. 1 Feb 1893 d. 1918
George Wood
b. 5 Jul 1891
11
Murray George Wood
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.1]
b. 16 Jul 1915
Marybelle Matheson
b. 25 Nov 1919
12
Ronald Marvin Wood
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.1.1]
[
=>
]
12
Carol Maureen Wood
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.1.2]
[
=>
]
11
Campbell Robert Wood
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.2]
b. 5 Nov 1917
Marie Isabel Mould
b. 14 Feb 1918
12
Jean Mabel Wood
[1.1.1.1.1.1.4.4.1.7.2.1]
[
=>
]
9
Richard S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2]
b. 8 Sep 1855
Janet MacGregor
b. 8 Jan 1861
10
Frank Valentine Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.1]
b. 14 Feb 1883
10
Mabel MacGregor Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.2]
b. 26 Dec 1885
+
Raymond Sparling
10
Frederick Bell Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.3]
b. 11 Dec 1886
Madeline Allan
11
Frank Bell Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.3.1]
Katherine Elizabeth Ferguson
12
Pamela Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.3.1.1]
12
Peter Bell Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.3.1.2]
11
Katherine Mack Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.3.2]
+
Dr. James Alfred Berkeley
10
Norman Keith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.4]
b. 19 May 1889 d. 8 Apr 1960
Ruby V. Hill
11
Richard Keith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.4.1]
d. 31 Mar 1944
11
George Douglas Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.4.2]
Lillian Gwendolyn Laycock
12
Richard Keith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.4.2.1]
11
Eleanor Joan Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.4.3]
b. 21 May 1923 d. 11 Sep 2001
+
Theodore William Forshiner
b. 4 May 1920 d. 1999
11
Robert Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.4.4]
10
Ella Irene Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.5]
b. 29 Apr 1891
Horace Ashley Ireland
11
Charles Edward Ireland
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.5.1]
Joan Winnifred Sutton
12
Patricia Mary Ireland
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.5.1.1]
11
Edith Irene Ireland
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.5.2]
+
John Paton
11
Janet Madeline Ireland
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.5.3]
George Mason Hallworth
12
Janis Irene Hallworth
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.5.3.1]
12
Gerald Allen Hallworth
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.5.3.2]
10
Douglas Earl Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.6]
b. 13 Oct 1892
Wilma McKenzie
11
Donald McKenzie Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.6.1]
11
Janet Sybelle Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.6.2]
11
James Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.6.3]
Edith Eliza Hughes
b. Abt 1877
10
Donald Harvey Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.7]
Helen Mary Armstrong
11
Carol Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.7.1]
11
William Richard Douglas Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.7.2]
11
Donald Arden Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.7.3]
10
Edith Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.8]
Richard Mungen
11
Elizabeth Jane Mungen
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.8.1]
11
Mary Lou Mungen
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.8.2]
11
Katherine Ann Mungen
[1.1.1.1.1.1.4.4.2.8.3]
+
Daisey Ellen Dennis Rowley
9
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.4.3]
b. 20 Dec 1859 d. 21 Jan 1921
David Brown
b. 4 Dec 1849 d. 10 May 1926
10
Elizabeth Maude Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.1]
b. Jan 1880 d. 17 Aug 1887
10
Francis Jeffery Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.2]
b. 1 Nov 1881 d. 16 Aug 1887
10
Margaret Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.3]
b. 9 May 1883 d. 30 May 1887
10
Catherine Crone Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.4]
b. 4 Jun 1884 d. 1964
Frederick Justus Anderson
b. 1879 d. 1931
11
Frederick Justus (Ricky) Anderson
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.4.1]
b. 1913 d. 31 Aug 1993
Elizabeth Brenda Osborne
12
Frederick Justus Anderson
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.4.1.1]
12
John David Anderson
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.4.1.2]
10
Ettabell Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.5]
b. 10 May 1886 d. 1966
+
Samuel James Marshall
b. 1893 d. 1926
10
David Campbell Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.6]
b. 5 Feb 1888 d. 1940
10
William Stuart Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.7]
b. 22 May 1889 d. 24 Jul 1908
10
Thomas Egbert Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.8]
b. 23 Jun 1891 d. 1957
Hildred McLeod
11
Dorothy Ann Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.8.1]
Bert O'Neal
12
David O'Neal
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.8.1.1]
+
Mildred Retafuse
10
Robert Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.9]
b. 3 Sep 1893 d. 7 Sep 1893
10
Bessie Allison Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.10]
b. 14 Jun 1894 d. 7 May 1965
William Corsline Kotchapaw
b. 28 Jun 1891 d. 5 Oct 1971
11
Margaret Sarah Kotchapaw
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.10.1]
b. 10 Oct 1918 d. Mar 1991
Dr. Robert Walker McNeil
b. 27 Apr
12
Martha Lyle McNeil
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.10.1.1]
12
Robert William McNeil
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.10.1.2]
11
Marion Grace Kotchapaw
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.10.2]
b. 8 Sep 1921
Allen Thomas Lambert
b. 28 Dec 1911 d. 2002
12
William Allen Lambert
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.10.2.1]
11
William John Kotchapaw
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.10.3]
b. 21 Nov 1924 d. 1944
11
Betty Catherine Kotchapaw
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.10.4]
b. 5 May 1927 d. 8 Oct 2004
+
Alan Douglas Laing
b. 2 Dec 1926
11
Vesta Alison Kotchapaw
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.10.5]
b. 4 Apr 1930
+
Douglas Randall English
b. 4 Jun 1928
10
Marjorie Isabel Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.11]
b. 15 Aug 1896 d. 21 Jun 1915
10
Margaret Thomson Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.12]
b. 27 Mar 1900 d. 1950
John Struthers Strang
11
Ruth Harriet Strang
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.12.1]
11
David Struthers Strang
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.12.2]
10
Marion Agnes Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.13]
b. 8 Jul 1902 d. 5 Nov 1943
Harvard Browning Davey
b. 27 Feb 1901 d. 20 Jul 1969
11
John Harvard Davey
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.13.1]
b. 24 Feb 1926
+
Marion Louise Nickolson
b. 20 Nov 1933
11
Barbara Marion Davey
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.13.2]
b. 12 Aug 1927
+
Alexander Martin Fisfer Mahood
b. 30 Jul 1923
11
Margaret Florence Davey
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.13.3]
b. 26 Dec 1929
10
John Kenneth Brown
[1.1.1.1.1.1.4.4.3.14]
b. 4 Jul 1903 d. 1980
+
Rebecca Marshall
b. 1903
8
William R. Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 10 Mar 1834 d. 28 Oct 1903
Violet Henderson Brown
b. 25 Apr 1843 d. 8 Aug 1908
9
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.1]
b. 12 May 1864 d. 23 Sep 1925
Eva Barker
b. 10 Sep 1863 d. 5 Oct 1940
10
Alice Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.1]
b. 16 Feb 1894
10
William Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.2]
b. 19 Nov 1896 d. 26 Oct 1945
Irene Furze
b. 1896 d. 1924
11
Lionel Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.2.1]
b. 13 Dec 1916
Mary Helen McGarry
b. 15 Aug 1910
12
Patricia Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.2.1.1]
11
Shirley Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.2.2]
b. 1924
John Peter Hill
12
Chris Hill
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.2.2.1]
12
Peter Hill
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.2.2.2]
12
Alison Hill
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.2.2.3]
+
Gertrude Camplin
10
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.3]
10
Alexander Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.4]
Marion Drake
11
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.1.4.1]
9
Marion Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.2]
b. 1866
James O'Connor
b. 1861
10
Violet O'Connor
[1.1.1.1.1.1.4.5.2.1]
10
Sara O'Connor
[1.1.1.1.1.1.4.5.2.2]
10
John O'Connor
[1.1.1.1.1.1.4.5.2.3]
9
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.3]
b. 1868
9
Frank Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.4]
b. 1871
9
Egbert Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.5]
b. 1872 d. 13 Mar 1907
9
Agnes Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.6]
b. 1876
Everett R. Goodhand
b. 1875
10
Violet F. Goodhand
[1.1.1.1.1.1.4.5.6.1]
9
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.7]
b. 1878
9
Violet Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.5.8]
8
James Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.6]
b. 29 Dec 1839 d. 6 Nov 1924
Agnes Davidson
b. 7 Oct 1845
9
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.6.1]
b. 26 Feb 1873
9
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.6.2]
b. Jun 1875 d. 3 Apr 1887
9
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.6.3]
b. 1876
9
Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.6.4]
b. 9 May 1879
+
Lena May Gibb
b. Abt 1880
9
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.6.5]
b. 28 Jul 1880
Charles Wishart
10
Glen Robert Wishart
[1.1.1.1.1.1.4.6.5.1]
9
Charles Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.6.6]
b. 29 Mar 1883
9
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.6.7]
b. 17 Jun 1885
Thomas Wishart
10
James Wilford Wishart
[1.1.1.1.1.1.4.6.7.1]
10
Doris Isabella Wishart
[1.1.1.1.1.1.4.6.7.2]
Gordon Mathew Dow
11
Gordon Murray Dow
[1.1.1.1.1.1.4.6.7.2.1]
10
William Keith Wishart
[1.1.1.1.1.1.4.6.7.3]
10
Laura Jean Wishart
[1.1.1.1.1.1.4.6.7.4]
10
Murray Douglas Wishart
[1.1.1.1.1.1.4.6.7.5]
10
Walter Lloyd Wishart
[1.1.1.1.1.1.4.6.7.6]
8
Abigail Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 4 Apr 1843 d. 19 Oct 1905
William Underwood
b. Apr 1835 d. 14 Nov 1894
9
Harriet Underwood
[1.1.1.1.1.1.4.7.1]
b. 13 Nov/Oct 1878 d. 6 Jul 1893
9
Catherine Elizabeth Underwood
[1.1.1.1.1.1.4.7.2]
b. 15 Apr 1881 d. 22 May 1947
+
John Tidball
b. 28 Mar 1872 d. 13 Jul 1949
9
Jane Underwood
[1.1.1.1.1.1.4.7.3]
b. 15 Jun 1883 d. 13 Aug 1971
+
Peter W. Spring
b. 31 Oct 1876 d. 11 Feb 1962
9
Archibald Underwood
[1.1.1.1.1.1.4.7.4]
b. 21 Feb 1885 d. 26 Apr 1926
Carrie Luella Miles
b. 28 Jan 1890 d. 4 Feb 1980
10
Jean Underwood
[1.1.1.1.1.1.4.7.4.1]
b. 18 Jul
Thorton Bell
11
Nancy Jean Bell
[1.1.1.1.1.1.4.7.4.1.1]
11
Robert Bell
[1.1.1.1.1.1.4.7.4.1.2]
8
John Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.8]
b. 31 Dec 1836 d. 3 Jul 1886
Agnes Brown
b. 14 May 1839 d. 27 Sep 1875
9
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.8.1]
b. 14 Nov 1860 d. 3 Jun 1914
George McCowan
b. 9 Apr 1851 d. 9 Jul 1903
10
James Thomson McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.8.1.1]
b. 16 May 1888 d. 31 Aug 1888
10
John Alexander McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.8.1.2]
b. 26 Dec 1889 d. 14 Apr 1890
10
Agnes Marion McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.8.1.3]
b. 12 Jun 1893 d. 1895
10
Mary Bena McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.8.1.4]
b. 19 Apr 1900 d. 23 Feb 1905
10
Dr. William Porteus McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.8.1.5]
b. 7 Feb 1891 d. 1930
Vera Jane Schmidlin
b. 1892 d. 1976
11
Elizabeth McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.8.1.5.1]
William Thomas
12
William McCowan Thomas
[1.1.1.1.1.1.4.8.1.5.1.1]
11
George McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.8.1.5.2]
10
Martha Jane McCowan
[1.1.1.1.1.1.4.8.1.6]
b. 8 Sep 1896 d. 27 Jun 1929
+
Dr. Alexander Mahaffy
9
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.8.2]
b. 24 Jun 1862
Henry Wheler
b. 28 Dec 1856
10
Agnes Mabel Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1]
b. 14 Sep 1886
Reginald L. Jordon
11
Gersha Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.1]
Myrtle Campbell
12
Gail Wayne Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.1.1]
12
Rose Lyle Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.1.2]
12
Garry Rodger Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.1.3]
11
Fred A. (Gus) Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.2]
Marion Lymes
12
Teresa Ann Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.2.1]
12
Vernon Frederick Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.2.2]
11
Wilma Elinor Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.3]
H Dinsdale
12
Linda Dinsdale
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.3.1]
11
Donald Rodney Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.4]
11
Mabel Joan Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.5]
William Potter
12
Nicholas Potter
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.5.1]
11
Emily Lucille Jordon
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.1.6]
10
Charles Perryman Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.2]
b. 11 Sep 1889
10
Olive M. Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.3]
b. 16 Jun 1892
10
Margaret Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.4]
Ernest Hutchinson
11
Irene Hutchinson
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.4.1]
Kenneth Robertson
12
Ronald Robertson
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.4.1.1]
12
Lawrence Robertson
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.4.1.2]
12
Ian Robertson
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.4.1.3]
10
Frederick G. Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.5]
b. 31 Dec 1895
10
Alfred G. Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.6]
b. 3 Jan 1898
Nellie Roberts
11
Audrey Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.6.1]
11
Elliot Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.6.2]
11
Margaret Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.6.3]
11
Gordon Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.6.4]
11
Arnold Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.6.5]
10
William H. Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.7]
b. 13 Jan 1899
Florence Baxter
11
Milton Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.7.1]
11
Marlene Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.7.2]
11
Judith Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.7.3]
10
Marion Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.8]
+
Roy Gates
10
Jean Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.9]
Arthur Caldwell
11
Marion Caldwell
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.9.1]
Barney Baines
12
Patrick Baines
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.9.1.1]
11
Gerald Caldwell
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.9.2]
11
Ronald Caldwell
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.9.3]
11
Marjorie Caldwell
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.9.4]
11
Edwin Caldwell
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.9.5]
10
Ruby M. Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.10]
b. 1 Jul 1894
10
Arnold Thomson Wheeler
[1.1.1.1.1.1.4.8.2.11]
b. 16 Feb 1888
9
Marion Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.8.3]
b. 30 Aug 1865
Dr. John Alfred Deyell
b. 1865
10
Margaret Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.3.1]
d. 1949
Geoffrey Castleden
11
Marion Jean Castleden
[1.1.1.1.1.1.4.8.3.1.1]
11
Donald Hugh Castleden
[1.1.1.1.1.1.4.8.3.1.2]
10
Marion Thomson Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.3.2]
Marshall Richmond Smith
11
Douglas Smith
[1.1.1.1.1.1.4.8.3.2.1]
11
John (Jack) Smith
[1.1.1.1.1.1.4.8.3.2.2]
9
Abigail Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.8.4]
b. 1871
William T A Deyell
b. Abt 1864
10
John Thomson Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.1]
Violet LeGros
11
Doreen Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.1.1]
+
Nelles G. Fallis
11
William John Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.1.2]
11
James William Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.1.3]
11
Gerald Thomson Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.1.4]
10
Frederick James Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.2]
Elizabeth Cook
11
Joan Kathaleen Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.2.1]
+
Kenneth Bond
10
Mary Agnes Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.3]
Francis John Whitefield
11
Garnet Thomson Whitefield
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.3.1]
Jessie Murney
12
Gloria Elizabeth Whitefield
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.3.1.1]
11
Eleanor Mary Whitefield
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.3.2]
11
Frances Neal Whitefield
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.3.3]
11
Marion Bell Whitefield
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.3.4]
+
Ray Bothwell
10
Florence Marion Deyell
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4]
Harold James Hubbard
11
Norman Alfred Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.1]
11
Earl Ray Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.2]
11
Marjory Elizabeth Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.3]
+
Osborne Thomas Ruck
11
Marion Ethelda Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.4]
11
Wilma Henriette Gertrude Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.5]
11
Eva Mae Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.6]
11
Ida Jean Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.7]
11
Florence Joan Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.8]
11
Janet Hazel Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.9]
11
George Harold Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.10]
11
Ronald Henry Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.11]
11
Roy James Hubbard
[1.1.1.1.1.1.4.8.4.4.12]
9
Dr. John Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.8.5]
b. 1874 d. 31 Oct 1955
Janet Glendinning Paterson
b. 11 Apr 1872 d. 11 Nov 1953
10
Helen Agnes Dr. Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.8.5.1]
b. 5 Mar 1909 d. 17 Jan 1956
Karl Klanfer
11
John Klanfer
[1.1.1.1.1.1.4.8.5.1.1]
10
Margaret Glendinning Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.8.5.2]
b. Aft 1903
9
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.4.8.6]
b. Oct 1870 d. Feb 1871
7
Archibald D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.5]
b. 2 Aug 1796 d. 27 Dec 1877
Hannah Walton
b. 4 Jan 1801 d. 11 Apr 1886
8
Jennet Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 30 Mar 1823 d. 26 May 1896
George Evans
b. 1816
9
Archibald Evans
[1.1.1.1.1.1.5.1.1]
9
Robert Evans
[1.1.1.1.1.1.5.1.2]
b. 1850
Annie Bean
b. 1853
10
Ernest Evans
[1.1.1.1.1.1.5.1.2.1]
10
Wesley Evans
[1.1.1.1.1.1.5.1.2.2]
10
George Evans
[1.1.1.1.1.1.5.1.2.3]
10
Isabella Evans
[1.1.1.1.1.1.5.1.2.4]
b. 1890
+
Edwaed A. Shortt
b. Abt 1885
10
Harriet Evans
[1.1.1.1.1.1.5.1.2.5]
b. 1878
8
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 30 Mar 1823 d. 27 Nov 1851
Fullerton Gibson
b. 30 Apr 1825 d. 23 May 1912
9
Mary Gibson
[1.1.1.1.1.1.5.2.1]
b. Abt 1852
Adam Richardson
b. 1 Nov 1846
10
Mary Isabella Richardson
[1.1.1.1.1.1.5.2.1.1]
b. 3 Oct 1876
10
Frances E. Richardson
[1.1.1.1.1.1.5.2.1.2]
b. 2 Oct 1878
10
Margaret Winnifred Richardson
[1.1.1.1.1.1.5.2.1.3]
b. 24 Mar 1883
10
Alice Jane Richardson
[1.1.1.1.1.1.5.2.1.4]
b. 23 Feb 1875
+
Henry Utrech Thomson
b. 12 Jul 1865 d. 1944
9
James Gibson
[1.1.1.1.1.1.5.2.2]
b. 4 Mar 1850 d. Aft 31 Mar 1901
Martha Jane Walton
b. 17 Feb 1855
10
Mary Jane Gibson
[1.1.1.1.1.1.5.2.2.1]
b. 15 Dec 1880
10
Alletta G. Gibson
[1.1.1.1.1.1.5.2.2.2]
b. 16 Oct 1887
Harold George Bent
b. 1889
11
Florence Bent
[1.1.1.1.1.1.5.2.2.2.1]
b. 27 Apr 1915
Cecil Forrest
b. 1913
12
Carole Forrest
[1.1.1.1.1.1.5.2.2.2.1.1]
8
Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.3]
b. 15 Mar 1828 d. 4 Apr 1915
David Pherrill
b. 1824 d. 5 Mar 1896
9
David Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.1]
b. 1 Jun 1862 d. 24 Feb 1963
9
Mary Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.2]
b. Feb 1853 d. 15 Mar 1854
9
Stephen Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.3]
b. 2 Dec 1850 d. 11 Jan 1915
9
James Albert Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4]
b. 17 Jan 1861 d. 10 Apr 1931
Isabella Thomson
b. 2 Mar 1871 d. 8 Jul 1948
10
David James Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.1]
b. 13 Sep 1889 d. 5 Jan 1965
Kate Fudge
11
David Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.1.1]
b. 15 Jul 1931
10
Charles Frederick Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.2]
b. 29 Aug 1893 d. 16 Jun 1967
Violet May Burgess
b. Abt 1897
11
Ruth Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.2.1]
b. 10 Feb 1917
+
William Cooper
11
Georgina Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.2.2]
b. 5 Mar 1919
+
Robert Charles Chiddenton
11
Isabella Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.2.3]
b. 16 Aug 1921
+
David Jeffrey
11
Alberta Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.2.4]
b. 7 Jan 1929
+
James E. Spicer
10
Arthur George Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.3]
b. 18 Nov 1895
Ethel May Ball
b. Abt 1897
11
Nelda Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.3.1]
b. 27 Apr 1916
+
George Miller
11
Lorraine Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.3.2]
b. 6 Oct 1923
+
Donald Giddings
11
John Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.3.3]
b. 22 May 1930
10
Mary Isabella Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.4]
b. 20 Jun 1897 d. 1982
Fred Bennett
b. Abt 1894
11
Arthur Bennett
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.4.1]
b. 29 Dec 1915
11
Marie Bennett
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.4.2]
b. 31 Jul 1917
+
William McNalley
11
Pherrill Bennett
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.4.3]
b. 15 Sep 1924
+
Ruth Ellen McGowan
10
Albert Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.5]
b. 12 Apr 1899 d. Jan 1901
10
Andrew Thomson Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.6]
b. 12 Apr 1899 d. 1974
Eva Corbett
b. 30 May 1898
11
Alexander Thomson Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.6.1]
b. 10 Feb 1929 d. 3 Feb 2020
11
Ronald Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.6.2]
b. 15 May 1932
11
Harold Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.6.3]
11
Paul Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.4.6.4]
9
Archibald George Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.5]
b. 6 Aug 1858 d. 8 Jan 1916
Mary Margaret Leslie
b. Abt 1863 d. Bef 1901
10
Hannah Amelia Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.5.1]
b. 17 Nov 1881 d. 1 Feb 1960
Thomas Thomson Walton
b. 27 Apr 1873 d. 4 Feb 1953
11
Hazel Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.5.1.1]
b. 2 Jul 1904
Harold F. Evans
b. 31 Mar 1901 d. 11 Nov 1952
12
Margaret Evans
[1.1.1.1.1.1.5.3.5.1.1.1]
9
Thomson David Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.6]
b. 9 Aug 1866 d. 21 Dec 1946
9
Jane Isabella Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.7]
b. 1853
Isaac Walton
b. Abt 1850
10
Rudolph F. Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.1]
b. 1874
10
Hannah Geralda Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.2]
b. 16 Feb 1876
10
David Bertrum Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.3]
b. 1879
Florence
b. Aug 1878
11
Violet Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.3.1]
b. Feb 1905
11
Thomas Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.3.2]
b. Jul 1908
11
Marguerite Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.3.3]
b. Mar 1907
11
Florence Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.3.4]
b. Feb 1909
10
Albert Guy Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.4]
b. 10 Oct 1880
10
Violet Isabella Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.5]
b. Abt 1890
10
Victor Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.6]
b. 31 Jan 1883 d. 1 Feb 1883
10
Lydia Isabella Walton
[1.1.1.1.1.1.5.3.7.7]
b. 27 Jun 1884 d. 21 Feb 1885
9
Margaret Pherrill
[1.1.1.1.1.1.5.3.8]
b. 17 Jul 1863
8
Archibald A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.4]
b. Jan 1831 d. 8 Jul 1896
Eliza Richardson
b. 14 Jun 1838 d. 29 Mar 1915
9
George A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.4.1]
b. 17 Jan 1866 d. 1937
+
Clarinda
b. 2 Jan 1864 d. 1935
9
Margaret Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.4.2]
b. 28 Jan 1878 d. 28 Nov 1947
+
William McKean
b. 3 Mar 1870 d. 10 Apr 1963
9
David Charles Thomas Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.4.3]
b. 18 Jun 1875 d. 25 Jan 1952
8
David A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.5]
b. 21 Feb 1834 d. 30 Mar 1893
Margaret Paterson
b. 1840 d. 29 Jan 1875
9
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.5.1]
b. 9 Jun 1862 d. Aft 31 Mar 1901
Alexander Weir
b. 4 May 1860 d. Aft 31 Mar 1901
10
Iva Weir
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.1]
10
Thomas Weir
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.2]
10
Ada Gladys Estelle Weir
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3]
b. 24 Nov 1889
John McFayden
11
Marguerite McFayden
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3.1]
Brian Bignell
12
John Bignell
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3.1.1]
11
Ewan McFayden
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3.2]
Doreen Kirby
12
Marie McFayden
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3.2.1]
12
Lynn McFayden
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3.2.2]
12
Margaret McFayden
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3.2.3]
12
Kirby McFayden
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3.2.4]
11
Ruth McFayden
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3.3]
Ian R. Paterson
12
Jo-Anne Paterson
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.3.3.1]
10
Winnifred J. Weir
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.4]
b. 11 Feb 1892
John Rusk
11
Earl Rusk
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.4.1]
Mildred Holland
12
John Rusk
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.4.1.1]
12
Eleanor Rusk
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.4.1.2]
11
Murray Rusk
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.4.2]
Marion Shaw
12
Norman Rusk
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.4.2.1]
12
Cheryl Rusk
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.4.2.2]
10
William J.W. Weir
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.5]
b. 11 Feb 1895
+
Elizabeth Albright
10
Fred Thomson Weir
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.6]
b. 23 May 1898
Leila Gamble
11
Lucille Weir
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.6.1]
Russell Sanderson
12
Larry Sanderson
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.6.1.1]
12
Sheryl Sanderson
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.6.1.2]
11
Donald Weir
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.6.2]
11
Carole Weir
[1.1.1.1.1.1.5.5.1.6.3]
+
Keith Gabert
9
Mary Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.5.2]
b. 31 Jul 1867 d. 29 Jun 1909
+
James L. Young
b. 1866 d. 1938
9
Archibald D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.5.3]
b. 21 Feb 1868 d. 29 Mar 1944
Mary Elizabeth Larway
b. 15 Nov 1872 d. 6 Jan 1949
10
David Arnold Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.5.3.1]
b. 8 Feb 1893 d. 5 Apr 1982
Jean Rae Ormerod
b. 30 Apr 1894 d. 14 Mar 1986
11
Infant Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.5.3.1.1]
b. 1928 d. 19 Oct 1928
9
Annie J. Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.5.4]
b. 1872 d. 2 Aug 1935
Albert W.F. Mason
b. 1871 d. 15 Sep 1897
10
Vera Mason
[1.1.1.1.1.1.5.5.4.1]
b. 29 Jul 1897
+
John Rathbun
9
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.5.5]
9
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.5.6]
8
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.6]
b. 10 Apr 1837 d. 6 Jul 1924
William Ionson
b. 17 Sep 1834 d. 4 Jan 1905
9
James Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.1]
b. 24 Apr 1862 d. 8 Jun 1945
Harriet Emma Turner
b. 13 Jan 1865 d. Abt 1964
10
Wilbert Ashley Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.1.1]
b. 30 Jan 1887 d. Abt 1971
+
Mable V. Tolchard
10
Harriet Adella Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.1.2]
b. 28 Apr 1890 d. Abt 1973
+
Thomas Smith
b. 24 Jul 1889 d. 21 Nov 1966
10
Mary Isabella Victoria Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.1.3]
b. 9 Mar 1898 d. Abt 1970
9
Archibald William Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2]
b. 7 Jun 1864 d. 21 Feb 1949
Sarah Brown
b. 21 Dec 1864 d. 6 Apr 1942
10
Mary Edith Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.1]
b. 1 Mar 1896 d. 8 Mar 1967
Walter R. Thompson
b. 5 Oct 1887 d. 29 May 1980
11
Albert Thompson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.1.1]
11
Murray Thompson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.1.2]
10
Sarah Gertrude (Sadie) Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.2]
b. 2 Jan 1903 d. 8 Mar 1997
Edward Otto Jarick
b. 26 Oct 1887 d. 13 Oct 1937
11
Evelyn Ivy Jarick
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.2.1]
b. 20 Apr 1927 d. 9 Oct 1998
Gerald Kenneth MacNab
b. 13 Apr 1927 d. 26 Mar 2005
12
Girl MacNab
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.2.1.1]
10
Charles Archibald Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.3]
b. 5 Feb 1900 d. 19 Dec 1972
Irene J. Walker
b. 1903 d. 1997
11
Frank Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.3.1]
11
William Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.3.2]
10
Jessie May Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.4]
b. 22 Feb 1892 d. 15 Jun 1972
+
Isaac William Ashbridge
b. 9 Mar 1889 d. 23 Jun 1946
10
William Edgar Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.5]
b. 11 Feb 1890
Lillian Daisy Cramp
b. 1892 d. 8 Mar 1919
11
Norman Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.2.5.1]
+
May Baden Hord
b. Abt 1899
9
Mary Hannah Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.3]
b. 18 Jan 1871 d. 11 Mar 1930
Arthur Harding Mitchell
b. 22 Oct 1872 d. 12 Jan 1953
10
Arthur Edgar Mitchell
[1.1.1.1.1.1.5.6.3.1]
b. 1 Jul 1909 d. 28 Feb 1985
+
Mildred Workman
b. 11 Nov 1911 d. 1963
+
Ellen McMath Chambers
b. 4 Apr 1906 d. 16 Mar 1992
10
William Richard Mitchell
[1.1.1.1.1.1.5.6.3.2]
b. 1 Feb 1900 d. 5 Feb 1900
10
George Wesley Mitchell
[1.1.1.1.1.1.5.6.3.3]
b. 21 Sep 1910 d. 7 Oct 1910
9
Albert Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.4]
b. 11 May 1868 d. Jul 1936
Elsie Louise Chanter
b. 22 Jun 1872 d. Abt 1955
10
Hartley Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.4.1]
10
William Weley Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.4.2]
b. 18 Mar 1901 d. 14 Jun 1965
+
Rosalie Arnauts
b. 2 Oct 1902 d. 12 Dec 1993
10
Albert Roy Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.4.3]
b. 5 Oct 1902 d. 1 Jan 1904
10
Stanley Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.4.4]
b. 1 Oct 1912 d. Nov 1982
+
Margaret E.
b. 29 Mar 1916 d. 25 Sep 1989
10
Donald Ionson
[1.1.1.1.1.1.5.6.4.5]
b. 1 Oct 1912
8
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.7]
b. 22 Dec 1840 d. Aft 1901
Simpson Barron
b. 29 Jul 1830
9
George Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.1]
b. 15 Oct 1866
9
Archibald Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.2]
b. 1868
9
Wesley Walton Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.3]
b. 22 Oct 1878 d. 7 Sep 1930
Margaret Elizabeth MacKay
b. 1894 d. 1 Aug 1999
10
Vonda Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.1]
Stanley Lemmons
11
Sharon Lemmons
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.1.1]
11
David Lemmons
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.1.2]
11
Robert Lemmons
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.1.3]
11
Brenda Lemmons
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.1.4]
10
Allison MacKay Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.2]
10
Verna Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.3]
+
Samuel Doupe
10
Orval Walton Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.4]
b. Abt 1927 d. Abt 1998
Alfreda Nelson
11
Daniel Wesley Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.1]
11
Sherry Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.2]
11
Timothy Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.4.3]
10
Velma Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.3.5]
9
Hannah Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.4]
b. 27 Dec 1869
John Nelson Thornton
b. 9 Dec 1866
10
Ada Ellen Thornton
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.1]
b. 22 Mar 1891
Erastus Martin
11
Hazel Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.1.1]
+
Oliver Lemmons
11
Lewis Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.1.2]
10
Louis Simpson Thornton
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.2]
b. 14 Feb 1894
Beulah
11
Marjorie Thornton
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.2.1]
b. 1931
Louis Flannigan
12
Mary Flannigan
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.2.1.1]
[
=>
]
12
Bonnie Flannigan
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.2.1.2]
[
=>
]
12
John Flannigan
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.2.1.3]
11
Evelyn Thornton
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.2.2]
10
Iva Thornton
[1.1.1.1.1.1.5.7.4.3]
9
Isabella Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.5]
b. 6 Jul 1872 d. Abt 1968
William Richard Kennedy
b. 17 Apr 1872 d. Abt 1935
10
Helen Irene Kennedy
[1.1.1.1.1.1.5.7.5.1]
b. Abt 1912 d. 1951
10
Alexander Kennedy
[1.1.1.1.1.1.5.7.5.2]
b. Abt 1906
9
Mary Jane Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.6]
b. 6 Apr 1874 d. 4 Nov 1968
+
Arthur Harding Mitchell
b. 22 Oct 1872 d. 12 Jan 1953
9
Sarah Anne Barron
[1.1.1.1.1.1.5.7.7]
b. Abt 1877 d. Jul 1957
Archibald McMillan Martin
b. Abt 1877 d. 16 Dec 1898
10
Norval Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.1]
10
Velma Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.2]
Edward McComb
11
Verna McComb
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.2.1]
+
Vaughn Logan
11
Helen McComb
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.2.2]
+
Howard Karn
10
George Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.3]
b. 24 Nov 1912
Marjorie Ross
b. 12 Jun 1912
11
Kaye Marie Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.3.1]
11
Robert George Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.3.2]
10
Jordon Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.4]
b. 20 Oct 1915
Marion Doige
11
Mary Gordon Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.4.1]
+
Paul Murphy
11
Paul Douglas Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.4.2]
10
Reginald Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.5]
Joyce Martin
11
Linda Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.5.1]
11
Ronald Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.5.2]
11
Danny Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.5.3]
d. Feb 1961
11
Laurel Lee Martin
[1.1.1.1.1.1.5.7.7.5.4]
8
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.8]
b. Abt 1845 d. 1 Apr 1872
Adam Richardson
b. 1 Nov 1846
9
Isabella Richardson
[1.1.1.1.1.1.5.8.1]
b. Mar 1872 d. 27 Jul 1872
8
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.5.9]
b. 9 Sep 1841 d. 31 Aug 1842
7
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.6]
b. 27 Feb 1798 d. 12 Oct 1852
Rebecca Miskie
b. Dec 1804 d. 23 Jun 1863
8
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 1824
+
Mrs. Pheonix
8
John D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 1826 d. 18 Jan 1857
Mary Ann Teasdale
b. 11 Mar 1837 d. 23 Dec 1914
9
David J. Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 7 Mar 1856 d. 14 Sep 1874
8
Sarah Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 28 May 1831 d. Aft 1901
Francis Little
b. 1829 d. 4 Oct 1881
9
Mary Little
[1.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 1850
Joseph Break
b. 1835
10
Sarah M. Break
[1.1.1.1.1.1.6.3.1.1]
b. 1872
10
Edith S. Break
[1.1.1.1.1.1.6.3.1.2]
b. 1874
10
Fannie Break
[1.1.1.1.1.1.6.3.1.3]
b. 1877
10
Mary J Break
[1.1.1.1.1.1.6.3.1.4]
b. 1879
9
Rebecca Little
[1.1.1.1.1.1.6.3.2]
9
David Little
[1.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 25 Jul 1854 d. 22 Jun 1878
9
Janet Little
[1.1.1.1.1.1.6.3.4]
9
Isabella Little
[1.1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 1859
Richard Vanhorn
b. Abt 1854
10
Rebecca J. Vanhorn
[1.1.1.1.1.1.6.3.5.1]
b. 4 Jan 1883
10
John F. Vanhorn
[1.1.1.1.1.1.6.3.5.2]
b. 18 Oct 1884
10
David Vanhorn
[1.1.1.1.1.1.6.3.5.3]
b. 11 Apr 1887
8
David Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 11 Jul 1830 d. 22 Mar 1902
Mary Walker
b. 1832
9
Thaddeus Wright Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1]
b. 21 Oct 1863 d. 16 Apr 1933
Eliza Jane Key
b. 26 Nov 1862 d. 10 Feb 1956
10
Oliver Mowat Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.1]
b. 12 Mar 1890 d. 1943
Georgina Muriel Lloyd
b. Abt 1893
11
Wilfred Bruce Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.1.1]
11
Victor Lloyd Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.1.2]
11
Leila Marion Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.1.3]
11
Wilbert George Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.1.4]
b. 10 Sep 1914 d. 18 Sep 1914
10
David Mirehouse Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.2]
b. 28 Oct 1891 d. Aug 1944
Clara Elizabeth Turnbull
11
Dorothy Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.2.1]
10
Mary Rebecca (Dolly) Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.3]
b. 29 Apr 1894
Noah John Cannard
b. 16 Aug 1884 d. 27 Jun 1955
11
David Orion Cannard
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.3.1]
b. 23 Oct 1917
11
Joy Cannard
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.3.2]
b. 2 Jul 1923
+
Lloyd George Hopkin
b. 3 Sep 1916
11
Glen Davis Cannard
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.3.3]
b. 7 Jul 1926
11
Mary Jean Cannard
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.3.4]
b. 3 May 1929
+
Harold Emerald Bates
b. 24 May 1926
10
Francis Orion Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.4]
b. 19 Nov 1895 d. 1 Mar 1968
Katherine Parkinson
11
Reo Wright Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.4.1]
b. 24 Aug 1928
Mary Weber
12
Kimberley Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.4.1.1]
12
Peter Francis Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.4.1.2]
11
Duane Francis Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.4.2]
Rosemarie
12
Thomas Duane Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.4.2.1]
12
Tammy Maria Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.4.2.2]
11
Mary Catherine Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.1.4.3]
9
Rebecca Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.4.2]
b. Abt 1857
Ralph Richards
b. Abt 1854
10
Charles Richards
[1.1.1.1.1.1.6.4.2.1]
10
Lillie Vivian Richards
[1.1.1.1.1.1.6.4.2.2]
b. 1880
William Brown
11
Percy Brown
[1.1.1.1.1.1.6.4.2.2.1]
11
Stanley Brown
[1.1.1.1.1.1.6.4.2.2.2]
11
Rae Brown
[1.1.1.1.1.1.6.4.2.2.3]
8
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.5]
b. 1840 d. 3 Dec 1885
John McCaffrey
b. 1838
9
James McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.1]
b. 11 Jul 1863 d. 7 Dec 1939
Fanny Augusta Raymer
b. 1 Aug 1867 d. 1 Jan 1916
10
Mina McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.1]
b. 29 Nov 1890
Dr. L.W. Kergin
b. 5 Jul 1897
11
Edith Kergin
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.1.1]
b. 16 Apr 1915
+
Dr. R. R. Mutrie
b. 5 Nov 1909
11
Alan James Kergin
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.1.2]
b. 16 Mar 1921
11
Dorothy Jean Kergin
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.1.3]
b. 5 Sep 1928
10
Walter Raymer McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.2]
b. 23 Jun 1894
Muriel Bryant
b. 30 Mar 1896
11
Keith A. McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.2.1]
b. 2 Apr 1919
11
Brian D. McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.2.2]
b. 14 Nov 1920
11
Bruce I. McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.2.3]
b. 5 Oct 1922
11
Gordon G. McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.2.4]
b. 31 Aug 1924
11
Marjorie P. McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.2.5]
b. 15 Mar 1926
11
Shirley P. McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.1.2.6]
b. 17 Mar 1928
9
Andrew McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.2]
b. 1853
Johanna
b. 1858
10
Ellen McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.2.1]
b. 1877
9
David McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.3]
b. 20 Jul 1866
Alice Yates
b. 7 Dec 1871
10
David McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.3.1]
b. 15 May 1894
10
Eileen McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.6.5.3.2]
b. 23 Mar 1898
8
Thaddeus Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.6]
b. 16 Mar 1834 d. 23 Oct 1915
Barbara Walker
b. 9 Apr 1846 d. 4 Jan 1924
9
Thaddeus Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.6.1]
b. 1864
8
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.6.7]
b. 23 Nov 1844 d. 9 Apr 1922
Francis Little
b. 1829 d. 4 Oct 1881
9
James Little
[1.1.1.1.1.1.6.7.1]
9
Isabella Little
[1.1.1.1.1.1.6.7.2]
7
Janet (Jennet) Thomson
[1.1.1.1.1.1.7]
b. 18 May 1800 d. 11 Jan 1862
Andrew Johnston
b. 7 Sep 1796 d. 3 Sep 1868
8
James Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 22 Jan 1821 d. 13 Sep 1853
Isabella Little
b. 22 Jul 1820 d. 7 Jul 1912
9
Andrew Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1]
b. 9 Jul 1843
Ellen Thomson
b. 23 Nov 1844
10
James Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.1]
b. 1868
+
Elizabeth Alice Hutcheson
b. Abt 1875
10
Isabella Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.2]
b. 1877
10
Hattie May Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.3]
b. 1879
James E. Ludford
b. Abt 1880
11
Clifford Ludford
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.3.1]
Esther Bergen
12
Michael Ludford
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.3.1.1]
11
Olive Ludford
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.3.2]
Fred Irving
12
Freddie Irving
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.3.2.1]
11
James Ludford
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.3.3]
10
William John Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.4]
b. 30 Sep 1880
+
Elizabeth Taylor
b. Abt 1886
10
Allan T. Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.5]
b. 30 Jun 1883
10
Mary Maude Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.6]
b. 23 Mar 1887
Chester H. Knapp
b. Abt 1886
11
Ellen Knapp
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.6.1]
11
Harvey Knapp
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.6.2]
11
Herbert Knapp
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.6.3]
11
Willis Knapp
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.6.4]
10
Rebecca Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.7]
b. 22 Jan 1871 d. 23 Jan 1871
10
David John Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.8]
b. Feb 1873 d. 11 Mar 1873
10
Andrew Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.1.9]
b. 13 Sep 1874
9
John Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2]
b. 30 Nov 1844 d. 26 Apr 1906
Mary Jane Elliott
b. 1852 d. 14 Dec 1893
10
James Archie Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.1]
b. 20 Feb 1877 d. Aft 31 Mar 1901
10
David Little Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.2]
b. 31 Aug 1878 d. Aft 31 Mar 1901
Mary I Hague
b. Abt 1888
11
May Isabel Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.2.1]
11
Arthur Elliot Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.2.2]
11
Thelma Ethel Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.2.3]
11
David Craig Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.2.4]
11
Margaret Elinor Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.2.5]
10
Andrew Howard Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.3]
b. 17 Nov 1880 d. 7 Nov 1946
Victoria E Bruels
b. 6 Jul 1887 d. 19 Oct 1954
11
Kenneth Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.3.1]
11
George Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.3.2]
11
Howard John Archibald Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.3.3]
11
James Andrew Little Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.3.4]
10
Margaret MacKay Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.4]
b. 28 Dec 1884 d. 13 Mar 1938
Walter Armstrong
b. 17 Aug 1874 d. 23 Jan 1940
11
Mary Armstrong
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.4.1]
11
Jean Margaret Armstrong
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.4.2]
+
Leslie Middlebrook
11
Florence Evelyn Armstrong
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.4.3]
+
William G. Brown
11
Hazel Mabel Armstrong
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.4.4]
+
Elmer Canning
11
James Elliot Armstrong
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.4.5]
10
Isabella L Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.5]
b. 1886 d. 9 Jan 1889
10
William T Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.2.6]
b. Mar 1890 d. 9 Jun 1890
9
William Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3]
b. 4 Jul 1846 d. 1925
Agnes Wyper
b. 1852 d. 1883
10
Annabella Wyper Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.1]
b. 1879 d. 1880
Mary Baxter
b. 27 Aug 1862 d. 30 Aug 1957
10
Albert James Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.2]
b. 15 Feb 1887 d. 1975
10
Leslie George Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3]
b. 23 Sep 1889 d. 19 Dec 1965
Lilliian Ada Hammond
b. 22 Nov 1894 d. Aft 1 Nov 1944
11
Neil Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.1]
b. 10 Nov 1918
Jennie Ebdon
b. 22 Jan 1916
12
Leslie Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.1.1]
12
Jane Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.1.2]
12
Joyce Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.1.3]
12
Brian Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.1.4]
12
Lyal Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.1.5]
12
Denise Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.1.6]
11
Norma Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.2]
b. 28 Aug 1922
Robert Harrison Bullock
12
William Robert Bullock
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.2.1]
12
Tanis Bullock
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.2.2]
11
William Leslie Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.3.3]
b. 17 Apr 1924 d. 1 Nov 1944
10
Anna May Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.4]
b. 7 Apr 1894 d. 25 Jul 1964
Percival Graham Weir
b. 19 Jun 1892 d. 9 Jan 1961
11
Lorne Stuart Weir
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.4.1]
Grace Smith
12
Susan Weir
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.4.1.1]
12
James Weir
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.4.1.2]
11
Marion Weir
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.4.2]
Fred Mosher
12
Ricky Mosher
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.4.2.1]
12
Randy Mosher
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.4.2.2]
12
Scott William Mosher
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.4.2.3]
10
Margaret B Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.5]
b. 18 Feb 1901
Erb W. H. Scott
11
Dorothy Scott
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.5.1]
Chester Whitley
12
Lea Whitley
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.5.1.1]
11
Winifred Eileen Scott
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.5.2]
d. 15 Sep 2019
Wilfred Miller Lewis
d. 1992
12
Gregory Phillip Lewis
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.5.2.1]
12
Wayne Kenneth Lewis
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.5.2.2]
12
Brenda Louise Lewis
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.5.2.3]
11
Marjorie Scott
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.5.3]
Ernest Phillip
12
Stephen Scott Phillip
[1.1.1.1.1.1.7.1.3.5.3.1]
9
Mary Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.4]
b. Jul 1849 d. 13 Sep 1851
9
Robert Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.5]
b. 30 Sep 1850 d. 14 Feb 1852
9
Mary Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.1.6]
b. 3 Mar 1853 d. 10 Oct 1944
John Elliott
b. 18 Dec 1854 d. 13 Sep 1944
10
Isabella Jane Elliott
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.1]
b. 22 Dec 1881 d. 1971
10
Laura Maybel Elliott
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2]
b. 28 Sep 1883 d. 27 Nov 1984
James George Paterson
b. 26 Apr 1881 d. 23 Mar 1949
11
Helen Isabel Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.1]
b. 14 May 1913
George W Robinson
b. 20 Sep 1910 d. 4 Dec 1981
12
Nancy Anna Robinson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.1.1]
12
Ruth Elizabeth Robinson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.1.2]
12
James George Robinson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.1.3]
[
=>
]
11
James Elliot Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.2]
b. 13 Dec 1915
Clare B. Reid
b. 7 Jan 1919
12
Linda Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.2.1]
12
Susan J. Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.2.2]
12
Randoph James Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.2.3]
11
Robert Murray Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.3]
b. 7 Jun 1918
Florence Rody
b. 16 Dec 1918
12
David Murray Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.3.1]
12
Janet Lesley Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.3.2]
11
John Donald Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.4]
b. 27 May 1921
Marjorie Anne Dodd
b. 25 Jul 1924
12
Nora Lea Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.2.4.1]
10
Emily May Elliott
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.3]
b. 17 May 1885 d. 1975
10
Walter James Elliott
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.4]
b. 28 Nov 1890 d. 1982
Alda Eileen Rowntree
b. 1890 d. 23 Dec 1968
11
Marion Elliott
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.4.1]
b. 27 Sep 1917
Hewlett White
12
Mary White
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.4.1.1]
12
Dorothy White
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.4.1.2]
12
Douglas White
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.4.1.3]
10
Wilfred Alexander Elliott
[1.1.1.1.1.1.7.1.6.5]
b. 1896 d. 1897
8
Mary Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 19 Dec 1818 d. 2 Mar 1876
John Donaldson
b. 1815 d. 28 Feb 1895
9
John Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.1]
b. Feb 1837 d. 30 May 1914
Emily Skippon
b. 1 Jun 1837 d. 6 Jan 1921
10
William Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.1.1]
b. 1871 d. 1943
Anna Almeda Matthews
b. 1871 d. 1912
11
Mary Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.1.1.1]
b. 1902
+
David Henry
b. 1901
11
Evelyn Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.1.1.2]
b. 1903
+
Karl O'Neil
b. 1893
11
Isabella Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.1.1.3]
b. 1904
+
Samuel King
b. 1903
11
John Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.1.1.4]
b. 1909
10
Isabella Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.1.2]
b. 30 Apr 1867 d. 12 May 1933
9
Elizabeth Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.2]
b. 21 Aug 1854
+
John S. McMillan
b. 17 Sep 1858
9
Mary Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.3]
9
Jennet Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.4]
b. 5 Jul 1852 d. 1911
John Bawden
b. 1844 d. 1930
10
Gladys Aileen Bawden
[1.1.1.1.1.1.7.2.4.1]
b. 13 Aug 1890 d. 17 Nov 1958
Achilles Weddle
d. 1926
11
Brent Weddle
[1.1.1.1.1.1.7.2.4.1.1]
Daniel McDonough
b. 1888
11
Donalda Ann McDonough
[1.1.1.1.1.1.7.2.4.1.2]
b. 1929
+
Bernard Lipka
10
Elizabeth Donalda Bawden
[1.1.1.1.1.1.7.2.4.2]
b. 23 May 1895
+
Audley Oscar Williams
b. 1890
10
Arthur E. Bawden
[1.1.1.1.1.1.7.2.4.3]
b. 20 Oct 1876
10
Florance M. Bawden
[1.1.1.1.1.1.7.2.4.4]
b. 13 Jun 1882
9
Isabella Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.5]
9
Helen Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.6]
b. 19 Apr 1859 d. 1 Jan 1933
Caleb Quigley
b. Abt 1858 d. Sep 1927
10
Francis Arthur Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.1]
b. 23 Jun 1883 d. 1941
Margaret Jane Kincade
b. Abt 1884
11
Caleb Arthur Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.1.1]
b. 3 Sep 1910
10
Mary Georgina Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.2]
b. 13 Aug 1885
Arthur Hunt Penny
b. 1892 d. 1961
11
Irving Penny
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.2.1]
b. 23 Apr 1921
11
Helen Victoria Penny
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.2.2]
b. 19 Jun 1919
+
Kenneth MacDonald
11
Frederick Arthur Penny
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.2.3]
b. 30 Aug 1926
10
William John Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.3]
b. 30 Oct 1887
Margaret Manson
b. 1889
11
Helen Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.3.1]
b. 1916
+
Frank Kalwas
11
William Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.3.2]
b. May 1919
11
Dorothy Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.3.3]
b. 1924
+
Samuel Ferrell
11
Mary Elizabeth Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.3.4]
b. 1928
+
Francis Cutter
10
Abigail Helen Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.4]
b. 15 Jan 1890
William MacDonald
b. Abt 1882
11
Gladys MacDonald
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.4.1]
b. 1918
11
Jean MacDonald
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.4.2]
b. 1921
+
John Eicher
10
Elizabeth Kathleen Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.5]
b. 19 Jul 1892
10
Frederick Caleb Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.6]
b. 8 Jul 1894
+
Isabella Kincade
b. Abt 1891
10
Charles Allen Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.7]
b. 25 Oct 1896
Florence Elizabeth Smith
b. 1898
11
Evelyn Ruth Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.7.1]
b. 14 Aug 1922
+
Clifford M. Overton
11
Jean Susan Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.7.2]
b. 7 Jul 1923
+
Arthur Storie
11
Lorraine Helen Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.7.3]
b. 1 Dec 1924
+
Ronald Ketcheson
11
Audrey Patricia Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.7.4]
b. 13 Mar 1926
+
William Rowland
10
Kenneth Chester Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.8]
b. 30 Mar 1901
Mary Elgie
b. 1902
11
Abigail Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.8.1]
b. 1924
11
Kenneth Quigley
[1.1.1.1.1.1.7.2.6.8.2]
b. 1930
9
Andrew Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.7]
b. Abt 1846
Elizabeth Wilson
b. Abt 1855
10
Hattie Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.7.1]
+
Johnstone Robertson
9
Christina Donaldson
[1.1.1.1.1.1.7.2.8]
b. Abt 1857
Frank G. Ryan
b. Abt 1857
10
May Ryan
[1.1.1.1.1.1.7.2.8.1]
8
William Richard Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1825 d. 6 Feb 1872
8
Robert Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4]
b. 27 May 1827 d. 19 Aug 1896
Melinda Harrington
b. 1 Jul 1833 d. 18 Nov 1860
9
Andrew Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4.1]
b. 14 Mar 1855 d. 16 Feb 1857
9
William James Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4.2]
b. 23 Sep 1857 d. 15 Mar 1918
Ellen Elizabeth Gibb
b. 18 May 1858 d. 1911
10
Frank Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4.2.1]
b. 23 Nov 1886 d. 21 Sep 1949
10
Olive Irene Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4.2.2]
b. 25 Jun 1895 d. 14 Dec 1972
Elizabeth Harrington
b. 31 Mar 1844 d. 12 Jan 1929
9
Hiram Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4.3]
b. 1864
9
Melinda Jane (Minnie) Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4.4]
b. 4 Jun 1866 d. 1935
John Baird
b. 27 Jan 1860 d. 30 Nov 1935
10
Walter M Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.1]
b. 1888 d. 1889
10
Elizabeth Mae Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.2]
b. 18 Mar 1890 d. 1971
Alexander Clark Secor
b. 1889 d. 1987
11
Watson Secor
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.2.1]
12
Wayne Secor
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.2.1.1]
11
June Secor
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.2.2]
b. 1923
10
Annie M. Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.3]
b. 18 Nov 1891
Heatherington James Thomson
b. 13 Dec 1885 d. 25 Apr 1955
11
Grant Thomson
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.3.1]
11
Keith Thomson
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.3.2]
10
Frederick Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.4]
b. 15 Apr 1894
+
Ethel Ray Bush
b. 24 Mar 1889
10
John Stuart Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.5]
b. 31 Aug 1895 d. 30 May 1958
Irene Jane MacDonald
b. Abt 1895
11
Betty Irene Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.5.1]
b. 1919
John Allan McLean
12
John Stuart McLean
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.5.1.1]
12
Allan Watson McLean
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.5.1.2]
12
Marcia Irene McLean
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.5.1.3]
11
John Marshall Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.5.2]
b. 1921
+
Frances Zalusky
11
William Stuart Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.5.3]
b. 1932
+
Maureen White
b. 1922
10
Robert Johnston Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.6]
b. 3 Apr 1897 d. 15 Aug 1963
+
Elizabeth Wood
b. 27 Mar 1893 d. 1 Feb 1965
10
James Campbell Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.7]
b. 29 Apr 1899
10
Dr Nolan H Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.8]
b. 1905 d. 1988
Frieda Elizabeth Wittman
11
Nolan H Baird, Jr
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.8.1]
10
Blanche E Baird
[1.1.1.1.1.1.7.4.4.9]
b. 1907 d. 1908
9
David J. Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4.5]
b. 1873
9
Mary A. Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4.6]
b. 21 Jun 1875
9
Robert A. Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.4.7]
b. Aug 1880
8
David Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5]
b. 1830 d. 31 Jan 1895
Laura Secor
b. 18 Sep 1830 d. 16 Jun 1907
9
James Henry Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.1]
b. 1853 d. 25 Aug 1925
Alicia Laskey
b. 1854 d. 25 Mar 1939
10
Laskey Preston Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.1.1]
b. 1881 d. 1957
Irene Hearne
11
Muriel Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.1.1.1]
b. 1911
+
Arthur Harris
11
Elmer Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.1.1.2]
b. 1916
10
Secor Winslow Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.1.2]
b. 4 May 1886 d. Dec 1976
Edna Gramlich
b. 27 Jun 1888 d. 26 Oct 1948
11
Velma Pauline Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.1.2.1]
b. 1910 d. 1911
11
Lloyd Gordon Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.1.2.2]
b. 1911
11
Lyle Secor Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.1.2.3]
b. 1913 d. 1913
11
Joanne Marilyn Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.1.2.4]
b. 1932
+
Ian Montague Grant
+
Beulah May Lowry
b. 1899
9
Alice Mary Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.2]
b. 26 Aug 1855 d. 27 Jun 1925
Archibald W. Forfar
b. 3 Mar 1849 d. 12 Feb 1907
10
Ernest Johnston Forfar
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.1]
b. 15 Feb 1876 d. 29 Aug 1942
+
Anna may Safley
10
Nellie Marion Forfar
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.2]
b. 12 Oct 1878 d. 22 Mar 1959
10
Hubert Allan Forfar
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.3]
b. Feb 1882 d. 22 Oct 1885
10
William Carleton Forfar
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.4]
b. 3 Mar 1885 d. Abt 1929
+
Florence Moffat
10
Laura Agnes Forfar
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.5]
b. 21 Apr 1888 d. 24 Aug 1901
10
Hubert Roy Forfar
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.6]
b. 11 Dec 1890 d. 1953
Agnes Stewart Bell
b. 17 May 1896 d. Oct 1992
11
Lenore Forfar
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.6.1]
Ross Bowman
12
Allan Bowman
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.6.1.1]
12
Kevin Bowman
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.6.1.2]
12
Douglas Bowman
[1.1.1.1.1.1.7.5.2.6.1.3]
+
Allan Isaac
b. 1942 d. 1986
9
William George Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.3]
b. 7 Mar 1858 d. 1932
Elizabeth Harris
b. 22 May 1860 d. 1938
10
Harris Young Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.3.1]
b. 31 Aug 1884 d. 1918
10
Luther D Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.3.2]
b. 2 Dec 1888
Annie
11
Donald Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.3.2.1]
b. 1932
10
Wilfred Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.3.3]
b. 15 Dec 1894
9
Ellen Maria (Nellie) Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.4]
b. 11 Mar 1860 d. 1919
Alexander Baird
b. 16 Nov 1856 d. 1943
10
Wilmot Johnston Baird
[1.1.1.1.1.1.7.5.4.1]
b. 29 Dec 1889
Jean Aileen Lenty
b. Abt 1901
11
Donald Baird
[1.1.1.1.1.1.7.5.4.1.1]
11
Aileen Baird
[1.1.1.1.1.1.7.5.4.1.2]
10
Earl Meharg Baird
[1.1.1.1.1.1.7.5.4.2]
b. 18 Feb 1901 d. 1953
Marguerite
11
David Earl Baird
[1.1.1.1.1.1.7.5.4.2.1]
11
Douglas Baird
[1.1.1.1.1.1.7.5.4.2.2]
9
Elizabeth Janet (Lily) Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.5.5]
b. 20 Apr 1863 d. 21 Jun 1907
Peter Theodore Badgerow
b. 27 Dec 1859 d. 29 Apr 1919
10
Laura Lydia Badgerow
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.1]
b. 22 May 1885 d. 22 Feb 1952
Chester Stanley Smith
b. 6 Aug 1883 d. 13 Feb 1937
11
Lillie Elizabeth Smith
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.1.1]
b. 1907
+
Ralph Tracy
11
Alice Smith
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.1.2]
+
Douglas Mathewson
11
Frances Smith
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.1.3]
+
Clarence Smith
10
Della M. Badgerow
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.2]
b. 1887
Charles Isaac Golshon
b. 1883 d. 1959
11
Fern Janet Golshon
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.2.1]
b. 1907
+
Charles H. Rolfe
b. 1907
11
Wilmot E. Golshon
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.2.2]
b. 1909
11
Charles Wilbur Golshon
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.2.3]
b. 1911
10
Nellie Lila Badgerow
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.3]
b. 4 May 1889 d. May 1979
Julius Anson Johns
b. 1886
11
Audrey Mary Johns
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.3.1]
b. 1905
Harold A. Hood
b. 1906
12
Darlene Hood
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.3.1.1]
11
Wilfred Irving Johns
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.3.2]
b. 1912
11
Lavern Eliza Johns
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.3.3]
b. 1918
+
Leslie Jay Roberts
b. 1915
11
Ruth Janet Johns
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.3.4]
b. 1921
+
Samuel M. Thomas
b. 1915
11
Harold Donald Johns
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.3.5]
b. 1924
11
Phyllis Darlene Johns
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.3.6]
b. 1927
+
John C. Lambert
b. 1921
10
Lafayette Ella Badgerow
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.4]
b. 1891
+
John Waynoth
d. 1953
+
Fred Lincoln Elroy
10
George (Ruby) Badgerow
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.5]
b. 14 Apr 1892 d. Mar 1966
Bessie Smith
b. 1894
11
Doris Badgerow
[1.1.1.1.1.1.7.5.5.5.1]
b. 1913
+
Robert Coleman
8
Janet Johnston
[1.1.1.1.1.1.7.6]
b. 1833 d. 28 May 1899
John Chester
b. 1828 d. 15 Mar 1901
9
Andrew C. Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.1]
b. 9 Jul 1856 d. 25 Apr 1929
Jessie Smith
b. 23 Nov 1861
10
Ruth E. Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.1.1]
b. 8 May 1899
10
Jame Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.1.2]
9
Thomas Elliot Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.2]
b. 10 Sep 1866
9
Frances Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.3]
b. Dec 1870 d. 1 Aug 1893
9
Georgina Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.4]
b. 20 Jan 1877
9
Elizabeth Helen (Nellie) Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.5]
b. 9 May 1875
William Paterson
b. Abt 1871
10
Clarence Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.6.5.1]
10
Douglas Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.6.5.2]
10
Edna Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.6.5.3]
10
Harold Paterson
[1.1.1.1.1.1.7.6.5.4]
9
John Herbert Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.6]
b. 3 Aug 1872
9
Emma Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.7]
b. 1869
9
William George Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.8]
b. 6 Aug 1859 d. Aft 1901
9
Janet Nettie Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.9]
b. 1863
+
Guy Denham
9
Mary Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.10]
b. 27 Aug 1858 d. 20 May 1927
9
George Chester
[1.1.1.1.1.1.7.6.11]
b. 1864 d. 21 Nov 1872
7
William D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8]
b. 4 Mar 1802 d. 3 May 1877
Isabella Lowes
b. 24 Sep 1807 d. 20 Jul 1888
8
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 3 Jun 1848 d. 15 Nov 1848
8
David W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 22 Dec 1828 d. 26 May 1907
Elizabeth Chester
b. Oct 1829 d. 18 Mar 1894
9
William Wesley Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1]
b. 31 Jan 1858 d. 15 Apr 1935
Margaret Smith
b. 8 Mar 1861 d. 23 Aug 1940
10
Lewis Elwood Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.1]
b. 13 Oct 1886 d. 7 Nov 1950
10
Theresa Isabell Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.2]
b. 9 Feb 1890
J. H. Abercrombie
b. Nov 1878 d. Jul 1959
11
Enid Theresa Abercrombie
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.2.1]
b. Nov 1911
+
Fred Allen
11
Ian Everett H. Abercrombie
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.2.2]
b. May 1919
10
Estermere Wesley Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.3]
b. Apr 1892 d. 13 Oct 1951
10
Elizabeth Pearl Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.4]
b. 19 Oct 1897
Edward Casper Paiment
b. 26 May 1900
11
Marie Ardis Paiment
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.4.1]
b. 20 Mar 1928 d. 26 Aug 1929
11
Lois Audrey Paiment
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.4.2]
b. 30 Oct 1930
+
Frank Hugh Poast
11
Margaret Beryl Paiment
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.4.3]
+
Clarence Lambert
10
Glen Carlyle Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5]
b. Jul 1900
Vera Whenham
b. 1904
11
Shirley Adelle Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5.1]
b. Jun 1929
J. J. Heilmann
b. 1920
12
Janet Lee Heilmann
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5.1.1]
12
Kerry Lynne Heilmann
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5.1.2]
12
Dana Lou Heilmann
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5.1.3]
11
Colin Argyle Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5.2]
b. 1932
Eleanor Hunter
12
Heather Laurie Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5.2.1]
12
Frederick Glen Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5.2.2]
12
Robert Bruce Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5.2.3]
11
Rodney Glen Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.5.3]
+
Valeria McBrien
b. 1932
10
Everett Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.1.6]
b. 1902 d. 1907
9
Emily Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.2]
b. 5 Apr 1864 d. 7 Sep 1905
Francis Weir
b. 19 Jun 1862 d. 24 Apr 1951
10
Ethel Weir
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.1]
b. 12 Feb 1899 d. 19 Mar 1899
10
Frank Thomson Weir
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.2]
b. 9 Apr 1902 d. 14 Jan 1904
10
Percival Graham Weir
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.3]
b. 19 Jun 1892 d. 9 Jan 1961
Anna May Johnston
b. 7 Apr 1894 d. 25 Jul 1964
11
Lorne Stuart Weir
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.3.1]
Grace Smith
12
Susan Weir
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.3.1.1]
12
James Weir
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.3.1.2]
11
Marion Weir
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.3.2]
Fred Mosher
12
Ricky Mosher
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.3.2.1]
12
Randy Mosher
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.3.2.2]
12
Scott William Mosher
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.3.2.3]
10
Herbert J. Weir
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.4]
b. 31 Oct 1894
Mary Hele
b. 6 Sep 1894
11
Joan Isabel Weir
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.4.1]
b. 24 Dec 1927
Ross F. Westlake
12
Debra Westlake
[1.1.1.1.1.1.8.2.2.4.1.1]
9
Sidney Chester Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.3]
b. 7 Jul 1867 d. Aft 1945
+
Clara Agnes Clark
d. 30 Apr 1942
Jane Carlyle
b. 11 Oct 1859 d. 31 Jul 1917
10
Douglas Frank Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.3.1]
b. 31 Mar 1917 d. 27 Mar 2005
Mary Lukish
b. 9 Oct 1921 d. 30 Aug 1995
11
Girl Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.3.1.1]
11
Boy Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.3.1.2]
11
Ron Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.3.1.3]
11
Rose Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.3.1.4]
9
Herbert Isaac Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.4]
b. 23 Jan 1872
Margaret French
b. 23 Dec 1865
10
Lorne Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.4.1]
10
Ruth Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.4.2]
10
Alice Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.4.3]
10
Blair Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.4.4]
b. 30 Jul 1892
10
Colin C. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.4.5]
b. 6 Jul 1896
9
Frances E. (Fanny) Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.5]
b. 21 Aug 1859 d. 2 Oct 1876
9
Colin Campbell Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.2.6]
b. 23 Jan 1872 d. 3 Oct 1872
8
Richard W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.3]
b. Dec 1838 d. 19 Nov 1878
Lillian Alderson
b. Abt 1855
9
Mabel Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.3.1]
b. 8 Jun 1879
9
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.3.2]
b. 11 May 1877 d. 25 Feb 1882
8
Archibald W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 16 Jan 1852 d. 29 Dec 1941
Anne Elizabeth (Libbie) Alderson
b. 1855 d. 12 Feb 1888
9
Alfred James Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.1]
b. 7 Nov 1880 d. May 1955
Emma Grace Ford
b. Abt 1885
10
Ralph Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.1.1]
b. Abt 1908
10
Dean Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.1.2]
b. Abt 1910 d. Died
10
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.1.3]
b. 15 Nov 1915 d. Nov 1968
Ms. McLean
11
James Russell Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.1.3.1]
b. 4 May 1945 d. 10 Feb 2001
+
Ms Szymanski
11
David Harold Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.1.3.2]
b. 10 Oct 1949 d. 10 Oct 1993
9
George Edwin Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.2]
b. 20 Sep 1885 d. 6 Feb 1907
9
Nellie Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.3]
b. 12 Nov 1883 d. 14 Nov 1966
+
Thomas Wood Brown
b. Abt 1880
Sarah Jackson
b. 16 Mar 1857 d. 15 Jun 1955
9
Flora Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.4]
b. 20 Nov 1889 d. May 1955
George Wood
10
Florence Evelyn Wood
[1.1.1.1.1.1.8.4.4.1]
b. 1913
9
Walter Opie Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.5]
b. 10 Feb 1892 d. 1972
Dorothy Sarah Mitchell
b. 1895 d. 1991
10
Valerie Joan Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.5.1]
9
Nathan Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.6]
b. 22 Sep 1894 d. 18 Nov 1915
9
Wilfred G. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.7]
b. 23 Dec 1896
9
Celia Amelia Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.4.8]
b. 1 Jan 1899
8
Joseph W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.5]
b. 23 Nov 1834 d. 25 Nov 1915
Anna Bella Atkinson
b. 1848 d. 17 Dec 1890
9
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.5.1]
b. 17 Sep 1884 d. 20 Feb 1955
William Arthur Spurgeon
b. 1877 d. 25 Nov 1909
10
Marjorie Spurgeon
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1]
b. Apr 1905
Nile Potter
11
Ralph Potter
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.1.1]
10
Edith Spurgeon
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2]
b. Oct 1907
Henry Dart
11
Robert Dart
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.1]
11
Henry Arthur Dart
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.2]
d. 2009
11
Frederick Dart
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.3]
11
Kenneth Dart
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.2.4]
10
Hilda Spurgeon
[1.1.1.1.1.1.8.5.1.3]
b. Apr 1910
+
William Dart
9
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.5.2]
b. 4 Jan 1890 d. 22 Sep 1956
8
William Wesley Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6]
b. 1833 d. 6 Apr 1900
Joanne Paterson
b. 1836 d. 14 Oct 1871
9
William W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.1]
b. 2 Jun 1866 d. 17 Mar 1920
Emma Gertrude McBain
b. 1870
10
Marion Gertrude Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.1.1]
b. Abt 1900
+
Joseph Alonze Hamilton
b. Abt 1889
9
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.2]
b. 1860 d. 8 Apr 1870
Amelia H. Patton
b. 5 Jan 1844 d. 28 Nov 1922
9
Lincoln Thomas Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.3]
b. 13 Nov 1873 d. 18 Dec 1956
Cynthia Elizabeth Sproule
b. 17 Mar 1875 d. 6 Aug 1935
10
Cynthia Ruby Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.3.1]
b. 25 May 1905 d. 23 Nov 1905
10
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.3.2]
10
Amelia Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.3.3]
10
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.3.4]
10
Lorne Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.3.5]
9
Horace Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.4]
b. 21 May 1877 d. 9 Apr 1963
9
Isabella L. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.5]
b. 6 Jul 1879 d. 26 Aug 1955
John B. Malcolm
b. 8 Dec 1878 d. 19 Apr 1936
10
A. Isabella Malcolm
[1.1.1.1.1.1.8.6.5.1]
b. 1905
10
Margaret Malcolm
[1.1.1.1.1.1.8.6.5.2]
10
Myrtle Jean Malcolm
[1.1.1.1.1.1.8.6.5.3]
b. 5 Jun 1910 d. 8 Oct 1913
10
Alma A. Malcolm
[1.1.1.1.1.1.8.6.5.4]
b. 1912 d. 1984
9
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.6]
b. 26 Nov 1881
? Williams
10
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.6.1]
10
Kenneth Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.6.2]
9
Heatherington James Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.7]
b. 13 Dec 1885 d. 25 Apr 1955
Annie M. Baird
b. 18 Nov 1891
10
Grant Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.7.1]
10
Keith Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.6.7.2]
8
Robert W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7]
b. 7 Jun 1843 d. 13 Mar 1916
Hannah Walton
b. 15 Sep 1848 d. 24 May 1882
9
William R. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1]
b. 11 Jun 1872 d. 5 Jan 1948
Margaret Burns
b. 7 May 1877 d. 30 Sep 1951
10
Elsie Kathaleen Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.1]
b. 30 Nov 1901 d. 16 Jul 1953
William H. Harrison
b. 27 Jul 1895 d. 31 Mar 1977
11
Claire Harrison
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.1.1]
11
James Thomson Harrison
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.1.2]
10
William Leonard Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.2]
b. 30 Dec 1902 d. 27 Apr 1978
Gladys M. Crawford
b. 21 Aug 1899
11
Marilyn Anne Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.2.1]
11
Noreen Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.2.2]
10
Robert John Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.3]
b. 3 Dec 1904 d. 15 Sep 1974
Mildred Elsie Forfar
b. 25 Mar 1908 d. 19 Apr 2006
11
John David Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.3.1]
Susan Nolt
12
Jocelyn Gale Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.3.1.1]
12
Elyse Susanne Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.3.1.2]
11
William Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.3.2]
+
Doris May Baldwin
11
Robert Allan Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.3.3]
Donna Joy Ballard
12
Burke Robert Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.3.3.1]
12
Craig Dylan Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.3.3.2]
10
Frank Alexander Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.4]
b. 21 Mar 1906 d. 19 Aug 1964
10
Iva Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.5]
b. 11 Jan 1911
10
Lily Ruth Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.6]
b. 20 Nov 1912
10
Lois Jean Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7]
b. 17 Jun 1914
Lyman Cameron Kennedy
b. 21 Jan 1913
11
Gwendolyn Jean Kennedy
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.1]
John Adams Gracie
12
Kimberly Jean Gracie
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.1.1]
12
Jacqueline Ellen Gracie
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.1.2]
12
Heather Jo-Anne Gracie
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.1.3]
11
Lorne Cameron Kennedy
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.2]
Joyce Firman
12
Heather Michele Kennedy
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.2.1]
12
Ronal Cameron Kennedy
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.2.2]
12
Brian Ross Kennedy
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.2.3]
11
Bonnie Margaret Kennedy
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.3]
John Edward Thomson
12
Scott Edward Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.3.1]
12
Jill Lorranine Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.3.2]
11
Ross Thomson Kennedy
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.4]
12
Michele Kennedy
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.7.4.1]
10
Marion Amelia Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.8]
b. 19 Mar 1917
Robert P. McCowan
b. 9 Nov 1917
11
Janet Marion McCowan
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.8.1]
11
Robert Douglas McCowan
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.8.2]
10
David Lloyd Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.9]
b. 20 Sep 1918 d. 20 Jul 1993
Helen Annis McCowan
b. 3 Aug 1919
11
Ronald David Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.9.1]
11
James Harold Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.9.2]
10
Eleanor Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.10]
b. 7 Aug 1921
John Coburn
b. 18 Mar 1921
11
Beverley Ruth Coburn
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.10.1]
11
Walter John Coburn
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.10.2]
11
Margaret Ellen Coburn
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.10.3]
11
Denise Eleanor Coburn
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.10.4]
Margaret Christina Culham
10
Charles Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.1.11]
b. 1897
9
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.2]
b. 1874
Robert Hain Williamson
b. 1874
10
Robert Williamson
[1.1.1.1.1.1.8.7.2.1]
10
Isabella Williamson
[1.1.1.1.1.1.8.7.2.2]
10
John Williamson
[1.1.1.1.1.1.8.7.2.3]
10
Anna Williamson
[1.1.1.1.1.1.8.7.2.4]
9
Mary M. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.3]
b. 3 Jan 1878 d. 2 Nov 1957
9
Annie Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.4]
b. 16 Sep 1881 d. 19 Jun 1957
Edward Armstrong Mason
b. 2 Apr 1875 d. 16 Jan 1956
10
Blanche Mason
[1.1.1.1.1.1.8.7.4.1]
b. 1905 d. 1986
10
Amy Mason
[1.1.1.1.1.1.8.7.4.2]
R.G. Bond
11
Kathaleen Bond
[1.1.1.1.1.1.8.7.4.2.1]
9
Alfred Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.5]
b. 7 Nov 1880
Elizabeth Jane Miller
b. 18 Aug 1859 d. 3 Feb 1893
9
James Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.6]
b. 6 Nov 1889 d. 25 Nov 1926
9
Elizabeth Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.7]
b. 20 Jan 1893 d. 7 Mar 1933
9
Ellen Gertrude Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.7.8]
b. 8 Jul 1891
+
Charles Smith
8
Bridget Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.8]
b. 24 Nov 1830 d. 12 Dec 1910
+
William Carmichael
b. 13 Oct 1832 d. 13 Nov 1910
8
Mary L. Thomson
[1.1.1.1.1.1.8.9]
b. Abt 15 Oct 1836 d. 25 Dec 1895
Beeby Carnaghan
b. 15 Jul 1831 d. 22 Sep 1919
9
Isabella Carnaghan
[1.1.1.1.1.1.8.9.1]
b. 17 May 1864 d. 9 Jan 1953
William Henry Paterson
b. 3 May 1866 d. 9 Jun 1929
10
Mary Ida Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.1.1]
b. 17 Nov 1891 d. 28 Sep 1894
9
Sarah Ida Carnaghan
[1.1.1.1.1.1.8.9.2]
b. 10 Oct 1872 d. 19 Jan 1957
Thomas Archibald Paterson
b. 17 Feb 1865 d. 4 Nov 1945
10
Frank Gordon Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1]
b. 25 Jul 1897 d. 27 May 1961
Jane Rose Hill
b. 24 Sep 1903 d. 1973
11
William Gordon Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.1]
b. 29 Jun 1930
Noreen Alberta Blackburn
12
Michael Gordon Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.1.1]
12
William Scott Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.1.2]
12
Anne Noreen Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.1.3]
11
Richard Beebe Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.2]
b. 17 Mar 1933
Phyllis Moss
12
Robert Douglas Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.2.1]
12
James Gordon Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.2.2]
11
Marcia Jane Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.3]
+
Joseph Daniel Stone
11
Robert Frank Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.4]
Judith Matthews
12
Melanie Jane Paterson
[1.1.1.1.1.1.8.9.2.1.4.1]
7
John D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.9]
b. 10 Apr 1804 d. 4 Dec 1888
Mary Walton
b. 1 Nov 1806 d. 29 Dec 1863
8
Jane Wallace Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.1]
b. 23 Oct 1829 d. 17 Nov 1904
Robert Loveless
b. 28 Jun 1825 d. 15 Jul 1906
9
Mary Alice Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.1]
b. 23 Oct 1861 d. 29 Jan 1899
Rev. Wesley Charles Walls
b. 23 Nov 1858 d. 23 Jun 1900
10
Alvin Wesley Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.1]
b. 13 May 1889 d. 2 Oct 1907
10
Robert Edgar Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.2]
b. 20 Sep 1891 d. Aug 1921
10
Mary Jane (Jennie) Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3]
b. 3 Jan 1883 d. 29 Nov 1963
Henry R. Hamilton
b. 30 Aug 1883 d. 27 Dec 1954
11
Robert Wesley Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.1]
b. 23 May 1906 d. 3 Jun 1992
11
Burton Stanley Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.2]
b. 29 Dec 1907 d. 12 Oct 1985
11
Alice Myrel Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.3]
b. 20 Jun 1909
+
Frank Barkey
11
Gladys E. Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.4]
11
Gordon Fletcher Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.5]
b. 18 Oct 1914
11
Mary Josephine Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.6]
b. 14 Feb 1917 d. 30 Nov 2003
+
John VanDriel
11
Grace Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.7]
+
Ronald Bock
11
Arthur Frederick Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.8]
b. 17 Aug 1920 d. 17 Aug 1983
11
Hazel E. Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.9]
11
Kenneth Allen Hamilton
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.3.10]
b. 27 Aug 1911 d. 20 Jan 1918
10
Rev. Alice Edith Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.4]
b. 10 Jun 1887 d. 1 Feb 1959
10
Hannah Melva Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.5]
b. 22 Apr 1896 d. 4 May 1958
William Edward Wilson
b. 23 Jan 1893 d. 9 Mar 1948
11
Ida Martha Lucille Wilson
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.5.1]
b. 9 Feb 1922
+
Garnet Buffam
11
Edgar Lorne Wilson
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.5.2]
b. 19 Sep 1919 d. 8 Mar 1989
+
Betty Louise Jones
b. 28 Aug 1929
11
Murray William Wilson
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.5.3]
b. 9 Mar 1926 d. 24 Mar 1997
11
Margaret Elaine Wilson
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.5.4]
b. 14 Feb 1928 d. 17 Jun 1967
+
Leroy Mulligan
11
Dau Wilson
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.5.5]
+
Barry Patterson
11
Mary Ellen Wilson
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.5.6]
10
John Fletcher Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.6]
b. 20 Apr 1885 d. 4 Nov 1968
Mary Ella Moorehouse
b. 15 Jun 1884 d. 1966
11
Helen Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.6.1]
11
Gerald Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.6.2]
11
Kelso Wesley Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.6.3]
b. Mar 1918 d. 31 Jan 2008
10
Rev. Charles Emerald Loveless Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.7]
b. 17 Nov 1893 d. 12 Mar 1994
Marjorie Mae DeMille
b. 27 Jan 1902 d. Abt 1994
11
Dr. Robert W. Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.7.1]
b. 1926 d. 9 Jan 2001
11
Gordon E. Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.7.2]
b. 29 Sep 1925 d. 22 Oct 2003
11
Kenneth E.F. Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.7.3]
b. Abt 1922 d. 1993
11
Carl Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.7.4]
b. Abt 1923 d. 1994
11
Marguerite Walls
[1.1.1.1.1.1.9.1.1.7.5]
b. 1924 d. 1924
9
William Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2]
b. 5 May 1863 d. 26 Apr 1931
Hattie Mildred Dudley
b. 19 Feb 1872 d. 17 Nov 1944
10
Ellen Irene Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.1]
b. 22 Sep 1892 d. 17 Dec 1963
+
Ernest Teece
b. 16 Oct 1891 d. 20 Jun 1980
10
Roy Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.2]
10
Reta May Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.3]
b. 29 Jan 1902 d. 1902
10
William Tracy Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.4]
b. 1 Sep 1899 d. 21 May 1956
Jean Alexandra Martin
b. 19 Feb 1906
11
William Martin Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.4.1]
11
Arthur John Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.4.2]
10
Maitland Dudley Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.5]
b. 17 Jun 1904
Ilean E. Simkin
11
William John Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.5.1]
11
Murray Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.5.2]
11
Gwendolyn Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.5.3]
10
Elmer Addison Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.6]
b. 15 Oct 1906 d. 10 Dec 1961
Edna May Gilchrist
11
Morley Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.6.1]
11
Muriel Mae Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.6.2]
+
Peter Lorne Ganny
11
Robert Harvey Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.6.3]
11
William Bruce Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.6.4]
10
Hillyard Murray Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.7]
b. 25 May 1908 d. Aft 1931
Lillian Robinson
b. Abt 1910
11
Doreen Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.7.1]
+
? Curran
11
William Albert Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.7.2]
10
Charles Oran Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.8]
b. 24 Jul 1913 d. 26 Dec 1980
Ruby Grove
11
James Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.8.1]
11
Brenda Bernice Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.8.2]
+
Michael Dougherty
11
Linda Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.8.3]
11
Richard Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.8.4]
10
Vera Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.9]
10
Jennie Alvera Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.10]
b. 4 Jul 1894 d. 26 Jan 1937
10
Robert Wilfred Roy Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.2.11]
b. 12 May 1896 d. 12 Feb 1923
9
John Wolstenholme Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.3]
b. 9 Sep 1865 d. 23 Dec 1931
Jane Isabella McCowan
b. 31 Dec 1875 d. 4 Nov 1964
10
Ruth Isabella Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.1]
b. 13 Apr 1902 d. 25 Sep 1922
10
Mary Alice Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.2]
b. 3 Feb 1899
Herbert Arthur White
b. Abt 1897 d. 16 Jan 1967
11
Jean White
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.2.1]
b. 25 Apr 1921
Grant Morley
12
William Morley
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.2.1.1]
11
John White
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.2.2]
b. 4 Sep 1930
Donna Williamson
12
Kenneth White
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.2.2.1]
12
Donald White
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.2.2.2]
11
Ruth White
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.2.3]
+
D. Williams
11
Robert White
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.2.4]
10
Stella Kathleen Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.3]
b. 31 May 1905
R. Edward Greig
11
James Greig
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.3.1]
11
Kenneth Greig
[1.1.1.1.1.1.9.1.3.3.2]
9
Thomas Thomson Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.4]
b. 7 Jun 1867 d. 27 Sep 1934
Annetta Edith Moorehouse
b. 7 Jan 1873 d. 28 Oct 1945
10
Thomas Owen Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.1]
b. 25 May 1903 d. Nov 1986
Hilda Martin
b. 30 Mar 1904
11
Dorothy Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.1.1]
Robert F. Nixon
12
John Nixon
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.1.1.1]
12
Jane Nixon
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.1.1.2]
11
Robert Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.1.2]
11
Dau Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.1.3]
+
Howard Campbell
11
Gerald Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.1.4]
10
Annetta Maude Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.2]
b. 12 Jan 1900 d. 9 Apr 1990
Dr. Marion E. Bovee
b. 22 Sep 1888 d. 9 Aug 1970
11
Rev. Leon Bovee
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.2.1]
11
Wayne Bovee
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.2.2]
11
Susan Bovee
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.2.3]
+
Wesley Zebley
11
Noreen Loveless Bovee
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.2.4]
b. 8 Apr 1923 d. 20 Apr 2009
10
Allan Richard Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.3]
b. 24 Mar 1906
Fidella Bedelia Cosburn
b. Abt 1910
11
Ruth Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.4.3.1]
+
Herbert Hoover
9
Rev. Elijah Edgar Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5]
b. 30 May 1870 d. 10 Mar 1931
Harriet Wheatley (Hattie) Robinson
b. 13 Dec 1877 d. 19 May 1941
10
Rev. Edgar Lloyd Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.1]
b. 14 Jan 1903 d. Nov 1986
Gladys Eleanor Richardson
b. Abt 1900
11
Robert Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.1.1]
11
Beverly Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.1.2]
11
Elizabeth Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.1.3]
11
Barbara Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.1.4]
10
Harold Wesley Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.2]
b. 24 Oct 1904 d. Jan 1987
Frances Campbell
b. Abt 1905
11
LaVerne Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.2.1]
11
Clifford Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.2.2]
11
David Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.2.3]
10
Edna Marjorie Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.3]
b. 27 Oct 1907
Rolland Hook
b. Abt 1905
11
Edward Hook
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.3.1]
10
Grace Winnifred Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.4]
b. 22 May 1911 d. 29 Jan 1969
Clarence Irwin
b. Abt 1910
11
Elaine Irwin
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.4.1]
11
Brian Irwin
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.4.2]
11
Robert Irwin
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.4.3]
10
Marion Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.5]
Carl Silverbrand
11
Silvie Silverbrand
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.5.1]
11
Joy Silverbrand
[1.1.1.1.1.1.9.1.5.5.2]
9
Hannah Ellen Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.1.6]
b. 2 Jul 1872 d. 16 Mar 1953
Rev. John Malcolm Eagle
b. 29 Dec 1864 d. 10 Jul 1936
10
Mary Alice Eagle
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.1]
b. 5 Feb 1902
Rev. George W. Stevens
11
James Stevens
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.1.1]
11
Donald Stevens
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.1.2]
11
John W. Stevens
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.1.3]
11
Trevor George Stevens
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.1.4]
10
James Gordon Eagle
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.2]
b. 20 Jan 1911
10
Robert Earl Eagle
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.3]
b. 16 Feb 1900 d. Feb 1965
10
Ora Jean Eagle
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.4]
b. 5 Jun 1905
+
Rev. Ronald C. McCallum
10
John Carlyle Eagle
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.5]
b. 3 Feb 1917 d. 1992
+
Iva Lorraine Sholer
b. 1917 d. 2006
10
Lois Eagle
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.6]
b. 4 Sep 1908
10
Leon Eagle
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.7]
10
Melburn Wattan Eagle
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.8]
b. 22 Jan 1897 d. 4 Feb 1897
10
Orpha May Eagle
[1.1.1.1.1.1.9.1.6.9]
b. 15 May 1898 d. 12 Dec 1898
8
David Guy Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2]
b. 25 Dec 1834 d. 5 Dec 1919
Emily Jane Proud
b. 23 Sep 1836 d. 4 Oct 1912
9
John Wesley Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.1]
b. 7 Jul 1859 d. Aft 1901
Mary Hannah Victoria Cuff
b. 7 Sep 1860 d. Aft 1901
10
Henry Percival Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.1.1]
b. 14 Dec 1886
10
Ida May Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.1.2]
b. 7 Nov 1888
9
Thomas Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.2]
b. 1861
9
William Norman Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.3]
b. 1862 d. 1 Oct 1939
+
Lucinda A. Walker
b. 2 Mar 1872 d. 24 Feb 1920
9
Walton Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.4]
b. 11 Jan 1866 d. 15 Jan 1907
Sarah Etta Grabb
b. 4 Feb 1871 d. Aft 1901
10
Clarence P. Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.4.1]
b. 18 Aug 1898
9
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.5]
b. 14 Oct 1866 d. 17 Dec 1956
Charles Lewis Matthew Harris
b. 2 May 1863 d. 1925
10
Frank Hubert Harris
[1.1.1.1.1.1.9.2.5.1]
b. 24 Apr 1904
10
Lewis Frederick Harris
[1.1.1.1.1.1.9.2.5.2]
b. 23 Sep 1892
10
Clarence E. Harris
[1.1.1.1.1.1.9.2.5.3]
b. 14 Sep 1894
10
Charles T. Harris
[1.1.1.1.1.1.9.2.5.4]
b. 30 Aug 1895
10
Dorothy Grace Prous Harris
[1.1.1.1.1.1.9.2.5.5]
b. 15 Sep 1900
9
Ruth Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.6]
b. 4 Mar 1868
George Clapperton
b. 5 Oct 1864
10
Jean E. Clapperton
[1.1.1.1.1.1.9.2.6.1]
b. 19 Apr 1899
10
George Clapperton
[1.1.1.1.1.1.9.2.6.2]
b. 4 Jul 1900
9
David Lapsley Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.7]
b. 25 Nov 1869 d. 21 Apr 1951
Eda Isabel Nisbet
b. Abt 1882
10
John Nisbet Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.7.1]
b. 19 Nov 1921 d. 7 Mar 1944
9
Maitland Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.8]
b. 19 Dec 1872
Allison Bain Simpson
b. 1875 d. 29 Nov 1964
10
Maitland Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.8.1]
d. died
9
Percival H. Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.2.9]
b. 14 Dec 1886
8
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.3]
b. 28 Feb 1831 d. 14 Apr 1875
Rev. Thomas Dudley
b. 1821
9
Mary Jane Dudley
[1.1.1.1.1.1.9.3.1]
b. 3 Mar 1869
9
Hattie Mildred Dudley
[1.1.1.1.1.1.9.3.2]
b. 19 Feb 1872 d. 17 Nov 1944
William Loveless
b. 5 May 1863 d. 26 Apr 1931
10
Ellen Irene Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.1]
b. 22 Sep 1892 d. 17 Dec 1963
+
Ernest Teece
b. 16 Oct 1891 d. 20 Jun 1980
10
Roy Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.2]
10
Reta May Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.3]
b. 29 Jan 1902 d. 1902
10
William Tracy Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.4]
b. 1 Sep 1899 d. 21 May 1956
Jean Alexandra Martin
b. 19 Feb 1906
11
William Martin Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.4.1]
11
Arthur John Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.4.2]
10
Maitland Dudley Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.5]
b. 17 Jun 1904
Ilean E. Simkin
11
William John Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.5.1]
11
Murray Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.5.2]
11
Gwendolyn Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.5.3]
10
Elmer Addison Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.6]
b. 15 Oct 1906 d. 10 Dec 1961
Edna May Gilchrist
11
Morley Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.6.1]
11
Muriel Mae Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.6.2]
+
Peter Lorne Ganny
11
Robert Harvey Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.6.3]
11
William Bruce Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.6.4]
10
Hillyard Murray Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.7]
b. 25 May 1908 d. Aft 1931
Lillian Robinson
b. Abt 1910
11
Doreen Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.7.1]
+
? Curran
11
William Albert Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.7.2]
10
Charles Oran Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.8]
b. 24 Jul 1913 d. 26 Dec 1980
Ruby Grove
11
James Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.8.1]
11
Brenda Bernice Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.8.2]
+
Michael Dougherty
11
Linda Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.8.3]
11
Richard Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.8.4]
10
Vera Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.9]
10
Jennie Alvera Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.10]
b. 4 Jul 1894 d. 26 Jan 1937
10
Robert Wilfred Roy Loveless
[1.1.1.1.1.1.9.3.2.11]
b. 12 May 1896 d. 12 Feb 1923
8
Thomas Graham Thomson
[1.1.1.1.1.1.9.4]
b. 16 Nov 1842 d. 19 Jun 1933
7
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.10]
b. 10 Jun 1807 d. 9 Dec 1879
John Walton
b. 15 Mar 1799 d. 11 May 1877
8
Ellen Elizabeth Walton
[1.1.1.1.1.1.10.1]
b. 31 Mar 1825 d. 5 Apr 1888
Francis Thompson
b. 15 Aug 1821 d. 18 Mar 1890
9
William Wallace Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.1]
b. 10 Sep 1847 d. 22 Mar 1914
Janet Armstrong
b. 11 Jan 1849 d. 2 Nov 1917
10
Janet Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.1]
b. 9 Apr 1877
Frank Edwin Walton
b. 10 Aug 1872
11
Ruby V Walton
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.1.1]
b. 29 May 1897
Victor Cook
12
Janet Cook
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.1.1.1]
12
Frank Cook
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.1.1.2]
12
Roy Cook
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.1.1.3]
11
Frank M Walton
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.1.2]
b. 3 Sep 1898
Mary Jane Martin
12
Thomas David Walton
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.1.2.1]
10
Helena (Nellie) Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.2]
b. 10 Dec 1878
+
David Guy
10
Frank Ashley Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.3]
b. 18 Jun 1881 d. 13 Nov 1882
10
Walter Armstrong Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.4]
b. 31 Aug 1885 d. 16 Apr 1892
10
William David Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.5]
b. 28 Jun 1892
Cecilia Ethel Larocque
b. Abt 1900
11
Janet Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.1.5.1]
9
Mary Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.2]
b. 27 Aug 1850 d. 3 Jun 1906
9
David Walton Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.3]
b. 21 Oct 1853 d. Bef 1901
Fannie Mason
b. 16 May 1858
10
Nella Irene Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.3.1]
b. 21 Nov 1885
+
Arthur Gurney Hudson
b. Abt 1886
9
Hannah Janet Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.4]
b. 18 Apr 1855 d. 27 Oct 1912
9
Helen Isabella Thompson
[1.1.1.1.1.1.10.1.5]
b. 18 Aug 1858 d. 29 Sep 1932
8
Thomas Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2]
b. 12 Jan 1828 d. 17 Apr 1876
Frances (Fanny) Scott
b. 4 Mar 1835 d. 13 Dec 1907
9
David Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.1]
b. 1855 d. 31 Aug 1866
9
William Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.2]
b. 1856 d. 11 Mar 1857
9
Mary Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.3]
b. Jul 1862 d. Between 1920 and 1930
Charles Stephen Scrivens
b. Jun 1857 d. Bef 1910
10
Mary L. Scrivens
[1.1.1.1.1.1.10.2.3.1]
b. 1883
10
Alice Scrivens
[1.1.1.1.1.1.10.2.3.2]
b. 1885
Robert A. Boyle
b. 1885
11
Katherine E. Boyle
[1.1.1.1.1.1.10.2.3.2.1]
b. Abt 1906
11
Margaret A. Boyle
[1.1.1.1.1.1.10.2.3.2.2]
b. Abt 1907
10
Charles Scrivens
[1.1.1.1.1.1.10.2.3.3]
b. 1888
May
b. Abt 1887
11
William Scrivens
[1.1.1.1.1.1.10.2.3.3.1]
b. 1908
11
Kathrine Scrivens
[1.1.1.1.1.1.10.2.3.3.2]
b. Abt 1907
9
William Albert Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.4]
b. 11 Sep 1865 d. 1934
Mary Ann Mason
b. 22 Apr 1872 d. 1935
10
William E Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.4.1]
b. 23 Nov 1898 d. Aft 1911
10
Edith Cherry Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.4.2]
b. 19 Mar 1901
+
Louis J. Martin
10
W. Earl Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.4.3]
Mary Martin
11
Keith Martin Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.4.3.1]
10
Olive Elizabeth Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.4.4]
b. 25 Dec 1904
+
William Henry White
b. 1893 d. 24 Apr 1964
9
John Wallace Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5]
b. 24 Feb 1860 d. 20 Mar 1932
Polly Mary Brown
b. 22 Sep 1857 d. 13 Jun 1933
10
Sarah Isabella Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1]
b. 2 May 1886 d. 24 Feb 1969
Lorenza Herbert Walton
b. 11 Jun 1880 d. 29 May 1957
11
Olive Isabell Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.1]
b. 22 Jan 1907 d. 11 Jun 1985
William James Riddell
12
Lorna Riddell
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.1.1]
12
Mary Riddell
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.1.2]
12
Lois Riddell
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.1.3]
12
Roy Riddell
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.1.4]
11
Ross Lorenzo Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.2]
b. 31 Oct 1908 d. 16 Dec 1971
Dorothy Kelly
12
Ross Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.2.1]
12
Isabella Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.2.2]
[
=>
]
12
Joan Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.2.3]
12
Ruth Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.2.4]
11
Margaret Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.3]
Earlby R Gooderham
12
Myrel Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.3.1]
12
Ross Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.3.2]
11
Myrtle Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.4]
Walter W Craig
12
Mary Craig
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.4.1]
12
John Craig
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.4.2]
12
James Craig
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.4.3]
11
Lloyd George Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.5]
Ona Armstrong
12
Ronald Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.5.1]
12
Donald Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.5.2]
12
Joyce Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.1.5.3]
10
Fanny Ethel Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.2]
b. 28 Mar 1883 d. 13 Oct 1971
David Forfar
b. 25 Nov 1878 d. 17 Jul 1967
11
Mildred Elsie Forfar
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.2.1]
b. 25 Mar 1908 d. 19 Apr 2006
Robert John Thomson
b. 3 Dec 1904 d. 15 Sep 1974
12
John David Thomson
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.2.1.1]
[
=>
]
12
William Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.2.1.2]
12
Robert Allan Thomson
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.2.1.3]
[
=>
]
11
Mary Winnifred Forfar
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.2.2]
b. 26 Apr 1910 d. 2 Feb 1987
11
John David Albert Forfar
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.2.3]
b. 25 Aug 1912 d. 7 Mar 1945
10
Mary Ellen (Nellie) Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.3]
b. 1 Jul 1887 d. 27 Feb 1975
Joseph Archibald Forfar
b. 27 Feb 1883 d. 22 Jul 1968
11
Margorie Forfar
[1.1.1.1.1.1.10.2.5.3.1]
b. 11 Oct 1905 d. 12 Sep 1968
9
Thomas A Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.6]
b. 2 Dec 1867 d. 1951
Elizabeth C. Pettifer
b. 3 Apr 1877 d. 16 Dec 1969
10
Fred Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.6.1]
b. 27 Oct 1903
Jessie McGonagle
11
John Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.6.1.1]
11
Fred Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.6.1.2]
11
Eric Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.6.1.3]
10
Fanny Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.6.2]
b. Aug 1906
+
Samson Good
d. 18 Mar 1970
10
George Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.6.3]
b. Oct 1907
+
Gertrude
9
Lavina Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.7]
b. 4 Feb 1858 d. 1923
William Brown
b. 4 Mar 1856 d. 1923
10
Thomas Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.1]
b. 2 Nov 1880 d. Mar 1952
Emily Jane Danby
b. 19 Sep 1886 d. 21 May 1958
11
Dora May Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.1.1]
d. INFANT
11
Grace Lillian Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.1.2]
b. 9 Nov 1910
Murray Walton
12
Ann Marie Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.1.2.1]
11
Mary Helen Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.1.3]
b. 19 Jan 1915
+
Harold Dickinson
b. 25 Feb 1907
11
John Thomas Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.1.4]
b. 11 Jun 1923
Betty Wiltshire
b. 10 Oct 1924
12
John Hartley Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.1.4.1]
12
Pamela Caroline Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.1.4.2]
10
David Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2]
b. 10 Sep 1881 d. 11 Dec 1958
Agnes Scott Gibson
b. 17 Nov 1887 d. 17 Sep 1956
11
Douglas Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.1]
b. Mar 1908
Mary Allen
12
Gwendolyn Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.1.1]
[
=>
]
12
Eleanor Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.1.2]
11
William Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.2]
Gladys Newell
12
Barbara Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.2.1]
12
David Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.2.2]
11
Adam Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.3]
b. 20 Apr
Alice French
12
Allan Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.3.1]
12
Catherine Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.3.2]
11
Janet Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.4]
b. Jul 1910
Bert Nichols
12
Robert Nichols
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.2.4.1]
10
Francis Melville Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.3]
b. 30 Aug 1883 d. 22 May 1948
+
Florence Garbut
Jesse Irene Morris
b. Abt 1891
11
Budwin Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.3.1]
12
Susan Jane Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.3.1.1]
10
Edith Alice (Allie) Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.4]
b. 30 Dec 1885
+
Charles William Wilson
b. Abt 1868
10
Idella May Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.5]
b. 27 Jan 1898
Norman Stanley Williamson
b. Abt 1896
11
Dorothy Williamson
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.5.1]
+
Lloyd Hales
10
Myrtle I. Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.6]
b. 27 Sep 1900
Howard Grant
11
Joan Grant
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.6.1]
11
Shirley Grant
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.6.2]
10
Emily L. Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.7]
b. 11 Jan 1894
+
Roy A. Sullivan
b. Abt 1893
10
Hilton R. Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.8]
b. 10 Jan 1888
Myrtle Candy
11
Edward Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.8.1]
Brenda
12
Craig Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.8.1.1]
11
John Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.8.2]
Marjorie
12
Paul Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.8.2.1]
12
Catherine Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.8.2.2]
10
Edward Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.9]
10
John Brown
[1.1.1.1.1.1.10.2.7.10]
9
George Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.8]
b. 1870 d. 17 Dec 1870
9
Frank Edwin Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.9]
b. 10 Aug 1872
Janet Thompson
b. 9 Apr 1877
10
Ruby V Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.9.1]
b. 29 May 1897
Victor Cook
11
Janet Cook
[1.1.1.1.1.1.10.2.9.1.1]
11
Frank Cook
[1.1.1.1.1.1.10.2.9.1.2]
11
Roy Cook
[1.1.1.1.1.1.10.2.9.1.3]
10
Frank M Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.9.2]
b. 3 Sep 1898
Mary Jane Martin
11
Thomas David Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.9.2.1]
9
Alice Walton
[1.1.1.1.1.1.10.2.10]
b. Abt 1876
+
John E. Armstrong
b. Abt 1873
8
William Wallace Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3]
b. 10 Mar 1834 d. Bef 1901
Caroline Brooks
b. 17 Jun 1835 d. 10 May 1929
9
Emily Jane Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.1]
b. 1856
+
Robert Armstrong
9
John E Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.2]
b. 13 Nov 1856 d. 28 Dec 1940
Jane Brown
b. Mar 1859 d. 16 Jun 1895
10
Mary Minette Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.1]
b. 23 Oct 1880 d. 28 Feb 1941
10
Albert Deforest Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.2]
b. 31 Jul 1883
+
Mary Maud Dunk
b. Abt 1883
10
Emily May Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3]
b. 15 Jan 1885 d. 6 Oct 1969
Andrew Clancy
b. 9 May 1878 d. 3 Feb 1963
11
Albert David Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.1]
b. 17 Aug 1905 d. 3 Oct 1973
11
Andrew Harvey Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.2]
b. 4 Jun 1907
+
Violet Thomson
11
Emily Annabelle Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.3]
b. 16 Jan 1909 d. 1993
11
Wilfred Ross Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.4]
b. 8 Oct 1911 d. 1991
11
Richard Leslie Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.5]
b. 13 Jul 1913 d. 1987
Glenna
12
Shirley Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.5.1]
12
Sonny Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.5.2]
11
Malcom Arnold Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.6]
b. 8 Jul 1915 d. 1982
Martha W. Rathage
b. 1923 d. 1985
12
Glen Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.6.1]
12
Neil Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.6.2]
12
Roy Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.6.3]
11
Francis Earl Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.7]
b. 4 Oct 1917
+
Margaret Boston
11
Eva Caroline Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.8]
b. 6 Apr 1919 d. 1997
11
Ruby Esther Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.9]
b. 26 Mar 1921 d. 1 Apr 1999
Anthony Glowacki
12
Raymond Daryle Glowacki
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.9.1]
[
=>
]
11
James Edward Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.10]
b. 25 Aug 1923 d. 1968
Doreen Mogenson
12
Douglas Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.10.1]
12
Joyce Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.10.2]
11
Norman Weslry Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.11]
b. 12 Jul 1925 d. 1 Aug 2002
Louise
12
Wayne Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.11.1]
12
Bruce Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.11.2]
11
Olive Minette Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.12]
b. 9 Feb 1927
Michael James Glowacki
12
Melora Dawn Glowacki
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.12.1]
[
=>
]
11
Gerald Valens Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.13]
b. 10 Feb 1929 d. 4 Nov 1985
+
Edna Lenore Brock
b. 1932 d. 1988
11
Inez Bernice Clancy
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.3.14]
b. 29 Dec 1930
+
William John Graham
10
Annie L Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.4]
b. 15 Apr 1888
+
Dick Wright
10
Olive I Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.5]
b. 26 Feb 1890
Frederick Thomas Henderson
b. Abt 1885
11
Evelyn Henderson
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.5.1]
11
Kenneth Henderson
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.5.2]
10
Ida Myrtle Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.6]
b. 27 Aug 1893 d. 23 Feb 1968
Alfred Armstrong
b. 23 May 1889 d. 9 Mar 1952
11
Mrytle Armstrong
[1.1.1.1.1.1.10.3.2.6.1]
+
Ray Ferguson
9
William Wallace Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3]
b. 1 Apr 1861 d. 17 May 1923
Ellen Agnes Buchanan
b. 28 Mar 1861 d. 10 Mar 1959
10
Emily Grace Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.1]
b. 4 Jul 1882 d. 11 Apr 1961
Alfred Charles Mason
b. 14 Dec 1879 d. 28 Apr 1936
11
Ruth Myrtle Mason
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.1.1]
b. 6 Feb 1908
11
William Albert Allan Mason
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.1.2]
b. 27 Dec 1907
11
Herbert Mason
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.1.3]
b. 25 Dec 1915 d. 24 Feb
11
Jean Mason
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.1.4]
b. 24 Apr 1909
11
Edna Mason
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.1.5]
b. Mar 1911
10
Ida May Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.2]
b. 8 May 1884 d. 9 Feb 1892
10
Allan Colin Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.3]
b. 19 Apr 1886 d. 2 Mar 1904
10
Janet Amelia Alton Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.4]
b. 16 Mar 1889 d. 1932
Ernest Miller
b. Abt 1886
11
Robert Miller
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.4.1]
11
William Miller
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.4.2]
10
Albert McKenzie Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.5]
b. 28 Apr 1892 d. 19 Sep 1958
Clara Mae Martin
b. Abt 1895
11
Helen Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.5.1]
11
John Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.5.2]
+
Margaret Sewell
11
William Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.5.3]
+
Greta Isobel Penny
11
Lois Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.5.4]
+
Allan Murray
10
John Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.6]
b. 16 Aug 1894 d. 16 Aug 1894
10
William Buchanan Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.7]
b. 16 Aug 1894
10
Robert Lawrence Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.8]
b. 4 Oct 1897
Florence Pollard
11
Wesley Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.8.1]
12
Mark Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.8.1.1]
10
Charles N Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.3.9]
b. 1900 d. 1900
9
Albert E. Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.4]
b. 22 Dec 1869
+
Margaret P. MacFarlane
b. 22 Mar 1870
9
David Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.5]
b. 10 Jun 1867 d. Feb 1964
+
Lavina Charlton
b. 13 Aug 1866
9
Mary Ida Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.6]
b. 1864
+
John Steers
b. Abt 1856
9
Charles Wesley Walton
[1.1.1.1.1.1.10.3.7]
b. 13 May 1872
8
John Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4]
b. 29 Oct 1835 d. 27 Jul 1912
Margaret Brooks
b. 14 Mar 1840 d. 12 Aug 1904
9
Annie Maria Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.1]
b. 10 Jul 1858 d. 22 Jun 1935
David Drummond
b. 13 Feb 1854 d. 4 Dec 1919
10
H Noel Drummond
[1.1.1.1.1.1.10.4.1.1]
b. 29 Oct 1882 d. 14 Jun 1968
Elthera Amelia Maines
b. 1881 d. 23 Dec 1924
11
Muriel Drummond
[1.1.1.1.1.1.10.4.1.1.1]
b. 7 Dec 1924
+
Thomas Albert Jackson
b. 23 Mar 1925
Irene E Beamish
b. 1901 d. 28 Mar 1985
11
Margaret Drummond
[1.1.1.1.1.1.10.4.1.1.2]
+
K.A. Moores
10
David Roy Drummond
[1.1.1.1.1.1.10.4.1.2]
b. 22 Feb 1895 d. 6 Aug 1961
Edna May Salmon
b. 14 Jun 1896 d. 9 Jan 1980
11
Ruth Drummond
[1.1.1.1.1.1.10.4.1.2.1]
+
Grant Ferguson
9
James Edward Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2]
b. 20 Jul 1860 d. 14 Aug 1930
Mary Jane Slack
b. 1 Aug 1862
10
George Ernest Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.1]
b. 14 Sep 1884 d. 4 Mar 1966
Lottie Fountain
b. Abt 1887
11
Charles Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.1.1]
10
Albert Leonard Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.2]
b. 8 May 1881
Annie Edgar
b. 1 Nov 1881
11
Howard Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.2.1]
+
Josephine
11
James Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.2.2]
Hazel
12
Edgar Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.2.2.1]
12
Donald Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.2.2.2]
10
Howard Gordon Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.3]
b. 15 Oct 1886
Jessie Willena Grylls
b. 2 Feb 1889
11
James Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.3.1]
10
Charles C. Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.4]
b. 8 Sep 1889
Merle Horton
d. 9 Oct 1961
11
J. Paul Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.4.1]
+
Patricia Rice
10
Verna L. Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.5]
b. 18 Dec 1900
+
Donald Cameron
10
Gladys M. Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.2.6]
b. 28 Dec 1898
+
Clarence Dobson
9
Margaret Isabella Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.3]
b. 26 Aug 1870 d. 14 Jun 1954
Thomas Franklin Mason
b. 26 Mar 1869 d. 30 Jul 1949
10
Franklin Irving Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.1]
b. 8 Jul 1893
+
Georgina Bond Elliot
d. 4 Jul 1959
10
Howard Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.2]
b. 1 Sep 1895 d. 4 Aug 1909
10
Thomas Earl Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.3]
b. 17 Aug 1897 d. 27 Jul 1977
Meta
11
Joyce Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.3.1]
+
Ted Stevens
11
Helen Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.3.2]
+
Robert White
11
Vernon Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.3.3]
10
Arthur Walton Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.4]
b. 1 Feb 1900 d. 24 Mar 1977
10
Mabel Isabel Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.5]
b. 4 Jun 1910 d. 20 Jun 1910
10
Edward Bruce Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.6]
b. 9 Oct 1901 d. 13 Jun 1988
Ruth
11
Robert Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.6.1]
11
Roy Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.6.2]
11
Mary Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.6.3]
11
Joan Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.6.4]
11
Gordon Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.6.5]
10
Alfred Lindsay Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.7]
b. 4 Mar 1904
Eva Fenn
11
Marilyn Anne Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.7.1]
b. 1939 d. 1939
11
Carol Anne Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.7.2]
+
Ronald William Walters
11
Donald John Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.7.3]
10
Frederick James Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.8]
b. 12 Jan 1906 d. Aug 1996
Ethel Mabel Armstrong
b. 28 May 1910 d. 21 Nov 1965
11
Verna Irene Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.8.1]
+
B. Skuffman
11
Betty Jean Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.8.2]
b. 18 Jul 1931
+
James Douglas Batty
b. 8 Jul 1929
11
Lloyd James Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.8.3]
b. 15 Nov 1928
11
Margaret Alberta Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.8.4]
+
G. Yaleley
11
Thomas Edmund Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.8.5]
b. 7 Apr 1930
11
Edna Hazel Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.8.6]
+
M. Poulson
11
Harold Robert Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.8.7]
b. 6 Feb 1933
10
Reginald Brooks Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.9]
b. 12 Aug 1907 d. 25 Jun 1990
10
Margaret Merle Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.3.10]
b. 16 Nov 1908
9
John Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.4]
b. 13 Jan 1868 d. 8 Jul 1955
Estella Howe
b. 29 Sep 1873 d. 1959
10
Mildred Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.4.1]
b. 24 Sep 1898
10
Russell Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.4.2]
b. 3 Jan 1901
10
Irene Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.4.3]
b. 29 Jun 1904
+
N. Alcorn
10
Wilma Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.4.4]
b. 27 Jul 1906
10
Noel Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.4.5]
b. 6 Aug 1911
9
Thomas Thomson Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.5]
b. 27 Apr 1873 d. 4 Feb 1953
Hannah Amelia Pherrill
b. 17 Nov 1881 d. 1 Feb 1960
10
Hazel Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.5.1]
b. 2 Jul 1904
Harold F. Evans
b. 31 Mar 1901 d. 11 Nov 1952
11
Margaret Evans
[1.1.1.1.1.1.10.4.5.1.1]
+
John Roberts
9
Lillian Loretta (Lillie) Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.6]
b. 2 Sep 1875 d. 21 Aug 1960
9
Charles Ward Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.7]
b. 2 Sep 1875 d. 22 Mar 1953
Mary Ann Sackett
10
Albert Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.7.1]
Isabella
11
Charles Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.7.1.1]
9
Archibald Ashford Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.8]
b. 26 Mar 1878 d. 1 Sep 1961
Elizabeth Weir
b. 9 Jan 1877 d. 17 Mar 1942
10
Ashford Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.8.1]
b. 28 Oct 1905
10
Stanley Irwin Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.8.2]
b. Nov 1910
10
Francis (Frank) Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.8.3]
b. Nov 1908
10
Violet Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.8.4]
b. 28 May 1912
Joseph Bloom
d. 1958
11
Shirley Bloom
[1.1.1.1.1.1.10.4.8.4.1]
11
Faye Rosella Bloom
[1.1.1.1.1.1.10.4.8.4.2]
+
Gordon Clifford Money
11
Carol Bloom
[1.1.1.1.1.1.10.4.8.4.3]
9
Lorenza Herbert Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9]
b. 11 Jun 1880 d. 29 May 1957
Sarah Isabella Walton
b. 2 May 1886 d. 24 Feb 1969
10
Olive Isabell Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.1]
b. 22 Jan 1907 d. 11 Jun 1985
William James Riddell
11
Lorna Riddell
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.1.1]
+
Julian Pristanski
11
Mary Riddell
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.1.2]
+
Lorne Buck
11
Lois Riddell
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.1.3]
11
Roy Riddell
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.1.4]
10
Ross Lorenzo Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.2]
b. 31 Oct 1908 d. 16 Dec 1971
Dorothy Kelly
11
Ross Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.2.1]
+
Caroline Armstrong
11
Isabella Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.2.2]
Stanley Roberts
12
William Roberts
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.2.2.1]
12
Mark Roberts
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.2.2.2]
11
Joan Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.2.3]
11
Ruth Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.2.4]
10
Margaret Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.3]
Earlby R Gooderham
11
Myrel Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.3.1]
+
Fred Allard
11
Ross Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.3.2]
10
Myrtle Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.4]
Walter W Craig
11
Mary Craig
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.4.1]
+
Ed Smurthwaite
11
John Craig
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.4.2]
11
James Craig
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.4.3]
10
Lloyd George Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.5]
Ona Armstrong
11
Ronald Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.5.1]
11
Donald Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.5.2]
11
Joyce Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.9.5.3]
9
Sarah Helen Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.10]
b. 22 Mar 1884 d. 28 Nov 1976
9
Mary Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.11]
b. 1 Sep 1862 d. 2 Jan 1936
William Mason
b. 6 Aug 1860 d. 4 Feb 1947
10
Hermie Iva Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.1]
b. 31 Oct 1889
+
Andrew Allen
b. Abt 1889
10
William Cedric Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.2]
b. 30 Apr 1891
+
Eva Pepper
b. Abt 1894
10
Charles Henderson Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3]
b. 14 Nov 1892
Gladys Josephine Stenabaugh
b. Abt 1895
11
Dawn Evelyn Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.1]
b. 7 Jul 1930
William Morris Robinson
b. 22 Jan 1915 d. 26 Oct 1976
12
Kathryn Evelyn Robinson
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.1.1]
12
Steven Charles Robinson
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.1.2]
[
=>
]
12
Stanley William Robinson
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.1.3]
b. 23 Dec 1961 d. 21 Sep 1980
12
Paul Stewart Robinson
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.1.4]
[
=>
]
12
Karen Elizabeth Robinson
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.1.5]
[
=>
]
12
Brenda Arlene Robinson
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.1.6]
11
Helen Jean Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.2]
b. 14 Apr 1922
Franklin George Tamblyn
b. 1924 d. 3 Oct 2005
12
Robert Charles Tamblyn
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.2.1]
[
=>
]
12
Linda Jean Tamblyn
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.2.2]
[
=>
]
12
Patricia Ann Tamblyn
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.2.3]
12
William Paul Tamblyn
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.2.4]
12
Elaine Margaret Tamblyn
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.2.5]
11
Marion Josephine Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.3]
b. 29 Jun 1924
11
Shirley Margaret Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.4]
b. 12 Feb 1926 d. 1 Jul 19??
+
Bruce Sutherland
11
Phyllis Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.3.5]
b. 1932 d. 1934
10
Percy Lorenzo Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.4]
b. 13 Oct 1894
10
Margaret Isabella Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.5]
b. 29 Feb 1896 d. 30 Mar 1955
10
Mary Estelle Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.6]
b. 5 Feb 1898
Stanley Wilber Rosebrugh
b. 1896 d. 1952
11
Ina Grace Rosebrugh
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.6.1]
b. 20 Jul 1920
+
Alfred T. Williams
11
Glenford Wilbur Rosebrugh
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.6.2]
b. 17 Sep 1922
11
Herbert Lorne Rosebrugh
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.6.3]
b. 5 Mar 1933
10
Thomas Lloyd Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.7]
b. 29 Dec 1899 d. 23 Sep 1958
Freida Jane Hinan
b. Abt 1898
11
Frederick Lloyd Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.7.1]
b. 12 Aug 1924
11
Anna Marilyn Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.7.2]
b. 7 Jan 1932
+
Ernest Little
11
Joseph Edward Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.7.3]
b. 6 Oct 1926
10
Herbert Ashford Mason
[1.1.1.1.1.1.10.4.11.8]
b. 4 Sep 1901
9
Susannah Walton
[1.1.1.1.1.1.10.4.12]
b. 11 Jul 1865 d. 16 Sep 1951
William Hobbs
b. Abt 1860
10
Rena Hobbs
[1.1.1.1.1.1.10.4.12.1]
10
Margaret Hobbs
[1.1.1.1.1.1.10.4.12.2]
8
Guy Walton
[1.1.1.1.1.1.10.5]
b. 15 Nov 1839 d. 24 May 1910
Isabella McLevin
b. 24 Aug 1839 d. 13 Mar 1912
9
John Wesley Walton
[1.1.1.1.1.1.10.5.1]
b. 6 Oct 1876 d. 5 Jan 1947
Margaret Edith Green
b. 24 Feb 1876 d. 27 Jul 1945
10
Eva Walton
[1.1.1.1.1.1.10.5.1.1]
10
William Guy Walton
[1.1.1.1.1.1.10.5.1.2]
b. 1 Dec 1919
+
Ethel Elizabeth Gibb
b. 1917 d. 1976
10
Jean Walton
[1.1.1.1.1.1.10.5.1.3]
Clarence Wallace
11
Kenneth Wallace
[1.1.1.1.1.1.10.5.1.3.1]
11
Carol Wallace
[1.1.1.1.1.1.10.5.1.3.2]
11
Norma Wallace
[1.1.1.1.1.1.10.5.1.3.3]
9
Archibald A G Walton
[1.1.1.1.1.1.10.5.2]
b. 27 May 1878 d. 7 Nov 1941
9
Isabella Mary Walton
[1.1.1.1.1.1.10.5.3]
b. 16 Sep 1881 d. 20 Apr 1961
8
Isabella Walton
[1.1.1.1.1.1.10.6]
b. 25 Jan 1842 d. 18 Feb 1920
William Ezekiel Gooderham
b. 6 May 1843 d. 15 Mar 1917
9
David W Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.1]
b. Jan 1870 d. 9 Aug 1875
9
Walter Worts Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.2]
b. 5 Aug 1872 d. 14 Mar 1925
9
Mary Henrietta Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.3]
b. 27 Sep 1874
Robert Dunn Buchanan
b. 5 May 1871 d. 20 Sep 1965
10
Isabella Elizabeth Buchanan
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.1]
b. 23 Oct 1902
Walter Rutherford
11
Douglas Rutherford
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.1.1]
11
Ainslea Rutherford
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.1.2]
10
Mary Roberta Buchanan
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.2]
b. 13 Jul 1906
David T Martin
b. 13 Apr 1901 d. 13 Sep 1954
11
Mary Martin
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.2.1]
Frank Cook
12
Thomas David Cook
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.2.1.1]
11
Jean Martin
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.2.2]
11
Peter Martin
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.2.3]
11
William Martin
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.2.4]
10
Helen Jean Buchanan
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.3]
b. 11 Nov 1911
+
Gordon A. Milne
10
Robert William John Buchanan
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.4]
b. 6 May 1919
Lena Goodwin
11
Randolph Robert John Buchanan
[1.1.1.1.1.1.10.6.3.4.1]
9
Hattie Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.4]
b. Jul 1876 d. 20 Aug 1876
9
William Herbert Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.5]
b. 17 Mar 1878
Agnes Winifred Thomson
b. 27 Apr 1879 d. 1942
10
Rita Isabella Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.1]
b. 1905 d. 29 May 1945
William John Brumwell
b. 24 May 1900 d. 30 Mar 1945
11
Norma Isobel Brumwell
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.1.1]
b. 6 Aug 1931
John Bruce Williams
12
James Bruce Williams
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.1.1.1]
12
John Colin Williams
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.1.1.2]
11
John Gooderham Brumwell
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.1.2]
b. 1 Nov 1933
Margaret Eva Hood
12
Julie Elizabeth Brumwell
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.1.2.1]
b. 1 Nov 1959 d. 1 Nov 1959
12
Diane Rita Brumwell
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.1.2.2]
12
Margaret Lynn Brumwell
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.1.2.3]
10
Mary Evelyn Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2]
b. 1907
Harry Hollingsworth Barber
11
Mary Evelyn Barber
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.1]
b. 22 Dec 1927
Donald William Matthews
12
Donald William Matthews
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.1.1]
12
Mary Evelyn Matthews
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.1.2]
11
Betty Eleanor Barber
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.2]
b. 27 May 1930
Walter Gordon Jefferies
12
James Walker Jefferies
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.2.1]
12
Roy Harry Jefferies
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.2.2]
12
Brian William Jefferies
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.2.3]
12
Ruth Elizabeth Jefferies
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.2.4]
11
Kathleen Agnes Barber
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.3]
b. 4 Feb 1932
Neil Darrel Brown
12
Neil Darrel Merton Brown
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.3.1]
12
Paul Lindsay Brown
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.3.2]
12
Cynthia Ellen Brown
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.3.3]
11
Marjorie Rita Barber
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.4]
+
Gordon W. Davie
11
Harry Hollingsworth Barber
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.5]
11
David Wilmer Barber
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.2.6]
10
William George Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.3]
b. 1908 d. 25 Apr 1968
+
Muriel Skelhorn
10
Murray Glendinning Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.4]
b. 1910
10
Elinor Jean Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.5]
b. 1921
Colin Wilson Hannah
11
Brian William Hannah
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.5.1]
11
Barbara Jean Hannah
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.5.2]
11
Scott Hannah
[1.1.1.1.1.1.10.6.5.5.3]
9
Ethel Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.6]
b. Jul 1882 d. 23 Aug 1882
9
Ineous E Gooderham
[1.1.1.1.1.1.10.6.7]
b. Jan 1888 d. 27 Apr 1888
8
David Walton
[1.1.1.1.1.1.10.7]
b. 7 Jun 1830 d. 4 Dec 1850
8
Archibald Walton
[1.1.1.1.1.1.10.8]
b. 13 Apr 1844 d. 6 Apr 1845
8
Mary Walton
[1.1.1.1.1.1.10.9]
b. 23 Jun 1837 d. 20 Mar 1876
+
James Taylor
b. Abt 1835
8
Janet (Jennie) Walton
[1.1.1.1.1.1.10.10]
b. 7 Jan 1832 d. 14 Aug 1902
William Giles
b. 25 May 1834 d. 30 Mar 1887
9
John Lapsley Giles
[1.1.1.1.1.1.10.10.1]
b. 13 May 1867 d. 12 Feb 1940
Harriet Eva Pearson
b. 15 Apr 1868 d. 1 Oct 1913
10
Janet Myrtle Giles
[1.1.1.1.1.1.10.10.1.1]
b. 5 Sep 1891 d. 28 Dec 1979
+
Garnet Beatty Dawson
b. 18 Jul 1896 d. 10 Jun 1968
10
William Slater Giles
[1.1.1.1.1.1.10.10.1.2]
b. 11 Dec 1892
10
John Franklin Giles
[1.1.1.1.1.1.10.10.1.3]
b. 30 Mar 1896
+
Ella Marion Harper
b. 1896
10
Ada Ellen Giles
[1.1.1.1.1.1.10.10.1.4]
b. 12 Sep 1898
+
Fred Smith
b. 1898
10
Eva Margaret Giles
[1.1.1.1.1.1.10.10.1.5]
b. 25 Feb 1904 d. 7 May 1982
Howard Dwight Hicks
b. 28 Sep 1896 d. 4 Jan 1970
11
Margaret Hicks
[1.1.1.1.1.1.10.10.1.5.1]
10
Mary Giles
[1.1.1.1.1.1.10.10.1.6]
b. Mar 1906
8
Thomson Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11]
b. 17 Oct 1849 d. 1916
Annie Palmer
b. 31 Jul 1856 d. 15 May 1934
9
John Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.1]
b. 19 Nov 1875 d. 10 Mar 1878
9
Mary Ida Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.2]
b. 5 Feb 1878 d. Aft 24 Sep 1944
9
Sarah Mabel Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.3]
b. 1879 d. 3 Jul 1881
9
Edith Louise Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.4]
b. 31 May 1884 d. 1 Jul 1935
James Joseph Teskey
b. 10 Jan 1875 d. 1 Jun 1925
10
Grace Teskey
[1.1.1.1.1.1.10.11.4.1]
10
Alvin Teskey
[1.1.1.1.1.1.10.11.4.2]
10
Norman Teskey
[1.1.1.1.1.1.10.11.4.3]
10
Evelyn Teskey
[1.1.1.1.1.1.10.11.4.4]
10
Carson Teskey
[1.1.1.1.1.1.10.11.4.5]
b. 19 Dec 1902
+
Gladys Glaziert
b. 11 Sep 1902
10
Vera Teskey
[1.1.1.1.1.1.10.11.4.6]
b. 16 Oct 1905
+
Gary Loveless
9
William Gordon Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.5]
b. 1 May 1887
+
Mary Jane Stonehouse
b. Abt 1891
9
Norman Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6]
b. 16 Apr 1890 d. 6 May 1955
Deannie Winifred Hughes
b. 5 Dec 1896 d. 7 Sep 1970
10
John Carson Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.1]
b. 13 Aug 1921 d. 14 Feb 1996
Catherine Blumson
b. 1919
11
Judith Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.1.1]
+
Ronald McCollom
10
Joan Constance Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.2]
b. 7 Apr 1923 d. 1 Jul 2001
Jim Stubbington
11
Linda Stubbington
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.2.1]
+
Harry Shultis
+
Yves Boileau
11
Debra Stubbington
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.2.2]
b. 1945 d. 2001
+
Stanley Brothers
11
Fred Stubbington
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.2.3]
+
Lynne
Joseph Stasica
11
Dianna Stasica
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.2.4]
10
Kenneth Norman Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.3]
b. 16 Jun 1925 d. 14 Nov 1995
10
Doreen Louise Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.4]
b. 18 Dec 1928 d. 2 Nov 1976
10
Garnet Victor Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.5]
b. 8 Jun 1931
+
Dianne
Sandy
11
Mathew Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.5.1]
11
Cari Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.5.2]
+
Narius Mistry
11
Sarah Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.5.3]
10
Gerald Allan Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.6]
Phylis Jacques
11
Carol Ann Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.6.1]
+
Donald Bruce Olmstead
11
Douglas Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.6.2]
11
Charlene Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.6.3]
+
Mark Morin
+
Peter Medvick
11
Jerry Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.6.4]
10
Donald Ralph Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.7]
Jeannette McDonald
11
Shelley Star Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.7.1]
+
Joseph Malacarne
11
Candy Lee Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.7.2]
+
Harold Cashen
11
Donald Ralph Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.6.7.3]
+
Heather Reid
+
Susan Wray
9
Garnet B Walton
[1.1.1.1.1.1.10.11.7]
b. 11 Apr 1897
7
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.11]
b. 5 Aug 1809 d. 23 Jul 1844
6
William Glendinning
[1.1.1.1.1.2]
b. 1777 d. 6 Dec 1851
6
Janet Glendinning
[1.1.1.1.1.3]
b. Aft 1762
6
Jane Glendinning
[1.1.1.1.1.4]
b. Aft 1762
+
Robert Scott
6
Lilias Glendinning
[1.1.1.1.1.5]
b. 5 Feb 1764
+
Christopher Borthwick
b. 1757 d. 1808
6
Archibald Glendinning
[1.1.1.1.1.6]
b. 4 Mar 1766 d. 20 Jan 1827
6
Walter Glendinning
[1.1.1.1.1.7]
b. 7 Feb 1770
Elizabeth Park
7
Archibald Glendinning
[1.1.1.1.1.7.1]
b. 6 Sep 1804 d. 29 May 1883
Jean Stobo
b. 10 Jul 1807 d. 16 May 1889
8
Elizabeth Glendinning
[1.1.1.1.1.7.1.1]
b. 22 Jan 1835 d. 24 Sep 1893
Richard A.D. Thomson
b. 1835 d. 28 Mar 1877
9
Andrew Alexander Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1]
b. 9 Jul 1859 d. 26 Feb 1928
Elizabeth Ann Catherwood
b. 2 Aug 1861 d. 1 Jul 1923
10
John Edward Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.1]
b. 21 Nov 1887 d. 24 Sep 1950
10
Sylvester A. Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.2]
b. 10 Apr 1891 d. 20 Jan 1946
10
Russel Francis Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.3]
b. 27 Oct 1893
+
Beatrice Arnold Middleton
b. 1893
10
Nelson James Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4]
b. 9 Nov 1895 d. 21 Sep 1950
Mary Edna Thomson
b. 2 Jan 1904 d. 10 Feb 1988
11
Ethel Marie Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.1]
b. 10 Feb 1923 d. 1998
+
Edmund Trudeau
b. 11 Jun 1926
11
Myrel Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.2]
b. 18 Apr 1924 d. 27 Jun 1993
James William McCowan
b. 28 Feb 1927 d. 15 Nov 2004
12
Wendy Lou McCowan
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.2.1]
12
James Bruce McCowan
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.2.2]
12
Beverley Marie McCowan
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.2.3]
11
Bertha May Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.3]
b. 3 Sep 1925
Ross Bedore
b. 14 Jan 1927
12
Eleanor Audrey Bedore
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.3.1]
12
Douglas James Bedore
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.3.2]
11
Bernice Mabel Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.4]
b. 11 Sep 1927 d. 31 Oct 2015
Joseph William Ingles
b. 28 Aug 1929 d. 2003
12
Ronald Joseph Ingles
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.4.1]
12
Debra Lynn Ingles
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.4.2]
12
Kenneth William Ingles
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.4.3]
11
David Nelson Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.5]
b. 31 Dec 1929 d. 14 Sep 2008
Helen Grove
b. 28 Apr 1928
12
David Timothy Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.5.1]
12
Kimberley Helen Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.5.2]
12
Michael James Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.5.3]
12
Lori Louann Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.5.4]
11
Roy Nelson Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.6]
b. 22 Nov 1931 d. 15 Jun 1932
11
Doris Mary Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.7]
b. 22 Nov 1933 d. 17 Mar 2015
Lawrence Wilson
b. Apr 1924 d. 24 Mar 1961
12
Kelly James Wilson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.7.1]
12
Jackie Wilson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.7.2]
Alvin Young
12
Adele Young
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.4.7.3]
10
Elizabeth Myrel Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.5]
b. 29 Oct 1900 d. 21 Dec 1982
Richard Roy Shadlock
11
Dorothy Shadlock
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.5.1]
+
Robert Ginn
10
Mary Jane Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.6]
b. Aug 1885 d. 1 Feb 1889
10
Frances Almira Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.1.7]
b. 2 Sep 1889 d. 17 Oct 1889
9
Archibald Stobo Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.2]
b. 28 Feb 1861 d. 18 May 1877
9
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.7.1.1.3]
7
James Glendinning
[1.1.1.1.1.7.2]
b. 2 May 1796 d. 4 May 1861
Eliza Jane Wilkinson
b. 1800 d. 7 Jul 1874
8
Agnes Glendinning
[1.1.1.1.1.7.2.1]
b. 9 Apr 1840 d. 11 Jan 1916
James George Thomson
b. 25 Jul 1839 d. 16 Nov 1917
9
Eliza Jane Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.1]
b. 18 Mar 1862 d. 17 Sep 1929
James Cherry
b. 1856 d. Aft 1929
10
Child Cherry
[1.1.1.1.1.7.2.1.1.1]
d. 21 May 1896
9
William James Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.2]
b. 1 Sep 1863 d. 6 Dec 1922
Louisa M. Closson
b. 16 May 1861 d. 11 Apr 1933
10
Closson Goldwin Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.2.1]
b. 23 Jan 1902 d. 1989
Anna Doris Marshall
b. 18 Jun 1902
11
Gewndolyn Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.2.1.1]
+
Peter August Kuopus
9
Andrew Henderson Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.3]
b. 24 Sep 1865 d. 4 Oct 1945
Emily Millard Atwater
b. 1862 d. 23 Aug 1945
10
Emily Atwater Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.3.1]
d. Abt 1907
9
Oliver Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.4]
b. 2 Sep 1867 d. 13 Aug 1942
Bertha Florence Swallow
b. 28 Sep 1873 d. 2 Jun 1959
10
Eva Luella Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.1]
b. 20 May 1896 d. 1974
John Dewey Johnston
b. 24 Jun 1897 d. 4 Dec 1960
11
John Donald Johnston
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.1.1]
b. 25 Apr 1932
+
Janine Robillar
b. 28 Mar 1931
11
Marilyn Johnston
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.1.2]
+
Charles D'Amour
11
Gordon Edward Johnston
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.1.3]
+
Margaret MacRae
10
Myril Madelin Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.2]
b. 23 Oct 1905 d. 16 Feb 1940
10
James Glendinning Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.3]
b. 26 Mar 1907 d. 8 Jan 2002
Mary Eleanor Shipp
b. 12 Mar 1919 d. 19 Dec 2006
11
James Edwin Oliver Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.3.1]
Carolyn Anne Rowe
12
Kristen Anne Margurette Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.3.1.1]
11
Mary Catherine Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.3.2]
+
Arthur Hamilton Parks
11
Nancy Eleanor Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.4.3.3]
9
Agnes Ida Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.5]
b. 21 Feb 1870 d. 23 Jun 1905
Archibald Loane Muir
b. 20 Mar 1870 d. 14 Dec 1958
10
Agnes Glenetta Muir
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.1]
b. 5 May 1892 d. 11 Mar 1954
John Robert Empringham
b. 1 May 1892 d. 21 Apr 1966
11
Ida Alice Empringham
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.1.1]
b. 3 May 1917 d. 1 Sep 1991
+
Harold Wesley Martin Smith
b. 1916 d. 1989
11
William George Empringham
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.1.2]
b. 19 Feb 1920 d. 14 Apr 2002
Gertrude Jane Hill
b. 7 Jan 1921
12
Bruce Empringham
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.1.2.1]
[
=>
]
12
Edward Empringham
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.1.2.2]
[
=>
]
12
James Empringham
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.1.2.3]
11
Muriel Lillian Empringham
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.1.3]
b. 2 May 1924
+
Peter Halicki
b. 18 Sep 1927
11
Evelyn Glenetta Empringham
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.1.4]
b. 7 Jul 1928
+
Donald Lockie
b. 1 May 1928
10
Hazel Amy Catherine Muir
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.2]
b. 25 Jun 1895 d. 5 Apr 1944
Andrew Minto
b. 25 Sep 1894 d. 4 Feb 1949
11
Catherine Agnes Minto
[1.1.1.1.1.7.2.1.5.2.1]
b. 17 Apr 1924
+
Howard Edward Ormiston
b. 18 Jul 1920 d. 10 Feb 1989
9
Allan Goodwin Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.6]
b. 11 Jul 1883 d. 18 Nov 1953
Third Annabella
b. 18 Nov 1878 d. 14 Jul 1981
10
Marjorie Isabel Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.6.1]
b. 4 Oct 1919 d. Aft 7 Dec 2015
Ewart Vernon Macklin
b. 24 May 1917
11
Janice Louise Macklin
[1.1.1.1.1.7.2.1.6.1.1]
+
Douglas William MacEwan
11
Marilyn Isabel Macklin
[1.1.1.1.1.7.2.1.6.1.2]
+
Brian leslie Read
11
Ian Thomson Macklin
[1.1.1.1.1.7.2.1.6.1.3]
11
Brenda Joan Macklin
[1.1.1.1.1.7.2.1.6.1.4]
11
Graeme Allen Macklin
[1.1.1.1.1.7.2.1.6.1.5]
11
Roger kent Macklin
[1.1.1.1.1.7.2.1.6.1.6]
10
Joyce Louise Thomson
[1.1.1.1.1.7.2.1.6.2]
b. 21 Jul 1922 d. 15 May 2006
+
Morley Ewart Harman
b. 2 Jun 1920
7
William Glendinning
[1.1.1.1.1.7.3]
b. 8 Apr 1802
Elizabeth Borthwick
b. 19 May 1802
8
Christina Glendinning
[1.1.1.1.1.7.3.1]
b. 6 Jan 1837 d. 10 May 1920
Andrew Thomson
b. 31 Mar 1832 d. Bef 1881
9
Isabella Jane Thomson
[1.1.1.1.1.7.3.1.1]
b. 19 May 1859 d. 18 May 1885
+
George Green
b. 27 Mar 1861 d. 26 Aug 1948
9
Andrew Borthwick Thomson
[1.1.1.1.1.7.3.1.2]
b. 16 May 1862 d. 10 Mar 1877
9
William H. Thomson
[1.1.1.1.1.7.3.1.3]
b. 1865 d. 12 Mar 1877
9
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.7.3.1.4]
b. 1857 d. 29 Mar 1877
6
John Glendinning
[1.1.1.1.1.8]
b. 29 Jan 1772 d. 8 May 1812
Elizabeth Armstrong
b. 1780 d. 12 Aug 1853
7
James Glendinning
[1.1.1.1.1.8.1]
b. 13 Oct 1800 d. 6 Nov 1855
Margaret Thomson
b. 22 Apr 1803 d. 18 Oct 1823
8
John Glendinning
[1.1.1.1.1.8.1.1]
b. 6 May 1821 d. 14 Apr 1822
Janet Little
b. 1781 d. 30 Jan 1863
7
Andrew Glendinning
[1.1.1.1.1.8.2]
b. 2 Nov 1811 d. 10 May 1872
6
James Glendinning
[1.1.1.1.1.9]
b. 5 Mar 1774 d. 24 Feb 1852
5
Janet Glendinning
[1.1.1.1.2]
b. 1729 d. 29 Mar 1811
Simon Little
b. 1725 d. 17 Jul 1797
6
Anna Little
[1.1.1.1.2.1]
b. 26 Apr 1765 d. 24 Feb 1855
William Thomson
b. 6 Sep 1747 d. 13 Feb 1837
7
Simon Thomson
[1.1.1.1.2.1.1]
b. 10 Mar 1795 d. 15 Dec 1876
Elizabeth Johnston
b. 1801 d. 15 Aug 1860
8
Robert S. Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 26 Jan 1827 d. 26 Apr 1907
Mary S. Little
b. 18 Jun 1841
9
Margaret Nichol Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 26 Sep 1877 d. 26 Nov 1942
Joseph Edwin McClintock
b. 14 Dec 1873 d. 10 Jul 1952
10
Hugh McClintock
[1.1.1.1.2.1.1.1.1.1]
8
David Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.2]
b. 1828
8
Archibald S. Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.3]
b. 14 Dec 1829 d. 19 Apr 1892
Mary
b. Abt 1831
9
George Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.3.1]
b. Abt 1855
9
Lucy E. Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.3.2]
b. Abt 1857
9
Ellen Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.3.3]
b. Abt 1858
9
William J. Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.3.4]
b. Abt 1860
8
William S. Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.4]
b. 1832 d. 31 May 1899
8
Janet Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.5]
b. 22 Feb 1837 d. 1 Sep 1885
James Elliot
b. 26 Nov 1835 d. 25 Aug 1930
9
John Elliot
[1.1.1.1.2.1.1.5.1]
b. 1863
9
Simon Elliot
[1.1.1.1.2.1.1.5.2]
b. 1866
9
Robert Elliot
[1.1.1.1.2.1.1.5.3]
b. 8 Aug 1868
9
Elizabeth Elliot
[1.1.1.1.2.1.1.5.4]
b. 15 Nov 1870 d. 12 Jan 1961
Alexander Carrie
b. 14 Nov 1863 d. 29 Jul 1947
10
Karhleen Elliott Carrie
[1.1.1.1.2.1.1.5.4.1]
b. 17 Mar 1897 d. 23 Aug 1899
10
Wilfred Grierson Carrie
[1.1.1.1.2.1.1.5.4.2]
b. 29 Jan 1900
10
Janet Thomson Carrie
[1.1.1.1.2.1.1.5.4.3]
b. 15 Nov 1903
Robert Harland Yorke
b. 1896
11
Joan E. Yorke
[1.1.1.1.2.1.1.5.4.3.1]
11
Mary C. Yorke
[1.1.1.1.2.1.1.5.4.3.2]
9
William J. Elliot
[1.1.1.1.2.1.1.5.5]
b. 18 Aug 1875
9
Archibald T. Elliot
[1.1.1.1.2.1.1.5.6]
b. 30 Sep 1876
9
George E. Elliot
[1.1.1.1.2.1.1.5.7]
b. 13 Nov 1879
9
Jane Elliot
[1.1.1.1.2.1.1.5.8]
b. 25 Jan 1882
John Milton McVettie
b. 20 Feb 1880 d. Dec 1970
10
Janet Thomson McVettie
[1.1.1.1.2.1.1.5.8.1]
b. 22 May 1906
10
Kenneth Moffatt McVettie
[1.1.1.1.2.1.1.5.8.2]
b. 19 May 1908 d. 17 Jun 1988
Eva Lumm
b. 1906
11
Kenneth M. McVettie
[1.1.1.1.2.1.1.5.8.2.1]
b. 25 Nov 1930 d. 1 Dec 2013
11
James R. McVettie
[1.1.1.1.2.1.1.5.8.2.2]
10
Margaret Fraser McVettie
[1.1.1.1.2.1.1.5.8.3]
b. 19 Dec 1909
10
Dorothy Elliott McVettie
[1.1.1.1.2.1.1.5.8.4]
10
John Westley McVettie
[1.1.1.1.2.1.1.5.8.5]
b. Oct 1917 d. 1956
9
William Elliot
[1.1.1.1.2.1.1.5.9]
b. 22 Aug 1885
8
Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.1.6]
b. 27 Oct 1839 d. 1 Dec 1893
James Chartres Brown
b. 8 Nov 1834 d. 11 Nov 1913
9
Elizabeth Johnston Brown
[1.1.1.1.2.1.1.6.1]
b. 18 Sep 1862 d. 21 Jun 1930
Mathew Coubrough
b. 8 Jan 1854 d. 28 Apr 1940
10
James Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.1]
b. 11 May 1884 d. 26 Aug 1966
Elizabeth McGuire
b. 12 Sep 1886 d. 13 Oct 1954
11
Alfretta (Retta) Elizabeth Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.1.1]
+
Roy Orvil Ealsh
b. 30 Sep 1910 d. 14 May 1993
11
Marjorie Martha Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.1.2]
b. 22 Nov 1913 d. 10 May 1916
11
Estelle May (Stella) Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.1.3]
b. 8 May 1919 d. Dec 1999
+
Harry William Goy
b. 5 Mar 1915 d. 12 Jul 1989
11
Jean Theressa Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.1.4]
+
Arthur "Kenneth" Porritt
b. 18 Feb 1921 d. 31 Aug 2001
+
Lillian Johnston
b. 9 May 1886 d. 26 Jun 1967
10
William Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.2]
b. 11 Dec 1885 d. 28 Aug 1934
10
Harvey Henderson Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.3]
b. 31 Mar 1887 d. 5 May 1959
May Victoria Cousins
b. 13 May 1900 d. 18 Jan 1996
11
Victoria Edith Margerite Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.3.1]
b. 23 May 1921 d. 26 Oct 2002
+
Glenford William Bellrose
b. 20 Oct 1915 d. 19 Nov 1939
11
George Thomas (Bud) Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.3.2]
b. 22 Sep 1922 d. 5 Dec 1941
11
Evelyn Jean Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.3.3]
b. 21 Jan 1925 d. 21 Apr 1962
+
Raymond Chester Myers
10
Annie Thomson Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.4]
b. 7 Jul 1888 d. 19 Mar 1942
Robert Nelson Eden
b. 14 Aug 1888 d. 11 Apr 1977
11
James William Eden
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.4.1]
b. 8 Nov 1907 d. 16 Oct 1983
+
Ida Emile Marguerite Brock
b. 29 Aug 1907 d. 29 Dec 1992
11
Harvey Mathew Eden
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.4.2]
b. 30 May 1909
11
Robert Gordon Eden
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.4.3]
+
Clara Jean Brock
b. 25 Oct 1910 d. 9 Jun 1980
11
Shirley Beatrice Eden
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.4.4]
+
Burnell Watson Ells
11
Nelson Verlan Eden
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.4.5]
11
Edward Alexander Eden
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.4.6]
b. 1 Nov 1928 d. 29 Nov 1980
+
Elaine Ida Moerika
b. 11 Aug 1932 d. 30 Jun 1974
10
Flora Jane Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5]
b. 9 Apr 1890 d. 3 Dec 1983
Howard Arthur Ott
b. 29 Oct 1889 d. 24 Feb 1967
11
Clara Belle Ott
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5.1]
+
Cecil Treadway
b. 15 Apr 1915 d. 3 Jul 1975
+
Leland Johnson
+
Alfred (fred) Boucher
b. 8 Nov 1910
11
Bessie Ott
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5.2]
b. 23 Mar 1915 d. 31 Oct 1998
+
Lewis Edward Guse
b. 4 Dec 1913 d. 21 Oct 1980
+
John McQuaig
b. 8 Nov 1911 d. 7 Sep 1991
11
Gladys May Ott
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5.3]
b. 3 Mar 1917 d. Aug 1917
11
John Ott
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5.4]
b. 29 May 1918 d. 26 Sep 1942
11
Russell Ott
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5.5]
b. 1 Jul 1919 d. 17 Jan 1992
11
Iva Ott
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5.6]
+
Allan Leo Doege
b. 23 Jan 1921 d. 25 May 1978
11
Arthur Howard Ott
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5.7]
b. 10 Mar 1923
+
Laura May Nelson
b. 1 May 1925
11
Fixilla Ott
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5.8]
b. 25 Feb 1924
+
Peter Charles Stemkoski
b. 6 Jan 1921 d. 20 Jun 1992
11
Elsie May Ott
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.5.9]
+
Orval Carmine Clark
b. 21 May 1924 d. 21 May 1998
10
Margaret Marion Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.6]
b. 21 Sep 1891 d. 17 Nov 1939
Albert Henry Dowswell
b. 23 Jun 1884 d. 12 Oct 1956
11
William Arthur Dowswell
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.6.1]
+
Bertha Emily Matikka
b. 19 Nov 1920 d. 9 Oct 1969
11
Wesley Mathew Dowswell
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.6.2]
b. 19 May 1912 d. 2 Sep 1997
11
Elizabeth Alice Dowswell
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.6.3]
b. 12 Feb 1914 d. 12 Oct 1984
+
Winford Oscar Souther
b. 10 Oct 1899 d. 20 Oct 1987
11
Clarence Roy Dowswell
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.6.4]
b. 28 Oct 1915 d. 14 Feb 1990
+
Daisy Myrtle Shain
b. 4 Feb 1918 d. 6 Aug 2002
11
Annie Beatrice Dowswell
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.6.5]
+
Markus Edwin Skundberg
b. 7 Feb 1905 d. 19 Sep 1983
10
Robert Randall Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.7]
b. 17 Jan 1893 d. 30 Sep 1916
10
John Brown Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.8]
b. 11 Apr 1894 d. 8 Aug 1918
10
Simon Peter Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.9]
b. 22 Jan 1896 d. 2 May 1917
10
Delbert Laurier Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.10]
b. 1 Oct 1897 d. 22 Feb 1992
Pauline Marie (Lena) Bromberg
11
John Edmund Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.10.1]
b. 13 Jul 1928 d. 8 Jul 2002
+
Rose Evangeline Klemenz
11
June Louise Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.10.2]
b. 23 Dec 1933 d. 1 Dec 1978
+
Walter James (Jim) Thompson
b. 27 Dec 1931 d. 4 Oct 1984
11
Douglas Leroy Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.10.3]
+
Helen Margaret Lethbridge
11
Gerald Delbert Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.10.4]
11
Gary William Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.10.5]
10
Barbara Allen Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.11]
b. 20 May 1899 d. 12 Apr 1982
Alexander Grier
b. 16 Aug 1882 d. 27 Dec 1968
11
Robert Roy Grier
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.11.1]
11
Earl Alexander Grier
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.11.2]
11
Harvey Nelson Grier
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.11.3]
11
June Elizabeth Grier
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.11.4]
b. 21 Jun 1930
+
Trevor Reginald Shakesby
10
Archibald Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.12]
b. 25 Nov 1900 d. 16 Jan 1996
Velma Susanna Bush
b. 11 Jan 1907 d. 3 Sep 1992
11
Dorothy Beatrice Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.12.1]
+
Pete Wasylin
11
Donald Archie Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.12.2]
11
Pearl Marie Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.12.3]
+
Thomas John Moore
b. 6 May 1925 d. 13 Feb 1987
11
Sharon Yvonne Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.12.4]
+
Reynold Glen Leroy McLellan
11
Shirley Jean Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.12.5]
+
William Stewart Sjodin
10
Mary Elizabeth Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.13]
b. 15 Jul 1903 d. 14 Sep 1995
William John Lamont
b. 30 Aug 1895 d. 7 Feb 1980
11
Barbara Lamont
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.13.1]
b. 4 Jun 1921 d. 2 Jan 1985
+
John Morrisey
b. 6 Sep 1927 d. 4 Jan 1985
11
Ethel Margaret Lamont
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.13.2]
+
Oiva Rutti
11
Anne Elizabeth Lamont
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.13.3]
+
Charles Walter Porter
11
Della Lydia Lamont
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.13.4]
+
Dennis John Rooney
b. 9 Aug 1922 d. 30 Aug 1980
11
Jean Lamont
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.13.5]
+
Joseph Arnold Rozzano
11
Mary Ruby Lamont
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.13.6]
b. 6 Jul 1930 d. 24 Apr 1998
+
Joseph Aurelle Laplante
b. 29 May 1928 d. 10 Sep 1999
11
James Mathew Lamont
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.13.7]
11
William Harold Lamont
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.13.8]
10
Lochlain Mathew Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.14]
b. 27 Apr 1906 d. 30 Jun 1985
Pearl Eliza Fox
11
Patricia May Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.14.1]
b. 1 Sep 1931 d. 1 Sep 1931
11
Bryan Delphus Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.14.2]
b. 3 Jul 1933 d. 27 May 1998
+
Mary Ann Rathgeber
+
Jessica Ann Marsh
11
Doreen Marlene Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.14.3]
+
David Arthur Palmer
11
Garth Ricky Kenneth Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.14.4]
10
Ethel Vivian Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.15]
b. 29 Nov 1908 d. 18 May 1998
Ernest Robert Tames
b. 23 Dec 1909 d. Dec 1986
11
Jean Couborough Tames
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.15.1]
+
William John Lees
11
William Ernest Tames
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.15.2]
11
James Robert Tames
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.15.3]
11
Thomas Nelson Tames
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.15.4]
11
Marie Ann Tames
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.15.5]
+
John Richard Rumley
+
Antoine Eugene Caron
11
Joan Katherine Tames
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.15.6]
+
Philip Gregory
10
Earl Nelson Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.16]
b. 6 Mar 1909 d. 17 Jul 1987
Violet May Holbrook
b. 22 Oct 1915 d. 13 Sep 1997
11
Wayne Robert Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.16.1]
11
Willard Allan Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.16.2]
b. 28 Apr 1936 d. 26 Apr 1981
11
Gloria Mae Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.16.3]
+
Reginald Robert Wilde
11
Russell Earl Coubrough
[1.1.1.1.2.1.1.6.1.16.4]
9
Margaret Brown
[1.1.1.1.2.1.1.6.2]
b. 12 May 1865
Lachlan McNeil
b. 1861
10
Archibald McNeil
[1.1.1.1.2.1.1.6.2.1]
b. Bef 1904
9
John Brown
[1.1.1.1.2.1.1.6.3]
b. 1 May 1868 d. 4 Apr 1939
Ethel Stephenson
b. 23 Dec 1882
10
Ethel Mona Brown
[1.1.1.1.2.1.1.6.3.1]
b. Abt 1903
10
Anna Marian Brown
[1.1.1.1.2.1.1.6.3.2]
b. 3 Sep 1904
10
Jack Kenneth Brown
[1.1.1.1.2.1.1.6.3.3]
b. 10 Sep 1911
9
Simon Thomson Brown
[1.1.1.1.2.1.1.6.4]
b. 20 Jun 1875 d. 13 Sep 1938
Mary Elizabeth Beattie
b. 29 Apr 1879 d. 3 Nov 1904
10
Mary Estella Brown
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1]
b. 25 Jun 1894 d. 2 Jan 1992
Essie Harmon
b. 9 Oct 1894 d. 2 Sep 1975
11
Jack B. Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.1]
b. 12 Jan 1917 d. 8 May 2003
+
Lydia Toomer
b. 27 Apr 1920 d. 9 Feb 2003
11
Helen Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.2]
b. 14 Jul 1918 d. 23 May 1975
11
Beth Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.3]
b. 27 Jul 1919 d. 22 May 1924
11
Don B. Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.4]
b. 9 Jan 1921 d. 11 Dec 2004
11
Cyril B Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.5]
b. 27 May 1922 d. 5 Jul 1995
11
James B. Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.6]
b. 9 Jul 1923 d. 10 Jul 1923
11
Keith Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.7]
b. 8 Mar 1925 d. 8 Aug 2001
11
Wynn Brent Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.8]
b. 28 Sep 1929 d. 13 Jun 2000
Helen Van Wagner
12
Barry Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.8.1]
[
=>
]
12
Helen Ladawn Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.8.2]
Florence Loise Veenendaal
b. 27 Feb 1937 d. 14 Sep 1964
12
Jacklyn Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.8.3]
[
=>
]
12
Wyndee Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.8.4]
12
B. Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.8.5]
11
Blair Harmon
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.1.9]
b. 15 Aug 1936 d. 7 Feb 2006
10
Hazel Beattie Brown
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.2]
b. 9 Apr 1897 d. 2 Nov 1968
Ferdinand Weber
b. 14 Nov 1894 d. 8 Oct 1958
11
Earl B. Weber
[1.1.1.1.2.1.1.6.4.2.1]
b. 15 Nov 1919 d. 26 Jan 1920
+
Josephine Matilda Johnson
b. Abt 1881
7
Christopher Thomson
[1.1.1.1.2.1.2]
b. 31 Aug 1796 d. 13 Dec 1879
Mary Thomson
b. 14 May 1800 d. 14 Dec 1876
8
William Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1]
b. 5 Sep 1820 d. 30 May 1876
Margaret Dand
b. 4 Feb 1843 d. 24 Mar 1916
9
Marion Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1.1]
b. 1864 d. 6 Mar 1895
Charles Walter Edwards
b. 1 Sep 1864
10
Margaret Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.1]
b. Aft 1886
10
William Charles Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2]
b. 18 Jul 1887
Emily Rebecca Winters
b. 9 Oct 1870 d. Feb 1946
11
Christopher Francis Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1]
b. 27 Feb 1914 d. 13 Oct 1976
Lillian Eureta Florence Winters
b. 1929 d. 2005
12
Bonnie Anne Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1]
12
Brian Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.2]
12
Joyce Elizabeth Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.3]
12
Kenneth Wayne Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.4]
12
Paul Douglas Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.5]
12
William Perry Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.6]
12
James C. Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.7]
b. 1950's d. 1990's
12
David Francis Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.8]
b. Abt 1958 d. 2008
10
Ellen Mary Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.3]
b. Abt 1890
10
Jannetta Marie Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.4]
b. 25 Jun 1890
10
Chrisopher Francis Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.5]
b. 6 Nov 1892 d. 6 Apr 1917
10
Thomas Clarence Edwards
[1.1.1.1.2.1.2.1.1.6]
b. 4 Nov 1893
9
Mary Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1.2]
b. 1866 d. 1934
9
Christopher Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1.3]
b. 15 Jul 1867 d. 1948
9
William Walter Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1.4]
b. 27 Jul 1869
Christina
b. 1874
10
William N. Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1.4.1]
b. 15 Feb 1896
10
Silver M. Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1.4.2]
b. 15 May 1900
9
Janet Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1.5]
b. 15 Oct 1872
Jacab Lougheed
b. 21 Oct 1865
10
Margaret Ann Lougheed
[1.1.1.1.2.1.2.1.5.1]
b. 19 Nov 1893
10
Ernest Lougheed
[1.1.1.1.2.1.2.1.5.2]
b. 24 Feb 1897
10
Arnold Lougheed
[1.1.1.1.2.1.2.1.5.3]
b. 3 Mar 1899
10
Christopher Lougheed
[1.1.1.1.2.1.2.1.5.4]
b. 4 Jan 1895
9
Ellen Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1.6]
b. 29 Oct 1873 d. 4 Nov 1956
John Spencer
b. 30 Apr 1866 d. 27 Jun 1964
10
Margaret E. Spencer
[1.1.1.1.2.1.2.1.6.1]
b. 3 Mar 1895
10
Annie R. Spencer
[1.1.1.1.2.1.2.1.6.2]
b. 15 Mar 1897
10
Nellie Kathleen Spencer
[1.1.1.1.2.1.2.1.6.3]
b. 22 Aug 1903 d. 9 Dec 1947
+
Clarence McMullen
b. Abt 1900
9
Eleanor Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.1.7]
b. 1874
8
Andrew Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.2]
b. 24 Jun 1822 d. 26 Dec 1880
8
Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.3]
b. 20 Feb 1824
William Nichol
b. Abt 1818
9
Mary Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.1]
b. 27 Jan 1844 d. 23 May 1917
James Thomson
b. 14 Aug 1814 d. 24 Aug 1883
10
David Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.3.1.1]
b. 7 Dec 1869
10
James Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.3.1.2]
b. 5 Oct 1873
9
Rachel Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.2]
b. 1 Jan 1846 d. 1 May 1928
William Horsley
b. 1832 d. 22 Mar 1896
10
Annie Jane Horsley
[1.1.1.1.2.1.2.3.2.1]
b. 12 Apr 1884 d. 18 Jun 1932
William James Muirhead
b. 28 Feb 1882 d. 29 Sep 1975
11
Mary Jane Muirhead
[1.1.1.1.2.1.2.3.2.1.1]
b. 24 Jan 1912 d. Mar 1999
11
Norman A. Muirhead
[1.1.1.1.2.1.2.3.2.1.2]
11
William J. Muirhead
[1.1.1.1.2.1.2.3.2.1.3]
11
Ronald J. Muirhead
[1.1.1.1.2.1.2.3.2.1.4]
b. 1918 d. 1987
10
Mary Isabella Horsley
[1.1.1.1.2.1.2.3.2.2]
b. 13 Sep 1888 d. 28 Sep 1968
9
Ann Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.3]
b. 1847
William Scrace
b. 1837
10
George William Scrace
[1.1.1.1.2.1.2.3.3.1]
b. 13 Mar 1890
9
David Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4]
b. 15 Nov 1849 d. 19 Sep 1923
Jane Kerr Young
b. 15 Jul 1855 d. 19 Dec 1922
10
William Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.1]
b. 8 Dec 1878 d. 15 Mar 1930
Maria Ann Dale
b. 7 Jan 1883 d. 2 Jan 1975
11
William Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.1.1]
b. 10 Jul 1906 d. 25 Jan 1950
11
Alice Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.1.2]
b. 18 May 1908 d. 1993
11
Lena Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.1.3]
b. 16 Apr 1913 d. 13 Oct 2005
11
David Henry Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.1.4]
b. 24 Sep 1915 d. 22 Sep 1982
11
John Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.1.5]
b. 1915 d. 1917
11
Clarice Edith Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.1.6]
b. 26 Jan 1918 d. 28 May 2003
+
Raymond Herbert Bell
b. 21 Feb 1917 d. 29 Aug 1988
11
Stanley Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.1.7]
b. 6 Jun 1927 d. 17 Jan 1990
10
Jane K. Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.2]
b. 3 Nov 1882
10
David James Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.3]
b. 27 Dec 1886 d. 2 Nov 1951
10
Annie Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.4]
b. 3 Feb 1892 d. 30 Sep 1958
Edwin Forrest Ballinger
b. 23 May 1880 d. 15 May 1952
11
Elizabeth Ballinger
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.4.1]
b. 14 Dec 1913 d. 5 Feb 1993
Orville Charles Triggs
b. 4 Aug 1911 d. 12 Jul 1976
12
Robert Edwin Triggs
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.4.1.1]
b. 18 Sep 1934 d. 1 Dec 2002
11
Ralph E. Ballinger
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.4.2]
b. 20 Jun 1919 d. 28 Oct 1977
12
Edwin Ratmond Ballinger
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.4.2.1]
b. 15 Apr 1943 d. 9 May 1970
10
John Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.5]
b. 9 May 1895 d. 24 Dec 1981
10
Alexander Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.4.6]
b. Jul 1880
9
Christopher Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.5]
b. 18 Oct 1852 d. 6 Jun 1933
9
William Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.6]
b. 5 Jan 1855 d. 15 Dec 1916
9
Andrew Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.7]
b. 24 Jan 1856 d. 13 Aug 1926
9
Isabella Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.8]
b. 1860
9
John Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.9]
b. 20 Jan 1863 d. 13 Jan 1926
Gertrude Risebrough
b. 5 Aug 1868 d. 3 Dec 1899
10
William James Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.9.1]
b. 18 Jun 1893 d. 16 Jun 1959
10
Isabella Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.9.2]
b. 19 Jun 1893 d. 23 Jun 1933
10
Gladys Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.9.3]
b. 5 Jul 1897
+
Thomas Elmer Robinson
b. 1893
10
Jesse Gertrude Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.9.4]
b. 30 Jul 1899
+
Albert Sandford Cox
b. 7 Nov 1896
+
Christiana Watson
b. Dec 1867
9
Jane Nichol
[1.1.1.1.2.1.2.3.10]
b. 18 Sep 1866 d. 18 Aug 1926
Albert Edward Frisby
b. Feb 1872 d. 12 Feb 1957
10
Charlotte Ann Frisby
[1.1.1.1.2.1.2.3.10.1]
b. Jun 1905
8
Jane Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.4]
b. 30 Sep 1825
Ichabod Vanderburgh
b. Abt 1815 d. 28 Jan 1892
9
William Vanderburgh
[1.1.1.1.2.1.2.4.1]
b. Aug 1850 d. 4 Feb 1896
9
Mary Vanderburgh
[1.1.1.1.2.1.2.4.2]
b. Abt 1853
9
Christopher Vanderburgh
[1.1.1.1.2.1.2.4.3]
b. 1855
9
Bradley Vanderburgh
[1.1.1.1.2.1.2.4.4]
b. Abt 1857
Nancy
b. 28 Dec 1870
10
Ida E. Vanderburgh
[1.1.1.1.2.1.2.4.4.1]
b. 3 Dec 1897
10
Gordon Vanderburgh
[1.1.1.1.2.1.2.4.4.2]
b. 24 Sep 1899
9
Elizabeth Vanderburgh
[1.1.1.1.2.1.2.4.5]
b. Abt 1859
9
Annie Vanderburgh
[1.1.1.1.2.1.2.4.6]
b. Abt 1866
8
Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.5]
b. 19 Apr 1827 d. 21 Jan 1894
Ann Hudson
b. 1841 d. Bef 1891
9
Annie Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.5.1]
b. 1864
9
Janet Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.5.2]
b. 1872
9
Mary Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.5.3]
b. 1874
8
George Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.6]
b. 14 Feb 1829
+
Charlotte Thompson
b. 1832
8
James Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7]
b. 14 Feb 1829 d. 11 Jun 1906
Mary Ross
b. 9 Oct 1836 d. 11 Nov 1913
9
James Ross Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.1]
b. 14 Nov 1867 d. 1953
Francis Jane Crawford
b. Jun 1876 d. 1959
10
Lillian Reta Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.1.1]
10
James F. Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.1.2]
b. 4 Mar 1906 d. 10 Dec 1935
10
Pansy J. Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.1.3]
b. 1918 d. 1999
9
John Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.2]
b. 5 Jan 1870 d. 1950
9
Susannah Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.3]
b. 23 Aug 1874 d. 1950
Andrew Douglas
b. 27 Feb 1861 d. 26 Dec 1932
10
Andrew Christopher Douglas
[1.1.1.1.2.1.2.7.3.1]
b. 1905 d. 1977
9
Mary Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.4]
b. 1862 d. 1 Jun 1926
Charles Soudan Tuplin
b. 14 May 1864 d. Dec 1906
10
Lula Gertrude Tuplin
[1.1.1.1.2.1.2.7.4.1]
b. 14 Jul 1894 d. Feb 1982
+
James Frederick Smith
b. 15 Sep 1881 d. 11 Aug 1930
+
William Leonard James Cain
b. 17 Jul 1908 d. 15 Dec 1995
9
Christopher Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.5]
b. 20 Sep 1862 d. 1951
+
Maria Jane Saigeon
b. 10 Jul 1860 d. 13 May 1934
9
George Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.6]
b. 11 Aug 1872
9
Ellen Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.7.7]
b. Jan 1878 d. 15 Mar 1882
8
David Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.8]
b. 22 Mar 1832 d. 27 Feb 1911
Charlotte Ross
b. 10 Jun 1839 d. 16 Aug 1905
9
Susan Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.8.1]
b. 6 Jun 1863 d. 11 Feb 1920
Angus Currie
b. 1856 d. 1916
10
Catherine Currie
[1.1.1.1.2.1.2.8.1.1]
b. 6 May 1888 d. 1986
10
Charlotte Currie
[1.1.1.1.2.1.2.8.1.2]
b. 9 May 1891
+
Neil D. McNicol
b. 1883
10
David Currie
[1.1.1.1.2.1.2.8.1.3]
b. 10 May 1893 d. 1971
10
Neil Currie
[1.1.1.1.2.1.2.8.1.4]
b. 30 May 1895 d. 1958
10
Richard Malcolm Currie
[1.1.1.1.2.1.2.8.1.5]
b. 4 Mar 1898 d. 1988
10
Christopher Currie
[1.1.1.1.2.1.2.8.1.6]
b. 1909
9
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.8.2]
b. 1867
9
Ellen Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.8.3]
b. 10 Sep 1868 d. 19 Aug 1932
Louis Frederick Baker
b. 2 Aug 1870 d. 2 Dec 1940
10
Wesley Frederick Baker
[1.1.1.1.2.1.2.8.3.1]
b. 5 Oct 1897 d. 1975
Minnie Louise Stoll
b. 1905 d. 14 Nov 1997
11
Gary Earle Baker
[1.1.1.1.2.1.2.8.3.1.1]
b. 1936 d. 1971
9
Christopher Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.8.4]
b. 7 Jan 1871 d. 29 Nov 1937
+
Carrie Baker
b. 30 Apr 1869 d. 22 Mar 1932
9
Flora Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.8.5]
b. 1873
Ronald McDonald
b. 1860
10
Florence Charlotte McDonald
[1.1.1.1.2.1.2.8.5.1]
b. 1902
10
Virginia B. McDonald
[1.1.1.1.2.1.2.8.5.2]
b. 10 Jan 1907
9
Charlotte Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.8.6]
b. 14 Mar 1876
Lachlan McDougall
b. 1866
10
Lachlan McDougall
[1.1.1.1.2.1.2.8.6.1]
b. 28 Jun 1902 d. 28 Jun 1902
10
David Alex McDougall
[1.1.1.1.2.1.2.8.6.2]
b. 17 Oct 1905
10
S'Arcy Willie Argyle McDougall
[1.1.1.1.2.1.2.8.6.3]
b. 29 Jul 1908
10
Neil Donald McDougall
[1.1.1.1.2.1.2.8.6.4]
10
Charlotte McDougall
[1.1.1.1.2.1.2.8.6.5]
9
Janet F. Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.8.7]
b. 1878
+
Enock Scilley
b. 1877
8
Frances Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.9]
b. 23 Dec 1838
James Thompson
9
Fanny Thompson
[1.1.1.1.2.1.2.9.1]
8
John Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.10]
b. 20 Dec 1840 d. 22 Jan 1893
8
Christopher Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.11]
b. 23 Feb 1843 d. 17 May 1917
8
Simon Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.12]
b. 22 Mar 1836 d. 21 Mar 1889
Sarah Scott
b. 1836 d. 2 Apr 1921
9
Christopher William Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.12.1]
b. 22 Jun 1867
Sarah
b. 1 Jun 1877
10
Bessie Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.12.1.1]
b. 1 Apr 1899
10
Nellie Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.12.1.2]
b. 12 Dec 1900
9
Frances A Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.12.2]
b. 1871
9
George Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.12.3]
b. 1869
8
Helen Thomson
[1.1.1.1.2.1.2.13]
b. 1 May 1834 d. Bef 1881
James Main
b. 26 Aug 1827
9
Charles Main
[1.1.1.1.2.1.2.13.1]
b. 1859
9
Mary Main
[1.1.1.1.2.1.2.13.2]
b. 1861
9
Janet Main
[1.1.1.1.2.1.2.13.3]
b. 1863
9
Ann Main
[1.1.1.1.2.1.2.13.4]
b. 20 Nov 1864
9
Elizabeth Main
[1.1.1.1.2.1.2.13.5]
b. 22 Nov 1866
9
Christopher Main
[1.1.1.1.2.1.2.13.6]
b. 11 Mar 1870
Catherine
b. 21 Feb 1869
10
Clifford Main
[1.1.1.1.2.1.2.13.6.1]
b. 12 Oct 1895
7
William Thomson
[1.1.1.1.2.1.3]
b. 6 Oct 1797 d. 15 Dec 1866
Mary Murray
b. 1804 d. Aft 4 Apr 1881
8
Thomas Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.1]
b. 28 Feb 1831 d. 4 Jan 1877
Agnes Dalgleish
b. 1845 d. 21 Mar 1877
9
Mary Isabella Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.1.1]
b. 1877 d. 21 Jul 1955
Euphemia Allan
9
Margaret Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.1.2]
b. 1 Aug 1854
8
William Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.2]
b. 15 Dec 1832 d. Aft 4 Apr 1881
Elizabeth Richardson
b. 27 Jan 1839 d. Aft 1881
9
Maryanne Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.2.1]
b. 1860
8
Simon Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.3]
b. 17 Aug 1834 d. 2 Dec 1885
Janet Thomson
b. 2 Dec 1837 d. 16 May 1921
9
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.3.1]
b. 10 Jan 1873 d. 18 Jun 1948
Alexander Wakeman Edwards
b. 15 Jan 1872 d. 26 Dec 1953
10
Janet Margaret Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.1]
b. 31 Aug 1897 d. 29 Sep 1962
Nathan Sheldon Eaton
b. 17 Jan 1900 d. 29 Jun 1975
11
John Gordon Eaton
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.1.1]
b. 21 Apr 1926 d. 2 Dec 1963
11
Cheryl Louise Eaton
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.1.2]
Edward Gerald MacDonnell
12
Virginia Louise MacDonnell
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.1.2.1]
[
=>
]
12
Janet Margaret MacDonnell
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.1.2.2]
[
=>
]
10
Wakeman Thomson Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.2]
b. 27 Sep 1899 d. 8 May 1918
10
Robena Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3]
b. 20 Dec 1901 d. 6 Jan 1997
Bertram James Parsons
b. 6 Jun 1901 d. 15 May 1962
11
Janet Marilyn Parsons
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3.1]
Norman Jackson Mason
12
Michael Norman Mason
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3.1.1]
[
=>
]
12
Eric Wesley Mason
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3.1.2]
12
Sean Bertram Mason
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3.1.3]
[
=>
]
12
Randall James Mason
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3.1.4]
11
Margaret Elizabeth Parsons
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3.2]
James George Rawson
12
Melanie Jane Rawson
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3.2.1]
[
=>
]
12
Michelle Elizabeth Rawson
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3.2.2]
[
=>
]
12
Cindy Marilyn Rawson
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.3.2.3]
[
=>
]
10
Ellen Louise Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4]
b. 3 Oct 1904 d. 27 Aug 1972
Leonard Alfred Taylor
b. 21 Apr 1905 d. Abt 1962
11
Norman Robert Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.1]
b. 27 Mar 1928 d. 2 Oct 1992
Patricia Mahler
b. 17 Mar 1932
12
Timothy Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.1.1]
[
=>
]
12
Randy Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.1.2]
12
Lori Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.1.3]
[
=>
]
11
William Ernest Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.2]
b. 28 Nov 1929 d. Abt 1989
Ila Mae Blakely
b. 6 May 1931 d. 20 Dec 1990
12
Susan Lynne Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.2.1]
[
=>
]
12
Gregory William Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.2.2]
[
=>
]
12
Stephen Wayne Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.2.3]
12
Marianne Louise Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.2.4]
[
=>
]
12
Douglas George Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.2.5]
[
=>
]
11
Burnell Edwards Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.3]
b. 28 Mar 1932
Marion G. Rodgers
b. 11 Dec 1932
12
Mitchell Alexander Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.3.1]
[
=>
]
12
Kimberly Ellen Taylor
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.4.3.2]
[
=>
]
+
Agnes E. McConnachie
+
Donna Unknown
10
Alexander William Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5]
b. 30 Dec 1906 d. 27 Jun 1980
Sarah Clarissa Alexandra MacCarthur
b. 29 Mar 1904 d. 29 Mar 1988
11
Sandra Lu Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5.1]
Ormy Allan Ross Hawman
b. 30 Aug 1940 d. 16 Jun 1997
12
Christopher Ross Hawman
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5.1.1]
[
=>
]
12
Kimberly Sandra Kathleen Hawman
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5.1.2]
[
=>
]
12
Heather Alexandra Hawman
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5.1.3]
12
Michael William Marshall Hawman
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5.1.4]
+
Ian Alvin McWhirter
11
Rose Mary Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5.2]
Harry James Kirwin
12
Susan Jane Kirwin
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5.2.1]
[
=>
]
12
William James Kirwin
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5.2.2]
[
=>
]
12
Craig Llewellyn Kirwin
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.5.2.3]
[
=>
]
10
Dorothy Jean Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.6]
b. 9 Jan 1909 d. 8 Jan 1995
Nathan Woodworth Eaton
b. 6 Jun 1908 d. 18 Feb 1993
11
Margaret Ann Eaton
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.6.1]
William Fenwick Gault Parker
12
Derek Eaton Parker
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.6.1.1]
12
Heather Ann Parker
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.6.1.2]
[
=>
]
12
David William Parker
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.6.1.3]
10
Violet Olive Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.7]
b. 14 Apr 1911 d. 16 Dec 1928
10
Edna Mae Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.8]
b. 1 Sep 1914 d. Abt Dec 1994
John Henry Litster
b. 25 Feb 1909 d. 18 Oct 1984
11
John Andrew Litster
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.8.1]
Brenda Wilson
12
Jessica Lynn Litster
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.8.1.1]
12
David Josuha Litster
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.8.1.2]
10
Beatrice Rae Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.9]
b. 8 Jan 1917 d. 6 Jan 1997
Stanley Schmalz Wurm
b. 16 May 1901 d. 19 May 1971
11
Marie Yvonne Wurm
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.9.1]
b. 14 May 1927
Lachlan Alexander Stuart Godfrey
b. 19 Sep 1927 d. May 1991
12
Christopher Stanley Godfrey
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.9.1.1]
[
=>
]
12
Brian Lachlan Godfrey
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.9.1.2]
12
Janice Lynne Godfrey
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.9.1.3]
[
=>
]
12
Kathryn Anne Godfrey
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.9.1.4]
[
=>
]
10
Sydney Chichester Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.10]
b. 20 Nov 1895 d. 2 Jul 1970
Sarah Abigale Bunn
b. 12 Aug 1898 d. 22 Nov 1992
11
Sydney Stanton Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.10.1]
b. 16 Sep 1926
+
Marilyn Lrelf
Elsie Marion McKeown
b. 29 Apr 1931
12
Allan Stanton Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.10.1.1]
[
=>
]
12
Brent Alexander Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.10.1.2]
+
Beverly Unknown
11
Beverly Wakeman Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.10.2]
b. 20 Nov 1930
Bernice Verena Goltz
b. 13 Dec 1928
12
Douglas Wakeman Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.10.2.1]
[
=>
]
12
Murray David Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.10.2.2]
[
=>
]
12
Gail Gladys Edwards
[1.1.1.1.2.1.3.3.1.10.2.3]
[
=>
]
9
Mary Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.3.2]
b. 14 Nov 1862 d. 4 Feb 1864
9
David Simon Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.3.3]
b. 4 Jun 1864 d. 29 Mar 1937
+
Margaret Jane Harvie
b. 15 May 1869 d. Abt 1952
9
Jane Jemmina Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.3.4]
b. 13 Mar 1869 d. 30 Dec 1951
9
Thomas Telford Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.3.5]
b. 12 Dec 1870 d. 9 May 1948
9
Margaret E. Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.3.6]
b. 16 Feb 1875 d. 6 May 1949
9
Jenett Rabina Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.3.7]
b. 10 Jul 1879 d. 24 May 1963
9
William S. Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.3.8]
b. 7 Nov 1866 d. 7 Mar 1954
8
Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4]
b. 5 Aug 1836 d. Aft 4 Apr 1881
Mary Lattimer
b. 1845 d. Aft 4 Apr 1881
9
Margaret Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.1]
b. 24 Nov 1863 d. 25 Nov 1935
John Beattie Bell
b. 8 Oct 1862 d. 7 Jan 1915
10
Mary Thomson Bell
[1.1.1.1.2.1.3.4.1.1]
b. Sep 1883 d. 27 Jul 1893
10
George Bell
[1.1.1.1.2.1.3.4.1.2]
b. 1886 d. 25 Jun 1916
10
Archibald Thomson Bell
[1.1.1.1.2.1.3.4.1.3]
b. 1888 d. 13 Jul 1928
Margaret Pringle
b. 1885 d. 1924
11
Euphemia Little Bell
[1.1.1.1.2.1.3.4.1.3.1]
b. 1918 d. 1991
10
Thomas Bell
[1.1.1.1.2.1.3.4.1.4]
b. Feb 1890 d. 2 Aug 1896
10
William Thomson Bell
[1.1.1.1.2.1.3.4.1.5]
b. 1891
10
Mary Lizzie Bell
[1.1.1.1.2.1.3.4.1.6]
b. 1895
10
John Beattie Bell
[1.1.1.1.2.1.3.4.1.7]
b. 1899
10
Margaret Thomson Bell
[1.1.1.1.2.1.3.4.1.8]
b. 1902 d. 15 Sep 1916
9
William Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.2]
b. 9 Jul 1866
9
Christopher John Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.3]
b. 29 Mar 1872 d. 1909
Mary Jane Shannon
b. 3 Aug 1872
10
Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.3.1]
b. 1898
10
William Graham Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.3.2]
b. 1899
10
Mary G Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.3.3]
b. 1903
9
Thomas Telfer Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.4]
b. 3 Mar 1874 d. 31 Jan 1942
Elizabeth Houston
b. 2 Apr 1876 d. 2 Mar 1943
10
Archibald Houston Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.4.1]
b. 28 Apr 1901 d. 10 Mar 1981
Rachel Elizabeth Foster
b. 10 Mar 1905 d. 4 Sep 1939
11
John C Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.4.1.1]
+
Eileen Mary Gay
10
Janet Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.4.2]
b. 1903
10
Andrew Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.4.3]
b. 30 Sep 1904 d. 23 Feb 1979
Thelma Imogene Nolting
b. 10 Dec 1909 d. 22 Mar 1987
11
Jean Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.4.3.1]
9
Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5]
b. 29 Nov 1880 d. 11 Jun 1973
Janet Thomson
b. 18 Mar 1882 d. 29 Dec 1946
10
Mary Latimer Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1]
b. 17 Nov 1911 d. 11 Jun 1972
John Sheard
b. 21 Dec 1907 d. 22 Feb 1982
11
Hilda Murial Sheard
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.1]
b. 13 Aug 1937 d. 3 May 1999
Bruce Willard Main
b. 7 Jul 1923 d. 15 Dec 2000
12
Son Main
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.1]
12
Dau Main
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.2]
12
Son Main
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.3]
[
=>
]
12
Son Main
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.4]
12
Melody Ann Main
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.5]
b. 24 May 1959 d. 25 May 1959
12
Maureen Joyce Main
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.1.6]
b. 24 May 1959 d. 25 May 1959
11
Janet Audrey Sheard
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.2]
b. 21 Aug 1938 d. 14 Dec 1982
11
Annie McDonald T Sheard
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.3]
b. 19 Jul 1941 d. 11 Jul 2007
Terry Batty
12
Keith Allen Batty
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.3.1]
12
William Batty
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.3.2]
11
Florence Mary Sheard
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.1.4]
b. 26 Apr 1946 d. 11 Oct 1990
10
Christopher John Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.2]
b. 4 Feb 1907 d. 1975
10
Agnes Downie Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.3]
b. 15 Oct 1908 d. 20 May 1936
10
Walter Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.4]
10
Janet Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.5]
10
Annie MacDonald Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.6]
b. 9 Apr 1918 d. 22 Jan 1919
10
Margaret Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.7]
10
Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.8]
b. 2 Feb 1922 d. 25 Mar 1976
10
David Watson Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.4.5.9]
b. 12 Aug 1925 d. 16 Feb 2004
8
Christopher Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.5]
b. 19 Dec 1838 d. Aft 4 Apr 1881
+
Elizabeth
b. Abt 1847
8
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.6]
b. 6 Mar 1841 d. Jul 1918
John Irving
b. 1853 d. 4 Jul 1928
9
Janet Ann Irving
[1.1.1.1.2.1.3.6.1]
b. 29 Apr 1874 d. Oct 1961
9
William Irving
[1.1.1.1.2.1.3.6.2]
b. 1875
9
Mary Isabella Irving
[1.1.1.1.2.1.3.6.3]
b. 1877
9
Helen Irving
[1.1.1.1.2.1.3.6.4]
b. 1879
9
Thomas Telfer Irving
[1.1.1.1.2.1.3.6.5]
b. 1882 d. 1958
9
Scott Irving
[1.1.1.1.2.1.3.6.6]
b. 1883
9
Elizabeth Irving
[1.1.1.1.2.1.3.6.7]
b. 28 Feb 1886
8
Margaret Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.7]
b. 10 Apr 1843 d. 26 Feb 1845
8
Andrew George Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.8]
b. 1846 d. 8 Oct 1889
Isabella Hood
b. 1847 d. 29 Mar 1922
9
Helen Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.8.1]
b. 1877 d. Aft 21 Apr 1922
9
Mary Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.8.2]
b. 1879 d. 29 Mar 1887
8
John Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.9]
b. 1830
8
Margaret Thomson
[1.1.1.1.2.1.3.10]
b. 1848
7
David Thomson
[1.1.1.1.2.1.4]
b. 18 Jul 1799 d. 23 Sep 1882
Jane (Jean) Edgar
b. 7 Apr 1798 d. 10 Apr 1874
8
William Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1]
b. 22 Oct 1826 d. 13 Dec 1920
Jessie Park
b. Abt 1827 d. 16 Jan 1901
9
David Park Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.1]
b. 23 Jan 1850 d. 13 Aug 1947
Jane Scott
b. 18 May 1852 d. 12 Mar 1934
10
James William Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.1]
b. 15 Jul 1885 d. 3 Feb 1963
Maggie Eddie
b. 6 Jan 1887 d. 14 Aug 1961
11
John Eddie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.1]
b. 26 Feb 1925
Verna Margaret Benner
b. 10 Mar 1930
12
John David Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.1.1]
[
=>
]
12
Douglas Benner Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.1.2]
[
=>
]
12
Leslie Joan Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.1.3]
[
=>
]
12
James Scott Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.1.1.4]
[
=>
]
10
Jessie Park Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2]
b. 14 Sep 1887 d. Abt 1957
John Wellington Duncan
b. 8 Nov 1882 d. 14 Jun 1948
11
James Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1]
Louise Hewitt
12
Ted Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1.1]
[
=>
]
12
Betty Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1.2]
[
=>
]
12
Marlene Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1.3]
[
=>
]
12
Wilma Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1.4]
[
=>
]
12
Valerie Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1.5]
12
Bill Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1.6]
[
=>
]
12
James Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.1.7]
[
=>
]
11
Mary Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.2]
+
Ken Bye
11
Thomas S. Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.3]
Laurene M. Baker
12
Scott David Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.3.1]
[
=>
]
12
Judy Ann Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.3.2]
[
=>
]
12
Diane Lynn Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.3.3]
[
=>
]
12
Sandra Jean Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.3.4]
[
=>
]
11
Myrtle Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.4]
b. 22 Dec 1911 d. 8 Jan 2001
Norman James Shaw
b. 13 Dec 1913 d. 26 Nov 1991
12
William J. Shaw
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.4.1]
12
Patricia Shaw
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.4.2]
[
=>
]
12
Ronald N. Shaw
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.4.3]
[
=>
]
12
Douglas T. Shaw
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.4.4]
11
Jean Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.5]
b. Abt 1917 d. Abt 1993
+
Duncan McIntosh
b. Abt 1909 d. Abt 1970
11
David Robert Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6]
b. Abt 1919 d. 29 Mar 1973
Audrey Helen Benner
b. Abt 1922 d. Abt 1977
12
Robert Reginald Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.1]
[
=>
]
12
Kenneth William Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.2]
12
David Allan Duncan
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.2.6.3]
10
David Thomas Scott Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.1.3]
b. 5 Jun 1890 d. 19 Jun 1968
+
Jennie Gertrude Valliant
b. 2 Jan 1880 d. 26 Oct 1976
9
John Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.2]
b. Abt Jun 1851
9
Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.3]
b. 12 Sep 1853
9
Robert Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.4]
b. 22 May 1855 d. 23 May 1921
Margaret Johnstone
b. 22 Nov 1856 d. 28 Jul 1935
10
William Robert Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.1]
b. 16 Oct 1880 d. 3 Jan 1944
10
James Johnstone Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.2]
b. 17 Jun 1882 d. 11 Jun 1941
10
Margaret Jane Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.3]
b. 5 Sep 1884 d. 18 Aug 1963
George Bell
b. 12 Dec 1879 d. 24 Nov 1945
11
William Thomas Bell
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.3.1]
b. 29 Apr 1911 d. 20 Apr 1984
Dorothy A. Harley
b. 14 Jan 1913 d. 22 Feb 1996
12
Diana Bell
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.3.1.1]
b. 8 Sep 1934 d. 8 Sep 1934
12
Jane Bell
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.3.1.2]
12
William Bell
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.3.1.3]
12
Carol-Lynne Bell
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.3.1.4]
11
I. Gladys Bell
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.3.2]
b. 10 May 1912 d. Bef 1978
11
Robert George Bell
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.3.3]
b. 24 May 1915 d. 30 Oct 1992
10
Jessie Florence Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.4]
b. 12 Oct 1886 d. Abt 1952
10
Annie Hughan Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.4.5]
b. 21 Apr 1892 d. 24 Jun 1978
9
Christine Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.5]
b. 17 Apr 1857 d. Bef 1940
William Graham
b. 12 Jul 1854 d. Aft 1915
10
John Grant Graham
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.1]
b. 19 Sep 1884 d. 1954
+
Margaret McNulty
b. Abt 1884
10
William Thompson Graham
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.2]
b. 15 May 1886 d. 15 Apr 1910
10
Jessie Agnes Graham
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.3]
b. 19 Feb 1888 d. Abt 1967
William Nelson Rogers
b. Abt 1874 d. Abt 1952
11
William Lawrence Grant Rogers
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.3.1]
b. 20 Nov 1907 d. Abt 1990
11
Lois Rogers
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.3.2]
b. Abt 1918 d. Abt 1972
10
Margaret C. Graham
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4]
b. 1 Sep 1889 d. Aft 1941
Richard Davis
b. 23 Jun 1880
11
Ruby M E Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.1]
b. Mar 1908
11
Muriel Irene Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.2]
b. 26 Feb 1911 d. 24 Nov 1985
Floyd Wilmer Davis
b. 7 Jul 1898
12
Floyd Douglas Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.2.1]
12
Shirley Irene Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.2.2]
b. 1 Feb 1931 d. Aug 1998 [
=>
]
11
Kenneth Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.3]
11
Lois Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.4]
11
Richard Grant Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.5]
b. 1913
+
Unknown Davis
Ina McNab
12
Duncan Graham Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.5.1]
[
=>
]
12
Malcom Ross Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.5.2]
11
Ross Graham Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.6]
d. May 1965
11
Jean Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.7]
b. 1915
11
Bruce Davis
[1.1.1.1.2.1.4.1.5.4.8]
d. 1938
9
Margaret Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.6]
b. 16 Jul 1861 d. 15 Apr 1957
David Jamieson Dunn
b. 17 Mar 1856 d. 5 May 1936
10
Jessie Ida Dunn
[1.1.1.1.2.1.4.1.6.1]
b. 12 Jun 1885 d. 3 Oct 1953
+
Archibald William McDonough
b. 4 Sep 1884 d. 6 Nov 1946
10
Thomas Herbert Dunn
[1.1.1.1.2.1.4.1.6.2]
b. 9 Dec 1886 d. 16 Feb 1897
10
William Dunn
[1.1.1.1.2.1.4.1.6.3]
b. 29 Oct 1888 d. 26 Oct 1967
+
Elsie Jan Scott
b. 16 Sep 1893 d. 1 Oct 1950
+
Vera Gertrude White
b. 27 Jul 1905
10
John Gordon Dunn
[1.1.1.1.2.1.4.1.6.4]
b. 16 Feb 1890 d. 7 Feb 1955
Catherine MacDonald
b. 1 Feb 1896 d. 25 Sep 1982
11
William Thomas Dunn
[1.1.1.1.2.1.4.1.6.4.1]
b. Abt 1921 d. 7 Sep 1994
Evelyn B. Jarick
b. Abt 1920
12
Gordon Dunn
[1.1.1.1.2.1.4.1.6.4.1.1]
12
Maureen Dunn
[1.1.1.1.2.1.4.1.6.4.1.2]
[
=>
]
9
Donald Campbell Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.7]
b. 11 Jun 1864 d. 14 Apr 1927
9
Jane Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.8]
b. 10 Jul 1866 d. 23 Nov 1874
9
Jessie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.9]
b. 2 Aug 1869 d. 19 Aug 1940
9
James Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.1.10]
b. 16 Nov 1873 d. Abt 1950
8
Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2]
b. 8 Apr 1828 d. 19 Mar 1913
Jane Allan
b. 18 Jan 1849 d. 17 Nov 1925
9
Jane Edgar Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.1]
b. 28 Feb 1869 d. 4 Apr 1917
9
Catherine Murray Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.2]
b. 1 Feb 1871 d. 1 Jan 1950
William Sibley Millichamp
b. 18 Dec 1869 d. 17 Oct 1947
10
Sibley Gray Millichamp
[1.1.1.1.2.1.4.2.2.1]
b. 9 Aug 1907 d. 1 Jul 1984
+
Verna Agatha Jelley
b. Abt 1912 d. 11 Jul 1987
10
Jean Catherine Millichamp
[1.1.1.1.2.1.4.2.2.2]
b. 23 Sep 1910 d. 3 Nov 1984
10
Alice Millichamp
[1.1.1.1.2.1.4.2.2.3]
b. Sep 1910
9
Janet Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.3]
b. 20 Nov 1872 d. 31 Jan 1945
Joseph M. Casey
b. Abt 1873 d. Abt 1934
10
Zelma Jean Casey
[1.1.1.1.2.1.4.2.3.1]
9
David Edgar Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4]
b. 1 Dec 1874 d. 7 Nov 1933
Alice Emily Kean
b. 9 Mar 1881 d. Abt 1950
10
Archibald James Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1]
b. 20 Nov 1902 d. 27 Aug 1981
Alberta Georgina Hill
b. 7 Jul 1906 d. 30 Apr 1967
11
James A. Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1.1]
b. Abt 1924 d. 22 Apr 1989
Unknown
12
Anne Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.1]
Alice Unknown
12
Brian Guest
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.2]
12
Glen Guest
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1.1.3]
d. Bef 1989
11
Francis Murray Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1.2]
b. 24 Oct 1925 d. 17 Mar 1926
11
Geraldine Marjory Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1.3]
b. 21 Apr 1936 d. 27 Mar 1973
Lucille Tester
11
Dale Marsh
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1.4]
11
David Marsh
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1.5]
11
Gaye Marsh
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.1.6]
+
Unknown Guzzo
10
Francis Oliver Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2]
b. 24 Apr 1904 d. 4 Apr 1976
Leila Ruth McKechnie
b. 12 Apr 1920
11
David Francis Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.1]
Milena Stoangi
12
William David Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.1.1]
b. Abt Sep 1978 d. Abt Oct 1978
11
Donald Paul Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.2]
Judith Annee Vyse
12
Katherine Charlotte Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.2.1]
b. 24 May 1975 d. 26 May 1975
12
Lisa Frances Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.2.2]
12
Andrew Charles Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.2.3]
11
Richard McKechnie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.3]
Beverly Nora Johnston
12
Lorraine Ruth Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.3.1]
12
Francis Richard Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.3.2]
12
Colleen Beverly Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.3.3]
12
Glenn Donald Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.3.4]
11
Jane Ruth Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.4]
Paul Norman Teskey
b. 10 Aug 1948 d. 31 May 1994
12
Paula Jane Teskey
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.4.1]
[
=>
]
12
Norman Frank Teskey
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.4.2]
+
John McLauchlin
11
Judith Alice Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.5]
Barry William Lutes
12
Craig Wesley Lutes
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.5.1]
12
Tyler William Lutes
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.5.2]
12
Curtis Daniel Lutes
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.5.3]
12
Jared David Lutes
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.5.4]
11
Barbara Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.6]
Karl Beverly Annis
12
Kory Dalton Annis
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.6.1]
12
Shelby Thomson Annis
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.6.2]
11
Michael Kevin Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.2.7]
+
Marilyn Elaine Sova
10
Gwinivere May Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.3]
b. 24 Jun 1905 d. 31 Aug 1983
10
Geraldine Annette Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.4]
b. 21 Sep 1906 d. 7 Jul 1964
10
Marjorie Mowat (Maude) Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.5]
b. 5 Mar 1908 d. 13 Sep 1992
+
Jack Burwash Hunter
b. 29 Oct 1914 d. 24 Jul 1995
10
David Murray Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.6]
b. Abt 1916
Irene May Lovatt
b. Abt 1924
11
Leon Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.6.1]
Jo Anne Robinson
12
David Francis Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.6.1.1]
[
=>
]
11
Douglas Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.4.6.2]
+
Louise Unknown
9
John Allan Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.5]
b. 8 Dec 1876 d. 7 Jan 1942
Minna Marella Annis
b. 2 Jul 1880 d. 30 Oct 1950
10
John Allan Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.5.1]
b. 22 Nov 1907 d. 8 Jan 1983
Greta Mae Harrington
b. 27 Oct 1907 d. 21 Jan 1991
11
William John Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.5.1.1]
b. 27 Oct 1932
Betty Mae Payne
b. 12 Aug 1931
12
Michael William Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.5.1.1.1]
[
=>
]
12
Nancy Jane Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.5.1.1.2]
9
Archibald Robert Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.6]
b. 29 Dec 1878 d. 26 Nov 1954
Minnie Agnes Hewitt
b. 11 Dec 1887 d. 15 Apr 1981
10
Allan Hewitt Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.1]
b. 24 Jul 1917 d. 18 Jan 1983
10
Mary Beatrice Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.2]
b. 20 Apr 1921 d. 30 Jan 2006
William Bernal Johnston
b. 14 Oct 1920
11
Bryan Wilfred Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.2.1]
Judith Ellen Neufeld
12
Jason Charles Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.2.1.1]
12
Mark Andrew Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.2.1.2]
b. 22 Jul 1980 d. 22 Apr 2000
10
Phyllis Irene Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.3]
b. 15 Dec 1928
Werner Hoeschele
b. 5 Sep 1929 d. 30 Jun 1983
11
Martin Allan Hoeschele
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.3.1]
11
Stephen Karl Hoeschele
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.3.2]
Andrea Unknown
12
Sasha Hoeschele
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.3.2.1]
12
Kennedy Hoeschele
[1.1.1.1.2.1.4.2.6.3.2.2]
9
William James Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.7]
b. 22 Mar 1881 d. 5 Feb 1963
Jessie Stewart Laver
b. 18 Apr 1886 d. 30 Mar 1960
10
Reginald James Stewart Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.7.1]
b. 16 May 1907 d. 25 Feb 1977
Margory Reil
11
Zeta Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.7.1.1]
d. 24 Jul 1990
10
Martha Ethel Jane Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.7.2]
b. 31 May 1914 d. 28 Aug 1998
9
Margaret Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.8]
b. 16 Feb 1883 d. 21 May 1965
John Stephen Ross
b. 4 Feb 1881 d. 4 Aug 1971
10
Archibald Thomson Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.1]
b. 10 Oct 1911 d. Bef 1999
Jean Dobson
11
Charles Douglas Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.1.1]
10
Ellen Margaret Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.2]
b. Abt 1915 d. 21 Jun 1999
Donald McCarthy
11
Donald C. McCarthy
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.2.1]
Carol Ney
12
Stephen Donald McCarthy
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.2.1.1]
12
Catherine Ann McCarthy
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.2.1.2]
11
Jane Ellen McCarthy
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.2.2]
11
John Edward McCarthy
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.2.3]
+
Mary Phillips
10
John Gray Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.3]
b. 28 May 1922 d. 22 Feb 1995
Margaret Jean Oakley
b. Abt 1926 d. Abt 1958
11
Son Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.3.1]
b. 8 Apr 1948 d. 8 Apr 1948
11
John E. Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.3.2]
Cathy Unknown
12
Trina Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.3.2.1]
12
Jason Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.3.2.2]
11
Robert C. Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.8.3.3]
9
Elizabeth Mary Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.9]
b. 18 Apr 1885 d. 11 May 1964
Robert Earld Wood
b. 9 Aug 1888 d. 12 Aug 1972
10
Thomas Archibald Wood
[1.1.1.1.2.1.4.2.9.1]
b. Abt 1916 d. 9 Mar 2006
Bernetta Gertrude Anderson
b. Abt 1918
11
Margaret Wood
[1.1.1.1.2.1.4.2.9.1.1]
Garry Carscadden
12
Garry Carscadden
[1.1.1.1.2.1.4.2.9.1.1.1]
12
Dennis Carscadden
[1.1.1.1.2.1.4.2.9.1.1.2]
+
Garry Petitclerc
9
Martha Mowat Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.10]
b. 21 Feb 1887 d. 11 Dec 1956
George William Ross
b. 1 Jun 1890 d. 21 Sep 1955
10
George Marr Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1]
b. 8 Jun 1915 d. 23 Jan 1993
Norma Edith Cooke
b. 27 Apr 1921 d. 10 Jun 1994
11
George Marr Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1.1]
b. 14 Dec 1942 d. 12 Jun 1999
Janice H. Hunter
b. 27 Mar 1943 d. 28 Nov 2000
12
Bradley Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1.1.1]
12
Jennifer Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1.1.2]
12
Tyler Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1.1.3]
11
Norma Elaine Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1.2]
Hugh Joseph Wellington Thompson
b. 7 Apr 1941 d. 15 Jan 2003
12
Ross Andrew Charles Thompson
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1.2.1]
12
Lisa Jennett Thompson
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1.2.2]
[
=>
]
12
Erin Louise Thompson
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1.2.3]
12
Meredith Lynn Thompson
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.1.2.4]
10
Jean Allan Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.2]
b. 28 Dec 1917
George Arthur Cobbold
b. 12 Apr 1915 d. 16 Dec 1988
11
George Stephen Cobbold
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.2.1]
Joan Parrish
12
Sarah Cobbold
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.2.1.1]
12
Peter Cobbold
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.2.1.2]
11
Marleen Cobbold
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.2.2]
10
David William Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.3]
b. 24 Dec 1922 d. 4 Jul 2001
Margaret Joan Clayton
b. 23 Nov 1930
11
Dale Margaret Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.3.1]
John William McDonald
12
Chloe Elleda Ross McDonald
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.3.1.1]
10
Grant Stephen Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.4]
b. 9 Oct 1925 d. 20 Jan 2007
Shirley Catherine Joseph
11
Heather Ann Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.4.1]
James Arthur Blake
12
Lisa Blake
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.4.1.1]
12
Michael Blake
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.4.1.2]
Celine Agatha Verrier
b. 8 May 1933
11
Guy Harold Ross
[1.1.1.1.2.1.4.2.10.4.2]
b. 15 Feb 1952 d. Abt 2003
9
George Grant Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11]
b. 1 Feb 1889 d. 3 Apr 1965
Evelyn Hope Wood
b. 20 Jun 1890 d. 23 Mar 1979
10
Helen Maude Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.1]
b. 5 Mar 1912
Albert Richard Anderson
b. 12 Jun 1911 d. 21 Sep 2003
11
George Richard Anderson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.1.1]
Janice Marjorie Hipwell
12
Allan George Anderson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.1.1.1]
12
Mark Richard Anderson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.1.1.2]
11
Jean Evelyn Anderson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.1.2]
Glenn Richard Boynton
12
Susan Jean Boynton
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.1.2.1]
12
Erin Beth Boynton
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.1.2.2]
12
Tricia Lynn Boynton
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.1.2.3]
12
Will Richard Boynton
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.1.2.4]
10
Myrne Jean Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.2]
b. 28 Aug 1915 d. 29 Dec 2004
+
Matthew Alic Thomas Terry
b. 26 Dec 1919 d. 7 Mar 2000
10
Archibald Grant Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.3]
b. 13 Mar 1918 d. 17 Nov 1993
Dorothy Evelyn Fountain
b. 25 Oct 1925 d. 8 Aug 1991
11
Linda Dianne Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.3.1]
+
Bruce Gordon Cook
Shirley Marie (Gosse) Hunter
b. Abt 1927 d. Abt 1998
11
Sandra Hunter
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.3.2]
11
Arden Hunter
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.3.3]
11
Allan Hunter
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.3.4]
11
Stephen Hunter
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.3.5]
10
Alexander John Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.4]
b. 7 May 1920
+
Gladys Louise Varty
b. 6 May 1922
10
Gray Frederick Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.5]
b. 6 Dec 1927
Patricia Lillian Robins
b. 18 Jul 1932
11
George Gray Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.5.1]
Joyce Margaret Gleadall
12
Gillian Gellrie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.5.1.1]
12
Matthew George Grant Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.5.1.2]
11
Robert James Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.5.2]
Jacqueline Kim Partridge
12
Ryan James Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.5.2.1]
+
Gail Roffey
11
Alexander Bruce Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.5.3]
+
Mary Rosanne Dumais
10
Ruth Evelyn Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6]
b. 21 Apr 1932
Lawrence Edward Vollick
b. 28 Dec 1930
11
Cynthia Ruth Vollick
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.1]
Wayne Frederick Crosbie
12
Nathan Wayne Crosbie
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.1.1]
12
Timothy Lawrence Crosbie
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.1.2]
12
Kimberly Ruth Crosbie
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.1.3]
11
Wayne Lawrence Vollick
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.2]
+
Paula Sue Hill
b. Abt 4 Dec
11
Paul Edward Vollick
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.3]
Lucia Bonofiglio
12
Amanda Brianne Vollick
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.3.1]
12
Samatha Rene Vollick
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.3.2]
12
Matthew Paul Vollick
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.3.3]
12
Jacqueline Rachell Vollick
[1.1.1.1.2.1.4.2.11.6.3.4]
9
Simon Gray Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.12]
b. 30 Oct 1891 d. 19 Feb 1977
Pansy Ethel Margaret Leach
b. 14 Nov 1894 d. 10 May 1975
10
John Gray Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.12.1]
b. 9 May 1930
+
Joan Unknown
Marilyn Mason
11
David Gray Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.12.1.1]
11
Donald Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.2.12.1.2]
8
Robert Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3]
b. 26 Mar 1830 d. 20 Jan 1879
Mary Cameron
b. 29 Jun 1847 d. 25 Oct 1935
9
Duncan Cameron Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1]
b. 25 Sep 1868 d. 7 Jun 1954
Nellie Gertrude Passmore
b. 1 Sep 1876 d. 13 Jun 1950
10
Jean Nellie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1]
b. 9 Oct 1896 d. 17 Sep 1986
Robert Hetherington Norris
b. 19 Jan 1897 d. 7 Jan 1963
11
Robert Duncan Norris
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1.1]
b. 14 Jun 1926 d. 26 Sep 1934
11
Jean Mary Nell Norris
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1.2]
b. 13 Nov 1929
Donald Collins MacTavish
b. 23 Mar 1925 d. 25 Apr 1996
12
Robert Neil MacTavish
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1.2.1]
[
=>
]
12
Heather Jean MacTavish
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1.2.2]
11
Joan Barbara Norris
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1.3]
b. 13 Jan 1933
Cuthbert Batten Dixon
b. Abt Sep 1909 d. Abt 1985
12
Nancy Jean Dixon
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1.3.1]
[
=>
]
12
Cuthbert "John" Coleman Dixon
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1.3.2]
[
=>
]
12
Jennifer Ann Dixon
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1.3.3]
b. 12 Apr 1962 d. 8 Nov 1999 [
=>
]
12
Robert Ernest Dixon
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.1.3.4]
[
=>
]
+
George Charles Muzzell
10
Robert Duncan Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2]
b. 9 Nov 1898 d. 24 Jul 1973
Helen "Beatrice" Dryden
b. 9 Nov 1902 d. 4 Oct 1991
11
Mary "Yvonne" Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.1]
b. 29 May 1925
Edward Henry Stacey
b. 9 Oct 1920 d. 30 Apr 1962
12
Mary "Catherine" Stacey
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.1.1]
[
=>
]
12
Duncan Edward Stacey
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.1.2]
[
=>
]
12
Shirley Anne Stacey
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.1.3]
[
=>
]
12
Nancy Carol Stacey
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.1.4]
[
=>
]
12
Elizabeth "Betty" Jean Stacey
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.1.5]
[
=>
]
+
Harvey Ross McGrath
b. 11 Dec 1921 d. 30 Dec 2000
+
David "Garfield" Evans
b. 25 Jul 1925
11
Dorothy-Jane Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.2]
b. 4 Jul 1927 d. 8 Dec 1995
Gordon Everard Williamson
b. 15 Jun 1923 d. 16 Oct 2005
12
Ronald James Williamson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.2.1]
12
Jon David Williamson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.2.2]
[
=>
]
12
Jenifer Rae Williamson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.2.3]
11
Duncan Dryden Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.3]
b. 7 Mar 1929
Kathryn June Smith
b. 12 Jun 1934 d. 30 Jun 2001
12
Linda Marie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.3.1]
[
=>
]
12
Michael John Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.3.2]
[
=>
]
12
Susan Leslie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.3.3]
[
=>
]
11
Ethel Beatrice Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.4]
b. 2 Nov 1931
William E. Dodds
b. 8 Jan 1931
12
William "Darcy" Dodds
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.4.1]
[
=>
]
12
Gordon Thomson Dodds
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.4.2]
[
=>
]
12
Gregory Ernest Dodds
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.4.3]
[
=>
]
12
Stephen Robert Dodds
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.4.4]
[
=>
]
12
Kelly Jean Dodds
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.4.5]
11
Carol Elizabeth Harriett Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.5]
+
Vernon Kent Davidson
+
Ian James Marr
11
Robert Kent Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.6]
Heather Eileen Smith
12
Robert Douglas Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.6.1]
[
=>
]
12
Daniel Kent Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.2.6.2]
[
=>
]
10
James Hoccum Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3]
b. 7 Feb 1901 d. 9 Jan 1971
Kathleen Roberta Jackson
b. 14 Sep 1900 d. 18 Nov 1988
11
Claire Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.1]
Richard A. Ball
12
James Ball
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.1.1]
[
=>
]
12
Michael Ball
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.1.2]
12
Ian Ball
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.1.3]
12
Tracey Ball
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.1.4]
[
=>
]
11
Martha Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.2]
Everett "Sonny" J. Grandelius
12
Steven Grandelius
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.2.1]
12
Tammy Grandelius
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.2.2]
12
Kristin Grandelius
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.2.3]
12
Joel Grandelius
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.3.2.4]
10
Caroline Marie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.4]
b. 19 Jul 1903 d. Abt 1947
+
Earl Thorne
10
Ruth Frances Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.5]
b. 22 Dec 1906 d. 6 Sep 2006
10
John Passmore Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.6]
b. 24 Jun 1909 d. 29 Jul 1988
Frances Ethel Smith
11
Gail Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.6.1]
Unknown O'Connor
12
Roxanne O'Connor
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.6.1.1]
12
Tara O'Connor
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.6.1.2]
12
Shelly O'Connor
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.6.1.3]
12
Ryan O'Connor
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.6.1.4]
11
Heather Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.6.2]
10
George Edgar Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.7]
b. 6 Nov 1910 d. 6 Nov 1910
10
Donald Albert Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.8]
b. 16 Sep 1913 d. 1 Jan 1992
Mabel Helen Pierce
b. 17 Feb 1915 d. 30 Jun 2001
11
Mary Helena Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.8.1]
Douglas Richard Lawton Solomon
12
Graham Douglas Lawton Solomon
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.8.1.1]
[
=>
]
12
Donald Fraser Lawton Solomon
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.8.1.2]
[
=>
]
12
Toni Frances Lawton Solomon
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.8.1.3]
[
=>
]
11
Donald Barry Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.8.2]
Cheryl Gail Ffyner-Collender
12
Duncan Craig Collender Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.8.2.1]
12
David Pierce Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.1.8.2.2]
9
Jane Robena Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.2]
b. 28 Feb 1870 d. 9 Feb 1947
George Bruce
b. Abt 1867 d. 23 Aug 1961
10
Robert Arnold Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1]
b. 6 Sep 1901 d. 16 Jan 1978
Marie Helena Hamilton
b. 27 Jun 1908 d. 4 Oct 1992
11
Beverly Grace Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.1]
b. 23 Feb 1926 d. 3 Jan 1988
Laurence W. Murphy
b. 3 May 1926 d. Abt Sep 1987
12
Lyndia Shannon Murphy
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.1.1]
b. Abt 1950 d. 20 Jul 1957
12
Patricia Ann Murphy
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.1.2]
[
=>
]
11
Roberta Helena Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.2]
b. 18 Jan 1928 d. 4 Mar 1988
Gerhard Abram Klassen
b. 2 Sep 1921 d. 6 Jan 2002
12
Ken Klassen
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.2.1]
[
=>
]
12
Grace Klassen
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.2.2]
[
=>
]
11
Joyce Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.3]
+
Unknown Robbins
11
Albert George Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.4]
b. 4 May 1931 d. 2 Mar 1971
Shirley Unknown
12
John Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.4.1]
12
Robert Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.4.2]
12
Wendy Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.4.3]
12
Susan Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.4.4]
12
George Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.4.5]
12
James Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.4.6]
11
John Hamilton Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.5]
b. 17 Aug 1932 d. 9 Nov 1954
+
Unknown
11
Gerald Thomas Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.1.6]
b. 20 Jun 1937 d. 2 May 1971
+
Unknown
10
Albert George Bruce
[1.1.1.1.2.1.4.3.2.2]
b. 17 Feb 1903 d. 14 Jul 1987
9
David Edgar Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.3]
b. 13 Feb 1872 d. Bef 1879
9
William John Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.4]
b. 20 Feb 1874 d. 17 Nov 1956
Gertrude Julia Wilson
b. 10 Jul 1882 d. 8 Jun 1908
10
Grace Marie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.1]
b. 16 Jul 1904 d. 5 Feb 1983
Frank Hillard McKay Marshall
b. 31 Mar 1904 d. Abt 1964
11
Sally Ann Marshall
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.1.1]
b. Abt 1940 d. Abt 1967
Peter Blair McCulloch
b. Abt 1939 d. 31 Jul 2003
12
Peter McCulloch
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.1.1.1]
12
Paul McCulloch
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.1.1.2]
Eva May Dudenhoffer
b. 6 Dec 1888 d. 27 Jul 1970
10
Dorothy Louise Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2]
b. 13 Oct 1921
Hugh Winters Calverley
b. 9 Feb 1920 d. 9 Jan 1994
11
William Robert Calverley
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2.1]
Susan Ann Prentice
12
Beverley Ann Calverley
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2.1.1]
[
=>
]
12
Amy Lynn Calverley
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2.1.2]
12
Andrew Calverley
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2.1.3]
12
Rebecca Calverley
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2.1.4]
11
James Hugh Calverley
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2.2]
+
Pauletta Goudreault
11
David John Calverley
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2.3]
Linda Unknown
12
Cassandra Calverley
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2.3.1]
12
Sabrina Calverley
[1.1.1.1.2.1.4.3.4.2.3.2]
+
Enril Samuel Robillard
b. Abt 1924 d. 27 Feb 2001
9
Margaret Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.5]
b. 25 Feb 1875 d. 20 Feb 1939
John Thomas Johnston
b. 6 Aug 1872 d. 28 Nov 1944
10
Grace Robena Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1]
b. 22 Oct 1897 d. 26 Apr 1978
Thomas Walton Holmes
b. 20 May 1898 d. Abt 1952
11
Marjorie Anne Holmes
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.1]
b. 18 Mar 1926
Hugh McCardell
12
Son McCardell
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.1.1]
12
Daughter McCardell
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.1.2]
11
Shirley Janet Holmes
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.2]
b. 7 May 1930
Ron Smith
12
Son Smith
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.2.1]
12
Daughter One Smith
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.2.2]
12
Daughter Two Smith
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.2.3]
11
Thomas Earl Holmes
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.3]
b. 13 Jan 1932
+
Joan Berg
11
Lucie Joy Holmes
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.4]
b. 23 Aug 1934 d. 30 Apr 1981
Lou Somers
12
Susan Somers
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.4.1]
12
Gail Somers
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.4.2]
12
Diane Somers
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.4.3]
12
Paula Somers
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.4.4]
Ernie Woodfall
12
Ward Woodfall
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.1.4.5]
10
Margaret Ellen Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2]
b. 12 Nov 1898 d. 5 Jan 1978
Rev James Currie Thomson
b. 1 Jun 1895 d. 5 May 1952
11
Margaret Anna Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.1]
b. 9 Nov 1921
Charles Edward Kelly
12
James "Scott" Kelly
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.1.1]
12
Lorne "Douglas" Kelly
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.1.2]
12
Sheila "Jane" Kelly
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.1.3]
12
David Michael Kelly
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.1.4]
11
Robert Currie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.2]
b. 25 Oct 1927
Agnes Tasker
12
Keith James Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.2.1]
12
Rhona Lynn Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.2.2]
11
Peter Lees Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.3]
Heather Lynne Dunford
12
Michael Stuart Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.3.1]
12
Margaret Erin Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.2.3.2]
10
Edna Mary Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.3]
b. 30 May 1901 d. Abt Apr 1999
10
Florence Jean Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4]
b. 30 Dec 1903 d. 23 Nov 1974
Joseph Paul U. Dumaresq
b. 5 Aug 1898 d. 12 Dec 1986
11
Ellen Dumaresq
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.1]
b. 11 Jan 1925
James Henry Kennedy
b. Abt 1931 d. 16 Nov 1975
12
Michael Kennedy
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.1.1]
12
Timothy Kennedy
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.1.2]
12
Barbara Kennedy
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.1.3]
12
Heather Kennedy
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.1.4]
+
Joseph McLoughlin
11
Joan Dumaresq
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.2]
b. 7 Aug 1927 d. Bef 2005
+
Lloyd W. McIntyre
11
David J. Dumaresq
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.3]
E. Joan Begg
12
Shelley Dumaresq
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.3.1]
12
Joel S. Dumaresq
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.3.2]
[
=>
]
12
Jason Dumaresq
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.3.3]
12
Stephanie Dumaresq
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.4.3.4]
[
=>
]
10
John Thomas Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.5]
b. 20 Aug 1907 d. 10 Mar 1973
Ruby M. Gourley
b. 10 Aug 1907 d. Abt 2002
11
Rosalie Anne Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.5.1]
b. 18 Apr 1931
+
Fred Fawcett
11
Patricia Maureen Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.5.2]
+
Gary Crawford
11
Barbara Elizabeth Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.5.3]
+
Charles Church
10
Wilma Marion Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.6]
b. 16 Jul 1913 d. Abt Nov 2000
John Edward Meagher
b. 16 Jan 1908 d. Abt 1987
11
Sharon Kay Meagher
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.6.1]
Thomas Michael Apsey
12
Susan Kathleen Apsey
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.6.1.1]
[
=>
]
12
Jill Christine Apsey
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.6.1.2]
[
=>
]
11
Keith John Meagher
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.6.2]
+
Pamela Jane West
10
Scott Cameron Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.7]
b. 3 Sep 1915 d. 26 Jul 1935
10
Keith McLean Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.3.5.8]
b. 26 Dec 1917 d. 26 Jul 1943
+
Elizabeth Robertson Smith
b. 20 May 1916
9
Robina Mary Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.3.6]
b. 17 Mar 1879 d. 24 Dec 1952
William Andrew Amos
b. 9 Feb 1876 d. 12 Dec 1967
10
William Albert Ross Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.1]
b. 4 May 1910 d. 27 Dec 1986
Margaret Selina Mitchell
b. Abt 1916 d. 25 Mar 1991
11
John Douglas Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.1.1]
Elizabeth Donaldson
12
Devon Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.1.1.1]
12
Jenny Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.1.1.2]
11
William Ross Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.1.2]
Gina Head
12
Tara Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.1.2.1]
12
Daniel Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.1.2.2]
10
Donald Clark Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2]
b. 15 May 1911 d. 1 Aug 1994
Marjorie Evelyne Proctor
b. Abt 1913 d. 24 Feb 1984
11
Paul Ross Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2.1]
Mary Louise Famme
12
Erin Louise Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2.1.1]
11
Donald Bruce Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2.2]
Stephanie Wood
12
William Ambrose Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2.2.1]
12
Matilda Grace Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2.2.2]
11
Robert Edward Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2.3]
Myfanwy Sarah Bone
12
Rosemary Elizabeth Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2.3.1]
12
Emily Grace Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2.3.2]
11
Janet Evelyne Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.2.4]
+
David Bacon
+
Grace Eileen Michener
b. 31 Mar 1911
10
Robert Douglas Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.3]
b. 22 Sep 1913 d. 13 Mar 1991
Irene Whittle
b. Abt 1919 d. 30 Dec 2005
11
Judith Anne Amos
[1.1.1.1.2.1.4.3.6.3.1]
+
David Davidson
8
Janet Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.4]
b. 2 Dec 1837 d. 16 May 1921
Simon Thomson
b. 17 Aug 1834 d. 2 Dec 1885
9
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.4.1]
b. 10 Jan 1873 d. 18 Jun 1948
Alexander Wakeman Edwards
b. 15 Jan 1872 d. 26 Dec 1953
10
Janet Margaret Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.1]
b. 31 Aug 1897 d. 29 Sep 1962
Nathan Sheldon Eaton
b. 17 Jan 1900 d. 29 Jun 1975
11
John Gordon Eaton
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.1.1]
b. 21 Apr 1926 d. 2 Dec 1963
11
Cheryl Louise Eaton
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.1.2]
Edward Gerald MacDonnell
12
Virginia Louise MacDonnell
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.1.2.1]
[
=>
]
12
Janet Margaret MacDonnell
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.1.2.2]
[
=>
]
10
Wakeman Thomson Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.2]
b. 27 Sep 1899 d. 8 May 1918
10
Robena Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3]
b. 20 Dec 1901 d. 6 Jan 1997
Bertram James Parsons
b. 6 Jun 1901 d. 15 May 1962
11
Janet Marilyn Parsons
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3.1]
Norman Jackson Mason
12
Michael Norman Mason
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3.1.1]
[
=>
]
12
Eric Wesley Mason
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3.1.2]
12
Sean Bertram Mason
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3.1.3]
[
=>
]
12
Randall James Mason
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3.1.4]
11
Margaret Elizabeth Parsons
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3.2]
James George Rawson
12
Melanie Jane Rawson
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3.2.1]
[
=>
]
12
Michelle Elizabeth Rawson
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3.2.2]
[
=>
]
12
Cindy Marilyn Rawson
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.3.2.3]
[
=>
]
10
Ellen Louise Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4]
b. 3 Oct 1904 d. 27 Aug 1972
Leonard Alfred Taylor
b. 21 Apr 1905 d. Abt 1962
11
Norman Robert Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.1]
b. 27 Mar 1928 d. 2 Oct 1992
Patricia Mahler
b. 17 Mar 1932
12
Timothy Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.1.1]
[
=>
]
12
Randy Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.1.2]
12
Lori Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.1.3]
[
=>
]
11
William Ernest Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.2]
b. 28 Nov 1929 d. Abt 1989
Ila Mae Blakely
b. 6 May 1931 d. 20 Dec 1990
12
Susan Lynne Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.2.1]
[
=>
]
12
Gregory William Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.2.2]
[
=>
]
12
Stephen Wayne Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.2.3]
12
Marianne Louise Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.2.4]
[
=>
]
12
Douglas George Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.2.5]
[
=>
]
11
Burnell Edwards Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.3]
b. 28 Mar 1932
Marion G. Rodgers
b. 11 Dec 1932
12
Mitchell Alexander Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.3.1]
[
=>
]
12
Kimberly Ellen Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.4.3.2]
[
=>
]
+
Agnes E. McConnachie
+
Donna Unknown
10
Alexander William Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5]
b. 30 Dec 1906 d. 27 Jun 1980
Sarah Clarissa Alexandra MacCarthur
b. 29 Mar 1904 d. 29 Mar 1988
11
Sandra Lu Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5.1]
Ormy Allan Ross Hawman
b. 30 Aug 1940 d. 16 Jun 1997
12
Christopher Ross Hawman
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5.1.1]
[
=>
]
12
Kimberly Sandra Kathleen Hawman
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5.1.2]
[
=>
]
12
Heather Alexandra Hawman
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5.1.3]
12
Michael William Marshall Hawman
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5.1.4]
+
Ian Alvin McWhirter
11
Rose Mary Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5.2]
Harry James Kirwin
12
Susan Jane Kirwin
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5.2.1]
[
=>
]
12
William James Kirwin
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5.2.2]
[
=>
]
12
Craig Llewellyn Kirwin
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.5.2.3]
[
=>
]
10
Dorothy Jean Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.6]
b. 9 Jan 1909 d. 8 Jan 1995
Nathan Woodworth Eaton
b. 6 Jun 1908 d. 18 Feb 1993
11
Margaret Ann Eaton
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.6.1]
William Fenwick Gault Parker
12
Derek Eaton Parker
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.6.1.1]
12
Heather Ann Parker
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.6.1.2]
[
=>
]
12
David William Parker
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.6.1.3]
10
Violet Olive Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.7]
b. 14 Apr 1911 d. 16 Dec 1928
10
Edna Mae Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.8]
b. 1 Sep 1914 d. Abt Dec 1994
John Henry Litster
b. 25 Feb 1909 d. 18 Oct 1984
11
John Andrew Litster
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.8.1]
Brenda Wilson
12
Jessica Lynn Litster
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.8.1.1]
12
David Josuha Litster
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.8.1.2]
10
Beatrice Rae Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.9]
b. 8 Jan 1917 d. 6 Jan 1997
Stanley Schmalz Wurm
b. 16 May 1901 d. 19 May 1971
11
Marie Yvonne Wurm
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.9.1]
b. 14 May 1927
Lachlan Alexander Stuart Godfrey
b. 19 Sep 1927 d. May 1991
12
Christopher Stanley Godfrey
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.9.1.1]
[
=>
]
12
Brian Lachlan Godfrey
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.9.1.2]
12
Janice Lynne Godfrey
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.9.1.3]
[
=>
]
12
Kathryn Anne Godfrey
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.9.1.4]
[
=>
]
10
Sydney Chichester Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.10]
b. 20 Nov 1895 d. 2 Jul 1970
Sarah Abigale Bunn
b. 12 Aug 1898 d. 22 Nov 1992
11
Sydney Stanton Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.10.1]
b. 16 Sep 1926
+
Marilyn Lrelf
Elsie Marion McKeown
b. 29 Apr 1931
12
Allan Stanton Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.10.1.1]
[
=>
]
12
Brent Alexander Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.10.1.2]
+
Beverly Unknown
11
Beverly Wakeman Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.10.2]
b. 20 Nov 1930
Bernice Verena Goltz
b. 13 Dec 1928
12
Douglas Wakeman Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.10.2.1]
[
=>
]
12
Murray David Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.10.2.2]
[
=>
]
12
Gail Gladys Edwards
[1.1.1.1.2.1.4.4.1.10.2.3]
[
=>
]
9
Mary Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.4.2]
b. 14 Nov 1862 d. 4 Feb 1864
9
David Simon Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.4.3]
b. 4 Jun 1864 d. 29 Mar 1937
+
Margaret Jane Harvie
b. 15 May 1869 d. Abt 1952
9
Jane Jemmina Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.4.4]
b. 13 Mar 1869 d. 30 Dec 1951
9
Thomas Telford Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.4.5]
b. 12 Dec 1870 d. 9 May 1948
9
Margaret E. Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.4.6]
b. 16 Feb 1875 d. 6 May 1949
9
Jenett Rabina Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.4.7]
b. 10 Jul 1879 d. 24 May 1963
9
William S. Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.4.8]
b. 7 Nov 1866 d. 7 Mar 1954
8
George Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5]
b. 30 Nov 1832 d. 5 Feb 1916
Elizabeth Graham
b. 24 Nov 1839 d. 21 Mar 1902
9
Jane Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.1]
b. 5 Jul 1861 d. Abt 1949
James Walker Russell
b. 5 Jan 1852 d. Abt 1916
10
Ina Elizabeth Russell
[1.1.1.1.2.1.4.5.1.1]
b. 19 Sep 1886
10
Lilian Mary Russell
[1.1.1.1.2.1.4.5.1.2]
b. 22 Dec 1888
9
William Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2]
b. 13 Dec 1862
Mary Ann Hawke
b. 15 Jul 1867 d. 8 Feb 1917
10
Waldon Roy Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1]
b. 9 May 1889 d. 13 Jan 1974
Gladys Emelia Wilhelmena Bremer
b. 4 May 1900 d. 29 Nov 1981
11
Everna Marie Anne Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.1]
Walter Neil Corry
b. 22 Jan 1920 d. 27 Feb 2004
12
Barrie Neil Corry
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.1.1]
12
Brian Howard Corry
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.1.2]
[
=>
]
12
Bradley Edward Corry
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.1.3]
11
Marion R. Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.2]
+
Harry Perrier
11
Manley L. Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.3]
+
Barbara Marsh
11
E. Arla Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.4]
+
Raymond Nelson
11
G. Norlene O. Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.5]
+
Unknown Hudgeon
11
R. Norris E. Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.6]
b. 9 May 1939 d. 3 Oct 1971
11
W. Orman R Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.7]
Gloria Morgan
12
Waldon Allan Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.7.1]
b. 10 Jan 1965 d. 31 Aug 1991
12
Robbie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.7.2]
12
Gene Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.7.3]
12
Linda Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.7.4]
12
Rosa Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.1.7.5]
10
Eva May Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2]
b. 21 Mar 1893 d. 4 Jul 1972
George Orange Dunlop
b. 22 Apr 1888 d. 1 Oct 1982
11
Eric Orange Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.1]
b. 21 Jun 1916 d. 10 Mar 1976
Norma Arlene Readman
12
David Eric Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.1.1]
12
Dennis Readman Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.1.2]
12
Paul Allen Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.1.3]
12
Karen Arlene Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.1.4]
12
Jeffery George Oliver Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.1.5]
12
Timothy Francis Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.1.6]
11
Autumn Marian Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.2]
Robert Percy Dale
12
Bonita Marian Dale
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.2.1]
12
Robert Glen Dale
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.2.2]
12
Bruce Murray Dale
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.2.3]
11
Ona Blanche Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.3]
Frank Norman Yarnold
12
Penny Louise Yarnold
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.3.1]
12
Robert Steven Frank Yarnold
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.3.2]
11
Glen Thomson Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.4]
Rose Marie Manning
12
John Garfield Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.4.1]
[
=>
]
12
Mark Thomson Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.4.2]
12
Kimberly Marie Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.4.3]
12
Christopher Allen Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.4.4]
12
Melanie Jill Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.4.5]
12
Elizabeth Ann Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.2.4.6]
10
George Harvie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.3]
b. 16 Feb 1895 d. Abt Aug 1972
10
William Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.2.4]
b. 1 Mar 1897
9
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.3]
b. 5 Nov 1864 d. 28 May 1942
John Thomas Graham
b. 25 May 1857 d. 5 Jun 1936
10
Joan Graham
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.1]
10
Elizabeth Maud Graham
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.2]
b. 7 Jun 1888
+
Hilton Leith
10
Eleanor Christian Graham
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3]
b. 25 Dec 1891 d. Abt 1970
John Dunlop
b. 19 Dec 1891 d. Abt 1980
11
Elizabeth Jane Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.1]
Ralph Brown Lipsett
12
Gregory Frank Lipsett
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.1.1]
12
Brian John Lipsett
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.1.2]
11
Dorothy Eleanor Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.2]
Calvin Rowmayne Croskill
12
Jeffrey Rowmayne Croskill
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.2.1]
12
Jo-Ann Elizabeth Croskill
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.2.2]
11
Grace Marie Dunlop
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.3]
Robert Reginald Tipping
12
Sonia Marie Tipping
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.3.1]
12
Richard Scott Tipping
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.3.2]
12
David John Tipping
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.3.3.3]
10
Frederic Richard Graham
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.4]
b. 21 Mar 1894 d. Abt 1932
10
George William John Graham
[1.1.1.1.2.1.4.5.3.5]
b. 8 Nov 1898
9
Janet Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.4]
b. 15 Mar 1866 d. Abt 1940
Robert J. Albert DeHart
b. 15 Jan 1869 d. 19 Oct 1943
10
Nora Alberta DeHart
[1.1.1.1.2.1.4.5.4.1]
b. 4 Feb 1900 d. Abt 1977
10
Elizabeth Marion DeHart
[1.1.1.1.2.1.4.5.4.2]
b. 29 May 1903 d. 12 Jun 1991
Percival Hugh Brimage
b. 19 Mar 1900 d. 25 Sep 1978
11
Barbara Elizabeth Brimage
[1.1.1.1.2.1.4.5.4.2.1]
+
Tom Gigliotti
11
Nora Jane Brimage
[1.1.1.1.2.1.4.5.4.2.2]
+
Harold O'Brien
9
David Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.5]
b. 8 Dec 1867 d. 28 Sep 1951
Maude Marion Fisher
b. 25 Aug 1872 d. 28 Mar 1956
10
Hazel Maude Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.1]
b. 24 Apr 1899 d. 30 Mar 1980
Albert Ernest Danforth
b. 16 Mar 1891 d. 24 Dec 1963
11
Francis David Danforth
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.1.1]
b. Abt Dec 1920
11
Kenneth Edward Danforth
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.1.2]
b. Abt Feb 1922
11
Helen Ilene Danforth
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.1.3]
b. 15 May 1923
11
Donald Arthur Danforth
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.1.4]
b. 10 Aug 1927 d. 1 Mar 1991
11
Dorothy Ruth Danforth
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.1.5]
b. 10 Aug 1927
11
Fred Danforth
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.1.6]
Unknown Yakubowski
12
Terry Ann Danforth
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.1.6.1]
12
Dwayne Danforth
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.1.6.2]
10
Marjorie Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.2]
b. 18 Jul 1901 d. 26 Dec 1990
+
Fredrick R. Gerl
b. Abt Jan 1905 d. 20 May 1987
10
George Elston Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.3]
b. 25 Feb 1905 d. 13 Sep 1905
10
Helen Marion Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4]
b. 20 Dec 1906 d. 24 Feb 1986
John Marshall Websdale
b. 13 Jan 1904 d. 16 Nov 1969
11
James Stanley Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.1]
b. 8 Jul 1933
Annette Ranville
b. 3 Apr 1931
12
Estelle Marie Delfine Neault
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.1.1]
[
=>
]
12
Rene Michael Craig Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.1.2]
12
Henri Derek Grant Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.1.3]
12
Francis John Stanley Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.1.4]
[
=>
]
12
Michelle Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.1.5]
11
Helen Marlene Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.2]
11
John Keith Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.3]
Helen Reimer
12
Karla Joanne Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.3.1]
[
=>
]
12
Katherine Louise Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.3.2]
[
=>
]
12
Robert Keith Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.3.3]
[
=>
]
12
Daniel James Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.3.4]
[
=>
]
11
Ronald Garth Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.4]
Audrey Jill Judd
12
Michael Jeffery Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.4.1]
12
Paul Douglas Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.4.2]
12
Sherri Ann Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.4.3]
[
=>
]
12
Scott Allen Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.4.4]
[
=>
]
+
Catherine Allen Wilson
11
Margaret Ruth Websdale
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.5]
Thomas Scott Henderson Edmonds
12
Elizabeth Alice Marion Edmonds
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.5.1]
12
Nicholas Albert John Edmonds
[1.1.1.1.2.1.4.5.5.4.5.2]
9
Margaret Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.6]
b. 23 Aug 1869 d. 25 Oct 1917
9
Christine Little Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.7]
b. 19 Apr 1871
Hiram Brody Wood
10
Alethia Wood
[1.1.1.1.2.1.4.5.7.1]
10
Etta Wood
[1.1.1.1.2.1.4.5.7.2]
9
Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8]
b. 13 Jan 1873 d. Abt 1947
Elizabeth Boyd Dunlop
b. Abt 1877 d. Abt 1972
10
George Graham Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.1]
b. 13 Aug 1909
Mildred Lucille Mahood
11
Susan Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.1.1]
+
James Terrance Stafford
11
George Mahood Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.1.2]
11
Mary Jane Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.1.3]
10
Elizabeth Marion Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.2]
John Dryden Johnston
b. Abt 1911 d. Abt 1967
11
Wendy Kaye Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.2.1]
11
John Peter Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.2.2]
11
Michael Dryden Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.2.3]
11
Elizabeth Ann Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.2.4]
11
Billie Virginia Johnston
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.2.5]
10
MacLaren Boyd Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.3]
Doris Alice MacPherson
11
Pamela Jane Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.3.1]
11
Jeffery Graham Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.3.2]
Kathryn
12
Koren Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.8.3.2.1]
9
Mary Isabella Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.9]
b. 17 Jun 1874 d. Abt 1956
John Clark Rumble
b. 5 Jun 1871 d. 15 Jul 1935
10
John Lancelot Graham Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.1]
b. 6 Sep 1895 d. Abt 1958
Georgia A. Lawson
b. 21 Jul 1900 d. 2 Dec 1997
11
Robert J. Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.1.1]
Unknown
12
Georgia Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.1.1.1]
[
=>
]
12
J. Lance Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.1.1.2]
[
=>
]
12
Jennifer Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.1.1.3]
[
=>
]
12
Robert L. Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.1.1.4]
[
=>
]
10
Mary Elizabeth Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.2]
b. 14 Aug 1897
W. H. Waldron
11
Mary Jane Waldron
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.2.1]
10
George Norman Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.3]
b. 25 Sep 1900
Grace Unknown
11
Betty Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.3.1]
11
John Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.3.2]
10
Dorthy Rae Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.4]
b. 8 Nov 1907
William Moncour
11
Mary Moncour
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.4.1]
10
Harold Clark Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.5]
b. Abt 1909
Laura Senn
11
Susan Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.5.1]
11
Peter Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.5.2]
11
Carolyn Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.5.3]
11
Dorothy Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.5.4]
10
John Christian Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.6]
b. Abt 1911 d. Abt 1989
Louise Ganton
11
Helen Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.6.1]
11
James Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.6.2]
11
John Rumble
[1.1.1.1.2.1.4.5.9.6.3]
9
Georgina Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.10]
b. 28 Dec 1875 d. Abt 1962
9
Robert Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.11]
b. 12 Jan 1878 d. 26 Feb 1954
9
Agnes Ellen Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.12]
b. 20 Aug 1880 d. 13 Jul 1950
9
John Charles Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.13]
b. 26 Jun 1882
Harriet Richardson
10
George Edwin Keith Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.13.1]
10
Harriet Marie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.13.2]
10
Marvin John Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.13.3]
10
Donald Gilri Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.13.4]
10
James Austin Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.13.5]
10
Ernest Robert Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.13.6]
9
Effie Rae Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.5.14]
b. 3 Oct 1885 d. 13 Jul 1972
+
William Arthur Moffit
b. 3 Apr 1885 d. 4 Dec 1980
8
James Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.6]
b. 25 Dec 1835 d. Bef 7 Jun 1841
8
Anne Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.7]
b. 27 Aug 1840
8
James Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.8]
b. 18 Feb 1843 d. 9 Aug 1908
Margaret Dunn
b. 1 Jun 1846 d. 4 Mar 1915
9
David Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.8.1]
b. Abt Feb 1871 d. 28 Oct 1953
+
Maude Alice Mair (Chambers) Archibald
b. Abt 1869 d. 20 Aug 1959
9
Thomas Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.8.2]
b. 28 Nov 1872 d. 20 Mar 1940
9
Margaret Ellen Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.8.3]
b. 28 Jan 1875 d. 26 Oct 1958
Samuel Cotton Harvie
b. 9 Aug 1874 d. 3 Jun 1961
10
Infant (female) Harvie
[1.1.1.1.2.1.4.8.3.1]
b. 21 Mar 1907 d. 22 Mar 1907
10
Elsie Jean Harvie
[1.1.1.1.2.1.4.8.3.2]
b. 16 Jul 1909 d. 25 Feb 2001
Jonathan Peter Cook
b. 8 Mar 1913 d. 30 Dec 1990
11
James Thomson Cook
[1.1.1.1.2.1.4.8.3.2.1]
Lynda Jean McGaughey
12
James Jonathan Cook
[1.1.1.1.2.1.4.8.3.2.1.1]
[
=>
]
11
Dorothy Jean Cook
[1.1.1.1.2.1.4.8.3.2.2]
Ernest Joseph Exavier Young
b. 23 Dec 1936 d. 5 Oct 2004
12
Christopher Wilson Young
[1.1.1.1.2.1.4.8.3.2.2.1]
12
Dayna Michelle Young
[1.1.1.1.2.1.4.8.3.2.2.2]
[
=>
]
12
David Ernest Young
[1.1.1.1.2.1.4.8.3.2.2.3]
[
=>
]
8
Margaret Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.9]
b. 28 Sep 1845 d. 28 Jun 1933
Daniel Walker
b. 12 May 1841 d. 24 Jul 1918
9
Edga Jane Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.1]
b. 24 Sep 1869 d. 24 May 1938
William George Mounsey Overend
b. 3 Nov 1865 d. 4 Aug 1939
10
Dora Maud Janette Overend
[1.1.1.1.2.1.4.9.1.1]
b. 27 Nov 1900 d. Abt 1968
Earl Thomas Richard Rose
b. 2 Nov 1901 d. Abt 1980
11
Howard Rose
[1.1.1.1.2.1.4.9.1.1.1]
b. 12 Oct 1933 d. 12 Oct 1933
9
George Daniel Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2]
b. 26 Apr 1871 d. 28 Jan 1942
Margaret Ann Johnstone
b. 8 May 1873 d. 25 Aug 1968
10
Marian Margaret Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.1]
b. 19 May 1904 d. 10 Apr 1995
10
Wilma Ellerene Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.2]
b. 23 May 1906 d. Abt Nov 1959
Kenneth Johnson
11
Will Johnson
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.2.1]
11
Ken Johnson
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.2.2]
11
Don Johnson
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.2.3]
10
James Daniel Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.3]
b. 29 Jan 1908 d. 7 Aug 1991
Enid Doris Welsh
b. 23 Feb 1912 d. 14 Jul 1997
11
Helen Margaret Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.3.1]
Gordon Osborne
12
Shelley Margaret Osborne
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.3.1.1]
[
=>
]
12
Douglas Victor Osborne
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.3.1.2]
11
Glen David Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.3.2]
Karen Lena Lyon
12
Carey David Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.3.2.1]
12
Shane Lyon Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.3.2.2]
11
William Dale Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.3.3]
10
George Lloyd Johnstone Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.4]
b. 4 Jun 1912 d. 24 Jul 1943
10
Eunice Irene Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.5]
b. 19 May 1914
Thomas Alexander Phillips
b. 30 Aug 1914 d. 3 Apr 1982
11
Margaret Elizabeth Phillips
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.5.1]
+
John Allen Nattress
b. Abt 1939 d. Abt 2000
11
Catherine Anne Phillips
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.5.2]
Frans Visser
12
Michael Frans Visser
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.5.2.1]
12
Laura Visser
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.5.2.2]
[
=>
]
11
Janet Florence Phillips
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.5.3]
Ronald Clarke
12
Jennifer Clarke
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.5.3.1]
[
=>
]
12
Heather Clarke
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.5.3.2]
12
Sarah Clarke
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.5.3.3]
[
=>
]
10
David Thomson Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.6]
b. 27 Oct 1916 d. 29 Nov 1987
Gloria Catherine Greatwich
11
Bernice Anne Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.6.1]
11
Pamela Mary Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.6.2]
Barry Ziegler
12
Morgan Ziegler
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.6.2.1]
12
Alex Ziegler
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.6.2.2]
10
Grace Jeanette Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.2.7]
b. 27 Oct 1916 d. 23 Apr 1990
9
Janet Maria Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.3]
b. 21 Jun 1873 d. 17 May 1945
William Francis Rix
b. Abt 1866 d. 3 Jun 1948
10
Walker William Daniel Rix
[1.1.1.1.2.1.4.9.3.1]
b. 18 Jan 1902 d. 6 Jan 2001
Lenora Irene Ward
b. 23 Jun 1915 d. 27 Jul 2004
11
Lawrence William Rix
[1.1.1.1.2.1.4.9.3.1.1]
b. 21 Aug 1950 d. 31 Jan 1952
11
Frances Rix
[1.1.1.1.2.1.4.9.3.1.2]
Douglas Thompson
12
Adam Thompson
[1.1.1.1.2.1.4.9.3.1.2.1]
12
Ruth Ann Thompson
[1.1.1.1.2.1.4.9.3.1.2.2]
10
Joseph Henry Rix
[1.1.1.1.2.1.4.9.3.2]
b. Abt 1910 d. 7 May 1996
Elizabeth Virginia Ried
b. Abt 1917 d. 21 Apr 2004
11
James Joseph Rix
[1.1.1.1.2.1.4.9.3.2.1]
+
Lynn Diane Gurnett
11
JoAnne Elizabeth Rix
[1.1.1.1.2.1.4.9.3.2.2]
+
Ross Wellman Phelps
9
David Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.4]
b. 24 Aug 1875 d. 30 Dec 1951
Marion Anderson
b. 1 Sep 1893 d. 15 Sep 1982
10
Garry Richard Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.4.1]
Alma Moore
11
Stephen Richard Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.4.1.1]
+
Sharon Lynn Ganton
11
Cindy Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.4.1.2]
+
S. J. Barden
+
Patricia Moore Miller
10
Barbara Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.4.2]
+
John Pattenden
9
Edmund Joseph Wilfred Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5]
b. 30 Sep 1878 d. 11 Aug 1958
Alice Hattie McKinley
b. 3 Dec 1888 d. 6 Oct 1937
10
Beverly Earl Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1]
b. 1 Nov 1911 d. 21 Mar 1996
Helen Jean Rose Walker
b. 19 Aug 1915
11
Donald Wilfred John Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1.1]
Mildred Isabel Silk
12
Rhondda Jane Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1.1.1]
[
=>
]
11
George Allan Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1.2]
Elaine Rosalind Anderson
12
Adrienne Elaine Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1.2.1]
12
Gregory Allan Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1.2.2]
11
Beverly Charles Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1.3]
Barbara Irene Beard
12
Donna Marie Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1.3.1]
[
=>
]
12
Sharon Barbara Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1.3.2]
12
Bradley James Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.1.3.3]
[
=>
]
10
Wilfred Daniel Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.2]
b. 3 Jan 1915
Elsie Gertrude Archer
b. 9 Mar 1914 d. 13 Jul 1940
11
Howard Leslie Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.2.1]
Peggy Mick
12
Daniel Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.2.1.1]
[
=>
]
12
Tom Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.2.1.2]
[
=>
]
12
Timothy William Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.2.1.3]
[
=>
]
12
Laura Jane Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.2.1.4]
[
=>
]
12
Don Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.2.1.5]
[
=>
]
Edna Evelyn Vollick
b. Abt 1914 d. Abt 1976
11
William Frederick Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.2.2]
Judy N. McIndoo
12
Darren Lee Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.2.2.1]
b. Abt 1969 d. Abt 1975
+
Mary Laura Doyle
b. 25 Sep 1922 d. 1 Jan 1994
10
Edgar George Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3]
b. 11 Jul 1916
Maysella Doreen Johnson
b. Abt 1919 d. 18 Feb 1986
11
Flossy Elizabeth Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.1]
b. 9 Dec 1939 d. 9 Sep 1940
11
Shirley Doreen Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.2]
Donald Charles Balkwill
12
Michael Charles Balkwill
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.2.1]
[
=>
]
12
Paul Donald Balkwill
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.2.2]
[
=>
]
12
Daniel James Balkwill
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.2.3]
12
Peter John Balkwill
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.2.4]
11
Robert George Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.3]
Dianne Victoria Waterfield
12
Robert Wayne Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.3.1]
12
Victoria Lynn Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.3.2]
11
Norman Edward Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.4]
Mary Belle Revel
12
John Edward Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.4.1]
12
James Martin Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.5.3.4.2]
[
=>
]
9
Archibald Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.6]
b. 17 Jun 1881 d. 10 Nov 1954
9
Margaret Ida Maud Walker
[1.1.1.1.2.1.4.9.7]
b. 5 Dec 1883 d. 20 Sep 1953
Neil Mathieson
b. 14 Mar 1881 d. 22 Jan 1964
10
Walker Donald Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.1]
b. 11 May 1913 d. 28 Sep 1975
Mona Viola Hubert
b. 11 Apr 1920 d. 25 Aug 2004
11
John David Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.1.1]
b. 11 Jun 1949 d. 19 Apr 2013
Mary Phillips
12
Alexandra Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.1.1.1]
12
Natalie Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.1.1.2]
+
Ann Klingner
11
James Herbert Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.1.2]
Cora Crawford
12
Steven Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.1.2.1]
12
Joy Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.1.2.2]
10
Kenneth Neil Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.2]
b. 18 Feb 1915 d. 28 Oct 1987
Betty B. Cull
b. Abt 1923 d. 22 Feb 2001
11
Keith Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.2.1]
+
Linda Cameron
11
Joe Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.2.2]
+
Donna Unknown
11
Bill Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.2.3]
+
Susan Unknown
11
Donna Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.2.4]
Stephen Jones
12
Sarah Jones
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.2.4.1]
12
Matthew Jones
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.2.4.2]
11
Linda Dale Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.2.5]
b. Abt 1956 d. Abt 1976
10
Ida Jean Mathieson
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.3]
b. 29 Jun 1921
Ken Keeler
11
Barron Keeler
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.3.1]
11
Neilda Keeler
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.3.2]
Peter Speedie
12
Phillip Speedie
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.3.2.1]
12
Katie Speedie
[1.1.1.1.2.1.4.9.7.3.2.2]
+
Lorne Quick
8
John Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10]
b. 16 Dec 1823 d. 29 Mar 1907
Adeline Elliott
b. Abt 1831 d. 25 Oct 1898
9
William Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.1]
b. 31 Mar 1853 d. Abt 1853
9
Annie Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.2]
b. 15 May 1854 d. 28 Dec 1941
John Baird
b. 1 Aug 1845 d. 3 Mar 1913
10
Fanny Adeline Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1]
b. 16 Mar 1879 d. 2 Apr 1959
James Glendinning
b. 14 Feb 1872 d. 15 Feb 1945
11
Alexander Caswell Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.1]
b. 1 Jan 1900 d. 15 Jul 1984
Violet Anne Geib Hanson
b. Abt 1907 d. 8 Mar 1996
12
Velma Geib
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.1.1]
12
Derwood Geib
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.1.2]
[
=>
]
11
Harold Baird Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.2]
b. 30 Jul 1902 d. 26 Feb 1957
Marie McDonald
b. Abt 1907 d. 18 Jul 1975
12
Edward Alvin Glendenning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.2.1]
b. 16 Nov 1926 d. 10 Aug 1999
12
Harold Marvin Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.2.2]
b. 12 Dec 1929 d. 24 May 1986 [
=>
]
12
Richard Harvey Glendenning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.2.3]
b. 21 Nov 1933 d. 23 Nov 1996 [
=>
]
12
Brian Allan Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.2.4]
b. 27 Oct 1935 d. 4 Jul 1993 [
=>
]
12
Ralph Arthur Glendenning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.2.5]
[
=>
]
11
Infant Daughter Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.3]
b. 13 Jul 1905 d. 2 Aug 1905
11
James Alton Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.4]
b. 29 Aug 1906 d. 24 Oct 2000
Alice Lillian Webster
b. 18 Feb 1909 d. 9 May 1990
12
Peter Webster Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.4.1]
b. 19 May 1945 d. 18 Feb 2006 [
=>
]
11
Edythe Marie Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.5]
b. 30 Aug 1909 d. 9 Apr 2004
Arden McKenzie Brown
b. 10 May 1908 d. Abt 1992
12
Glen Arden Brown
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.5.1]
12
James McKenzie Brown
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.5.2]
[
=>
]
12
Bettye Marie Brown
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.5.3]
[
=>
]
12
Patricia Ann Brown
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.5.4]
11
John Ernest Woodrow Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.6]
b. 15 Dec 1912 d. 1 Sep 2001
Dorothy Lillian MacKenzie
b. 11 Feb 1914 d. 15 Jun 1999
12
Marie Adelle Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.6.1]
12
Shirley Grey Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.6.2]
[
=>
]
12
John David Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.6.3]
[
=>
]
11
Robert Jamieson Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.7]
b. 17 May 1917 d. 6 Sep 1968
Patricia I. Robbins
b. Abt 1917
12
Sandra P. Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.7.1]
12
Robert Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.7.2]
[
=>
]
12
Richard Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.7.3]
12
Barbara Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.7.4]
12
Martin Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.7.5]
12
Norma D. Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.7.6]
11
Lorne Wallace Glendinning
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.1.8]
b. 9 Jun 1926
+
Frances Isobel Wishart
b. 10 Dec 1926 d. 24 Jul 1991
+
Veryl Uhl
b. 24 Sep 1927
10
Mary Ann Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.2]
b. Abt 1881 d. 27 Jun 1959
+
John Pettigrew
b. Abt 1873 d. 17 May 1959
10
James Alexander Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3]
b. 30 Jan 1884 d. 3 Jan 1963
Carrie Greenfield
b. 27 Jan 1886 d. 23 Jun 1977
11
Mary Adeline Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.1]
b. 15 Dec 1909 d. 10 May 1996
+
Ernest Ingle
d. Bef 1948
+
John Haley Barmby
b. 4 Jul 1905 d. 17 Sep 1964
+
Arthur Ray Bladon
b. Abt 1899 d. 17 Jul 1967
11
John William Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.2]
b. 23 Mar 1911 d. 29 Jul 1975
+
Josephine Yunker
b. Abt 1911 d. 16 Mar 1992
11
Annie Emma Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.3]
b. 24 Mar 1915
Archie Stephenson Hagerty
b. 21 Jul 1914 d. 16 Sep 2001
12
James Andrew Hagerty
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.3.1]
[
=>
]
12
Shelda Mae Hagerty
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.3.2]
[
=>
]
12
Ronald Evan Hagerty
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.3.3]
[
=>
]
12
Margaret Anne Hagerty
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.3.4]
12
Ross Allen Hagerty
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.3.5]
[
=>
]
11
Norman James Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.4]
b. 29 Mar 1919
Mona Joyce Van Male
b. Abt 1927
12
Robert Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.4.1]
[
=>
]
12
Douglas Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.4.2]
11
Fannie Kathryn Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.5]
b. 19 Jan 1925 d. 22 Feb 2004
Arthur Lucas Harvey
b. 19 Sep 1921 d. 9 Feb 1999
12
Carol Anne Harvey
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.5.1]
[
=>
]
12
Mary Louise Harvey
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.5.2]
[
=>
]
12
Janet Kathryn Harvey
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.5.3]
[
=>
]
12
Arlene Jean Harvey
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.3.5.4]
[
=>
]
10
John Ernest Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4]
b. Abt 1886 d. 30 Dec 1960
Elizabeth Alice McNaughton
b. 1 Aug 1887 d. 20 Aug 1977
11
Lawrence McNaughton Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.1]
b. 7 Jun 1913 d. 3 Jul 1979
+
Christine Fairweather
b. 3 May 1918
11
Robert Thomas Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.2]
b. 8 Oct 1917 d. 26 Jul 1986
Ellen Isabelle Millar
b. 18 Feb 1921
12
Kenneth Neil Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.2.1]
[
=>
]
12
Sharon Joan Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.2.2]
[
=>
]
11
John Ernest Baird ll
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.3]
b. 21 Nov 1918 d. 5 Sep 1995
Lily Anne Morrissey
b. 23 Oct 1920 d. 5 Jun 1999
12
John Ernest Baird lll
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.3.1]
b. Abt 1960 d. Abt 1960
11
Doris Ella Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.4]
b. 14 Dec 1919 d. 30 Nov 2001
Earl Deaver
b. 2 Jan 1913 d. 6 Mar 1968
12
Robert Earl Deaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.4.1]
[
=>
]
12
James E. Deaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.4.2]
b. 20 Nov 1944 d. 27 Nov 1944
12
Donald Wayne Deaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.4.3]
[
=>
]
12
Joanne E. Deaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.4.4]
b. 5 Apr 1951 d. 11 May 1953
12
Gregory Ernest Deaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.4.4.5]
10
Robert Jackson Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.5]
b. 16 Oct 1888 d. 9 Apr 1917
10
Agnes Helen Baird
[1.1.1.1.2.1.4.10.2.6]
b. 24 Jun 1891 d. 26 Nov 1988
9
William Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3]
b. 8 Jun 1856 d. 7 Apr 1939
Mary Jane Connell
b. 27 Sep 1860 d. 20 Jan 1953
10
Wilfred Murray Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1]
b. 5 Apr 1889 d. 28 Jun 1920
Mabel Irene Colwell
b. 30 Jan 1890 d. 25 Apr 1970
11
William Harold Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.1]
b. 5 Mar 1914 d. 13 Jul 2002
Avis Mabel Margory Rouse
b. 10 Sep 1917 d. 6 Oct 1979
12
Jane Louise Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.1.1]
[
=>
]
12
Wilfred Charles Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.1.2]
b. 2 Jun 1942 d. 8 Sep 1942
12
John Roger Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.1.3]
[
=>
]
11
Margaret Isobel Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.2]
b. 3 Nov 1917 d. 3 Mar 2000
Edward William Harper
b. 7 Nov 1914 d. 20 Jul 1998
12
Carol Marie Harper
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.2.1]
[
=>
]
12
Rhonda Louise Harper
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.2.2]
12
Susan Lynne Harper
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.2.3]
[
=>
]
11
John Wilfred Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.3]
b. 3 Dec 1919 d. 18 Dec 1987
Jean Catherine MacPhail
b. 16 Aug 1921 d. 22 May 2002
12
William Gordon Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.3.1]
[
=>
]
12
Fraser John Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.3.2]
12
Laura-Jean Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.1.3.3]
[
=>
]
10
Janet Peden Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.2]
b. 29 Mar 1891 d. Abt 1947
Osborne Graham Wallace
bur. 8 Jan 1951
11
Jean Osborne Wallace
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.2.1]
b. 3 Jan 1922 d. Abt 1997
John Fredrick Cornhill
d. 26 Apr 1982
12
John Fredrick Cornhill
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.2.1.1]
[
=>
]
12
David Wallace Cornhill
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.2.1.2]
[
=>
]
10
Agnes Mabel Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.3]
b. 26 Aug 1893 d. 6 Oct 1916
10
John Harvey Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4]
b. 1 Feb 1896 d. 19 Jul 1960
Frances Sarah Chisholm
b. 8 Jan 1902 d. 9 Oct 1995
11
Elizabeth Helen Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.1]
Harvey John Underhill
b. 26 Mar 1933
12
Brian Thomson Underhill
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.1.1]
[
=>
]
12
Dori Lynn Underhill
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.1.2]
[
=>
]
12
Barbara Ann Underhill
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.1.3]
[
=>
]
12
Lisa Marie Underhill
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.1.4]
[
=>
]
12
John Paul Underhill
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.1.5]
[
=>
]
11
Mary Gwendolyn Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.2]
Roy Keith Byram
12
Karen Kimberly Byram
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.2.1]
[
=>
]
12
Lori Lynn Byram
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.2.2]
[
=>
]
12
Jennifer Jill Byram
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.4.2.3]
[
=>
]
10
Margaret Connell Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.5]
b. 3 Jan 1901 d. Abt 4 Feb 1968
10
Mary Helen Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.3.6]
b. 29 Nov 1904 d. 20 Oct 1982
9
Helen Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.4]
b. 1 Mar 1859 d. 19 Jan 1929
Mark Alfred Hewitt
b. 24 May 1853 d. 26 Jun 1935
10
Alice Arabella Hewitt
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1]
b. 20 Oct 1886 d. 26 Dec 1973
Charles Sydney Akers
b. 7 Jan 1876 d. 29 Jun 1953
11
Helen Akers
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.1]
b. 14 Oct 1914
+
Richard Stanford
11
Harold Akers
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.2]
b. Abt 1917 d. 10 May 1979
11
John Akers
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.3]
b. Abt 1920
11
Grace Akers
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.4]
b. Abt 1922
Jim Gallagher
12
Unknown Gallagher
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.4.1]
12
Deny Gallagher
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.4.2]
11
Mae Akers
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.5]
b. Abt 1924
+
Unknown Mercer
11
Ruth Akers
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.6]
b. Abt 1926
D. Babbit
12
Len Babbit
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.6.1]
12
David Babbit
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.6.2]
12
Brian Babbit
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.1.6.3]
+
Charles Bawdry
10
Norman Llewellyn Hewitt
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.2]
b. 20 Sep 1889 d. 30 Sep 1964
Florine Kennely
b. Abt 1893
11
Llewelyn Hewitt
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.2.1]
b. Abt 1915
+
Gladys Unknown
+
Becky Unknown
10
Olive Helen Hewitt
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3]
b. 16 Nov 1891 d. 10 Feb 1991
William Robert Gauley
b. 29 Mar 1875 d. 12 Oct 1957
11
Isiah Sherman Gauley
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.1]
b. 18 Apr 1920
+
Laura Adeline Cranston
b. 26 Dec 1917 d. 24 Dec 1969
+
Mary Frances Kanawyer
b. 17 May 1914 d. 30 Jun 2004
+
Marjorie Loring
11
Robert Alfred Gauley
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.2]
b. 19 Oct 1921
Adelaide Rudnicki
b. 14 May 1927
12
Jeffrey Dean Gauley
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.2.1]
[
=>
]
12
Mark Andrew Gauley
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.2.2]
12
Harvey Jay Gauley
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.2.3]
[
=>
]
12
Wesley John Gauley
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.2.4]
[
=>
]
11
Esther Elizabeth Gauley
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.3]
b. 21 Jul 1925
Alfred Harry Sabin
b. 23 Feb 1914 d. 24 Sep 1986
12
James Andrew Sabin
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.3.1]
12
Joanne Linda Sabin
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.3.2]
[
=>
]
12
Ronald Robert Sabin
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.3.3]
12
Lorna Jean Sabin
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.3.4]
[
=>
]
11
Dorothy Jean Gauley
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.3.4]
b. 12 Dec 1927
+
Daniel Charuk
b. Abt 1917 d. Abt 1978
+
Dennis Jones
10
Ralph Emerson Hewitt
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.4]
b. 7 Apr 1894 d. 15 Apr 1915
10
Jean Adeline Hewitt
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5]
b. 26 Feb 1897 d. 15 Apr 1971
Jay Wilfred Shaver
b. 4 Mar 1899 d. 8 Dec 1982
11
Harvey Jay Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.1]
b. Abt 1918
Doris Cronquist
12
Margo Jean Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.1.1]
12
Loreen Gale Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.1.2]
12
William Alfred Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.1.3]
12
Janice Louise Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.1.4]
12
Wendy Lee Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.1.5]
11
Archie William Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.2]
b. 18 Sep 1919
Stella Pearl Sabin
12
Gary Leslie Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.2.1]
12
Dawn Dale Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.2.2]
12
Ricky Jay Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.2.3]
12
Conroy Boyd Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.2.4]
12
Mark Wesley Archie Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.2.5]
12
Lois Jean Stella Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.2.6]
12
Melody Evelyn Beth Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.2.7]
11
Norman Wilfred Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.3]
Stella Irene Greval
12
Randy Norman Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.3.1]
12
Janet Joan Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.3.2]
12
Darcy Jean Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.3.3]
b. 14 Nov 1956 d. 23 Jan 2003
12
Milton Jay Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.3.4]
12
Norman Corey Scott Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.3.5]
11
Leonard Robert Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.4]
Eileen Doris Stevens
12
Brenda Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.4.1]
12
Clinton Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.4.2]
11
Kenneth Bruce Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.5]
b. 29 Sep 1929 d. 22 Apr 1994
Barbara Catherine Stemper
b. 13 Jul 1929 d. 2 Jan 1989
12
Barbara Joan Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.5.1]
[
=>
]
Joyce Westburg
12
James Shaver
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.5.5.2]
10
Gwenny Annette Hewitt
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6]
b. 7 Oct 1899 d. 23 Jun 1999
Charles Bryan
b. 20 Nov 1890 d. 23 Jan 1964
11
Douglas Charles Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.1]
b. 20 Feb 1923
Sarah Evelyn Bussell
b. 23 Jan 1932
12
James Douglas Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.1.1]
[
=>
]
12
David Charles Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.1.2]
12
Patricia Gwen Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.1.3]
[
=>
]
12
Joyce Catherine Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.1.4]
[
=>
]
11
Esther Dorothea Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.2]
b. 2 Jan 1924 d. Abt Mar 2002
Morris Andrew Taylor
b. Abt 1911 d. Abt 1984
12
Lynne Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.2.1]
12
Kenneth Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.2.2]
[
=>
]
12
Carol Ann Taylor
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.2.3]
[
=>
]
11
William Ephraim Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.3]
b. 14 Jan 1929
Louise Haines
12
Colleen Patricia Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.3.1]
12
Laurel Lynne Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.3.2]
[
=>
]
+
Irene Wheeler
11
Patricia Anne Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.4]
b. 17 Mar 1932 d. 28 Feb 1993
Campbell Mayes
12
Neil Campbell Mayes
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.4.1]
b. Abt 1957 d. Abt 2000
12
Colen Robert Mayes
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.4.2]
[
=>
]
12
Bryan Clayton Mayes
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.4.3]
[
=>
]
11
Robert David Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.5]
Joan Marion Barfield
12
Michael Robert Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.5.1]
[
=>
]
12
Gwenda May Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.5.2]
12
Marion Lynda Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.5.3]
[
=>
]
11
Molly Vera Bryan
[1.1.1.1.2.1.4.10.4.6.6]
b. 4 Feb 1938 d. 13 Sep 1956
9
Fanny Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.5]
b. 8 Sep 1861 d. 17 Sep 1942
William Smith
b. 31 Oct 1853 d. 18 Jan 1938
10
Janet Norma Smith
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1]
b. 20 Nov 1893 d. 3 Apr 1983
Albert Bridge
b. 25 Oct 1890 d. 29 Jul 1977
11
Francis Marion Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.1]
b. 16 Mar 1916
William John Clark
b. 12 Sep 1911 d. 26 May 1994
12
John George Albert Clark
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.1.1]
12
Walter William Clark
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.1.2]
11
Walter E. Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.2]
b. 26 Feb 1918 d. 9 Dec 2005
Hilda Ma Thomas
b. 22 May 1922
12
David Walter Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.2.1]
[
=>
]
12
Ruth Anne Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.2.2]
[
=>
]
12
Harvey Thomas Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.2.3]
[
=>
]
12
Phillip Arthur Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.2.4]
b. 26 Apr 1958 d. 12 Oct 1997
11
Robert George Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.3]
b. 2 Mar 1920 d. 2 May 2006
Joyce Helen Taylor
b. 8 Jul 1927
12
Warren Robert Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.3.1]
[
=>
]
12
Trevor George Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.3.2]
[
=>
]
11
Ross Albert Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.4]
b. 8 Sep 1921 d. 11 Mar 2005
Grace Margaret Wenzel
b. 30 Nov 1926
12
Verna Jean Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.4.1]
[
=>
]
12
Judith Lynn Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.4.2]
b. 17 Nov 1950 d. 28 Apr 1987 [
=>
]
12
Debra Margaret Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.4.3]
[
=>
]
11
Norma Jean Bridge
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.5]
b. 21 Nov 1925 d. 20 Apr 1997
Donald Griffith Hayes
b. 17 Dec 1926 d. 1 Apr 1996
12
Margaret Ann Hayes
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.5.1]
[
=>
]
12
Brian Donald Hayes
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.1.5.2]
[
=>
]
10
Mabel Adeline Smith
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2]
b. 30 Aug 1897 d. 2 Jul 2001
Reuben Charles Kriter
b. 12 Jan 1893 d. 19 Jan 1956
11
Donald Wray Kriter
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2.1]
b. 10 Feb 1926 d. 8 Dec 1951
11
Bruce William Kriter
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2.2]
b. 16 May 1929
Margaret Velma Carnie
b. 8 May 1931
12
Donald Kevin Kriter
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2.2.1]
[
=>
]
12
Carol Ann Kriter
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2.2.2]
[
=>
]
11
Marjorie Jane Kriter
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2.3]
b. 10 Mar 1931
Neil Alexander McColl
12
Deborah Jane McColl
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2.3.1]
[
=>
]
12
Nancy Ann McColl
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2.3.2]
12
Kathryn Alexandria McColl
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2.3.3]
[
=>
]
12
Donald Alexander McColl
[1.1.1.1.2.1.4.10.5.2.3.4]
9
Jane Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.6]
b. 16 Apr 1864 d. 8 Jun 1927
Samuel Robert Cragg
b. Abt 1865 d. Abt 1938
10
Emerson Joseph Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.1]
b. 26 Jan 1893 d. 4 Jul 1922
Laura Ella Cruickshank
b. 27 Oct 1895 d. 15 Nov 1984
11
Robert Murray Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.1.1]
Agnes Clark
12
Sandra L. Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.1.1.1]
12
Barbara Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.1.1.2]
12
Mary Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.1.1.3]
12
Elizabeth Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.1.1.4]
12
Marjorie Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.1.1.5]
12
Catherine Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.1.1.6]
10
Gladys Jean Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.2]
b. 22 Oct 1896 d. 6 Oct 1988
10
Lilian Adeline Cragg
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3]
b. 19 May 1904 d. 8 Apr 1971
Robert Elven Foster
b. Abt 1900 d. 9 May 1950
11
Jean Charolette Foster
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.1]
b. 2 Jun 1929 d. 29 Feb 2000
Douglas Frank McKay
b. Abt 1924
12
Catherine Jane McKay
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.1.1]
[
=>
]
12
David John McKay
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.1.2]
[
=>
]
12
Barbara Jean McKay
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.1.3]
[
=>
]
11
Brock R. Foster
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.2]
b. 8 May 1932 d. 30 Dec 1980
Jeanne Omand
12
Thomas Alexander Foster
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.2.1]
[
=>
]
12
Margo Jane Foster
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.2.2]
[
=>
]
11
Neil Foster
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.3]
Doris Smith
12
Robert Foster
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.3.1]
[
=>
]
12
Stephen Foster
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.3.2]
[
=>
]
12
Elizabeth Foster
[1.1.1.1.2.1.4.10.6.3.3.3]
[
=>
]
9
David Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.7]
b. 20 Feb 1867 d. Abt Sep 1940
Florence Albertha Allan
b. 4 May 1878 d. 31 Jul 1931
10
Edna Adelaide Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1]
b. 5 Sep 1905 d. 11 Oct 1971
Wesley Elhannan Blood
b. 20 Jun 1879 d. 19 Oct 1966
11
Earl Kenneth Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.1]
b. 3 Feb 1909 d. 11 Mar 1994
Hazel Stewart
b. Abt 1913
12
Gloria Unknown
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.1.1]
b. Bef 1944 d. Abt Dec 2005 [
=>
]
12
Linda Loretta Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.1.2]
[
=>
]
12
Elyse Ann Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.1.3]
11
Samuel Willard Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.2]
b. 29 Nov 1910
May Undershute
12
Patricia Louise Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.2.1]
b. 20 Apr 1932 [
=>
]
12
Allen Wayne Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.2.2]
b. 20 Jul 1938 d. 29 Sep 1997 [
=>
]
11
Glen Merlin Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.3]
b. 26 Feb 1922 d. 31 Mar 2007
Doris Pauline Asmundson
b. 27 Dec 1923
12
Guy Wesley Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.3.1]
12
Ronald Kevin Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.3.2]
[
=>
]
12
Lenna Merle Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.3.3]
[
=>
]
12
Danna Paulette Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.3.4]
[
=>
]
11
Wesley Eugene Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.4]
b. 18 Apr 1930
Evelyn Ethel Elizabeth Ryan
b. 2 Sep 1932
12
Randal Gene Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.4.1]
[
=>
]
12
Bonnie June Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.4.2]
[
=>
]
12
Robert Jay Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.4.3]
12
Connie Marie Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.4.4]
11
Janice Marvorueen Blood
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.5]
Frank George Gardener
12
Franklin Trent Gardener
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.5.1]
[
=>
]
12
Kenneth Murray Gardener
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.1.5.2]
[
=>
]
10
Robert Allen Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2]
b. 25 Aug 1907 d. 1 Jul 1971
Camilla Dorthea Pederson
b. 3 Mar 1909 d. 28 Sep 1997
11
Donald Sveum
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.1]
b. 13 Oct 1932
11
Nancy Sveum
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.2]
+
Alvin Hughes
11
Kenneth Sveum
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.3]
11
Mildred Sveum
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.4]
George Earl Denning
b. 22 Jun 1930 d. Abt Sep 1988
12
Gary Denning
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.4.1]
[
=>
]
12
Darryl Denning
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.4.2]
[
=>
]
12
Fay Denning
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.4.3]
11
Lloyd Sveum
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.5]
11
Olive Sveum
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.6]
Bernard Monson
b. 6 May 1931 d. 17 Jun 1986
12
Connie Fay Monson
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.6.1]
[
=>
]
12
Penny Lee Monson
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.6.2]
12
Blaine Odean Monson
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.2.6.3]
10
Jessie Maud Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.3]
b. 17 Apr 1909 d. 11 Oct 1981
Addy Meindert Erick Mulder
b. 20 Jul 1907 d. 11 Mar 1955
11
Sharon Adrienne Mulder
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.3.1]
10
Iola Jean Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4]
b. 26 May 1912 d. 22 Aug 1998
George Edward Lee
b. 16 Oct 1896 d. 29 Oct 1982
11
Larry George Lee
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.1]
b. 10 Sep 1933 d. 21 May 1972
Phyllis Jean Vold
12
Barbara Ann Lee
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.1.1]
12
Lori Jean Lee
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.1.2]
12
Randall Larry Lee
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.1.3]
[
=>
]
12
Ricky Darwin Lee
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.1.4]
[
=>
]
11
Samuel Neil Lee
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.2]
b. 23 Dec 1935 d. 9 Apr 2000
Charlotte (Mastel) Lanz
12
Tammy Lanz
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.2.1]
12
Stephanie Lanz
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.2.2]
11
Enid Gail Alberta Lee
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.3]
Gordon Melvin Christensen
12
Tracy Lee Christensen
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.3.1]
[
=>
]
12
Kelly Rae Christensen
[1.1.1.1.2.1.4.10.7.4.3.2]
9
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.8]
b. 25 Feb 1870 d. 27 Apr 1938
9
Mary Adeline Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.9]
b. 1 Nov 1872 d. 26 Aug 1953
9
Robert Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.10]
b. 1 Nov 1875 d. 22 Mar 1919
9
John Albert Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11]
b. 17 Apr 1879 d. 8 Oct 1936
Mabel Ethel Fallis
b. 1 Nov 1884 d. 25 Nov 1963
10
James Albert Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.1]
b. 7 Jan 1910 d. 6 May 1996
Gladys Irene Belton Phillips
b. 29 May 1918
11
Bonnie Dune Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.1.1]
Richard Jacob Schappert
12
Shauna Doone Fathers
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.1.1.1]
[
=>
]
12
Angella Nadean Schappert
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.1.1.2]
b. 19 Sep 1977 d. 23 Jun 2000
+
Charles Henry Fathers
+
Agnes MacDonald
b. 16 May 1918 d. 2 Feb 2005
10
Robert Allen Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2]
b. 4 Nov 1911 d. 14 Jan 1987
Mildred Ophelia Munford
b. 10 Apr 1917 d. 29 Mar 2007
11
Joyce Elaine Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.1]
Lewis Vaughn Hiltz
12
Barry Lewis Hiltz
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.1.1]
[
=>
]
12
Connie Dawn Hiltz
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.1.2]
12
Patricia Gwen Hiltz
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.1.3]
12
Mark Edwin Hiltz
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.1.4]
[
=>
]
11
Robert Wayne Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.2]
b. 29 Aug 1940 d. Oct 2015
11
Diana Gail Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.3]
Douglas Hoffman Eklund
12
Joanne Fay Eklund
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.3.1]
[
=>
]
12
Daryl Vernon Eklund
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.3.2]
[
=>
]
12
Tracy Dawn Eklund
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.3.3]
[
=>
]
12
Lee Douglas Eklund
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.3.4]
11
Douglas Dale Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.4]
Evelyn Grace Rieder
12
Shawna Beth Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.4.1]
12
Cory Douglas Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.4.2]
+
Soubheih (Sabah) Mouhamad (Hamzeh) Daou
Ann Audrey (Goodmurphy) Gronlund
b. 3 Jan 1929
11
Shirley Ann Gronlund
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.5]
Neil Morris Johnson
12
Victoria Mary-Ann Johnson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.5.1]
12
Stephen-Thomas Robert Johnson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.5.2]
12
Alexander Albert Johnson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.5.3]
11
Carolyn Audrey Gronlund
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.6]
11
Richard James Gronlund
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.7]
Carolyn Jones
12
Angela Marie Jones
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.7.1]
Carolyn (Jones) Pyke
12
Angela Marie (Jones) Pyke
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.7.2]
12
Lindsay Christine Pyke
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.7.3]
+
Carrol Grace (McDavid) Chollak
11
Patricia Sue Gronlund
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.8]
Mark Nigel Welford
12
Miles Peter Welford
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.8.1]
11
Jill Violet Gronlund
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.9]
Joseph Allan Stanley
12
Alison Brianna Stanley
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.9.1]
Lee Jay Steeves
12
Robert David Steeves
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.2.9.2]
10
Susan Ethel Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.3]
b. 25 Aug 1913 d. 30 Aug 1996
George Clarke Rear
b. 23 Nov 1914 d. 26 Dec 1995
11
Carole Diane Rear
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.3.1]
b. 22 May 1943 d. 24 Sep 1970
11
Sandra Marlene Rear
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.3.2]
Andre Norman Lalonde
12
Megan Mireille Lalonde
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.3.2.1]
[
=>
]
12
Meika Chantal Lalonde
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.3.2.2]
10
Ben Gordon Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.4]
b. 26 Jul 1923 d. 14 Sep 1990
Thelma Elsie Marjorie McLeod
b. 29 Sep 1920
11
Patricia Anne Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.4.1]
Philip Robert Russell
b. 8 Dec 1948 d. 17 Jul 1999
12
Aliza Jane Russell
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.4.1.1]
11
Robert Gordon Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.4.2]
b. 20 Dec 1956 d. 10 Mar 1988
Denise Pamela Horne Kelsh
12
Christine Kelsh
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.4.2.1]
12
Royce Kelsh
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.4.2.2]
[
=>
]
12
Krystal Kathleen Kelsh Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.4.2.3]
[
=>
]
12
Kyle Gordon William Kelsh Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.4.2.4]
12
Andrew Kelsh Thomson
[1.1.1.1.2.1.4.10.11.4.2.5]
7
Janet (Jane) Thomson
[1.1.1.1.2.1.5]
b. 18 Jul 1801 d. 27 Feb 1874
George Harvey
b. 26 Feb 1798 d. 7 Nov 1869
8
Margaret Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.1]
b. 8 Nov 1829 d. 9 Jan 1849
8
James Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.2]
b. 3 Oct 1831 d. 5 Jan 1895
Elizabrth McNab
b. Jun 1840
9
George Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.2.1]
b. 1869
9
Peter Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.2.2]
b. 1870
9
John James Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.2.3]
b. 25 May 1874
8
Anne Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.3]
b. 11 Mar 1834 d. 6 Jul 1906
8
George Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4]
b. 11 Aug 1836 d. 21 Aug 1905
Mary Wilson
b. 1838 d. 26 Jul 1903
9
John Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.1]
b. 1876
9
Thomas Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2]
b. 2 Dec 1878 d. 24 Feb 1950
Elizabeth Barclay
b. 2 Apr 1877 d. 6 Nov 1947
10
Robert Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.1]
b. 5 Aug 1900 d. 14 Apr 1965
Alice Rebecca Fuller Fergusson
b. 10 Aug 1897 d. 20 Aug 1982
11
George Alexander Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.1.1]
b. 1926 d. 1998
11
William John Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.1.2]
b. 1931 d. 28 Apr 1965
11
Mary Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.1.3]
11
Betty Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.1.4]
10
Mary Wilson Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.2]
b. 1901
10
Marfaret Craig Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.3]
b. 1903
10
George Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.4]
b. 1905
10
James Stanley Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.5]
b. 6 Dec 1907 d. 1981
Annie Evelyn Barratt
b. 27 Aug 1908 d. 1985
11
Graeme Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.5.1]
10
Agnes Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.6]
10
Doris Elizabeth Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.7]
10
Thomas Witham Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.8]
10
Charles Gordon Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.2.9]
9
Mary Elizabeth Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.4.3]
b. 1881
8
Elizabeth Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.5]
b. Jul 1839 d. 14 Feb 1894
Frank Dickson
b. 1833 d. 15 Feb 1909
9
Margaret Dickson
[1.1.1.1.2.1.5.5.1]
b. 1861
9
Frank Dickson
[1.1.1.1.2.1.5.5.2]
b. 24 Dec 1863 d. 1953
8
William Harvey
[1.1.1.1.2.1.5.6]
b. 22 Dec 1843
7
Margaret Thomson
[1.1.1.1.2.1.6]
b. 22 Apr 1803 d. 18 Oct 1823
James Glendinning
b. 13 Oct 1800 d. 6 Nov 1855
8
John Glendinning
[1.1.1.1.2.1.6.1]
b. 6 May 1821 d. 14 Apr 1822
7
Ann Thomson
[1.1.1.1.2.1.7]
b. 27 May 1805 d. 2 Oct 1879
+
Thomas Telfer
b. 1788 d. 21 Oct 1830
7
John Thomson
[1.1.1.1.2.1.8]
b. 8 Nov 1808
7
Bridget Thomson
[1.1.1.1.2.1.9]
b. 8 May 1809
7
Archibald Thomson
[1.1.1.1.2.1.10]
b. 4 Feb 1811
6
Archibald Little
[1.1.1.1.2.2]
b. 1763
6
William Little
[1.1.1.1.2.3]
b. 1767 d. 28 Aug 1768
6
George Little
[1.1.1.1.2.4]
b. 1759 d. 24 Apr 1810
6
Jean Little
[1.1.1.1.2.5]
d. 6 Jan 1847
6
Margaret Little
[1.1.1.1.2.6]
b. 7 Jun 1770
6
Agnes Little
[1.1.1.1.2.7]
b. 24 Dec 1772 d. 21 Sep 1816
+
John Beattie
b. 28 Apr 1766
5
John Glendinning
[1.1.1.1.3]
b. 1734 d. 23 May 1811
5
Agnes Glendinning
[1.1.1.1.4]
b. 1725 d. 4 Apr 1792
5
James Glendinning
[1.1.1.1.5]
b. 1731 d. Bef 17 Dec 1738
4
Jennet Glendinning
[1.1.1.2]
b. 1702 d. 7 May 1750
Christopher Borthwick
d. 1755
5
Alexander Borthwick
[1.1.1.2.1]
b. 1728
Margaret Anderson
6
Christopher Borthwick
[1.1.1.2.1.1]
b. 1757 d. 1808
+
Lilias Glendinning
b. 5 Feb 1764
6
Joanna Borthwick
[1.1.1.2.1.2]
b. 1772 d. 1825
Christopher Borthwick
b. 1760 d. 1818
7
Elizabeth Borthwick
[1.1.1.2.1.2.1]
b. 19 May 1802
William Glendinning
b. 8 Apr 1802
8
Christina Glendinning
[1.1.1.2.1.2.1.1]
b. 6 Jan 1837 d. 10 May 1920
Andrew Thomson
b. 31 Mar 1832 d. Bef 1881
9
Isabella Jane Thomson
[1.1.1.2.1.2.1.1.1]
b. 19 May 1859 d. 18 May 1885
+
George Green
b. 27 Mar 1861 d. 26 Aug 1948
9
Andrew Borthwick Thomson
[1.1.1.2.1.2.1.1.2]
b. 16 May 1862 d. 10 Mar 1877
9
William H. Thomson
[1.1.1.2.1.2.1.1.3]
b. 1865 d. 12 Mar 1877
9
Elizabeth Thomson
[1.1.1.2.1.2.1.1.4]
b. 1857 d. 29 Mar 1877
4
James Glendinning
[1.1.1.3]
b. 1706 d. 1776
4
Christopher Glendinning
[1.1.1.4]
b. 1707 d. 1800
4
William Glendinning
[1.1.1.5]
b. 1716
4
Thomas Glendinning
[1.1.1.6]
b. 1719 d. Bef 13 Oct 1723
4
Thomas Glendinning
[1.1.1.7]
b. 1723
Counts