Home
Bob's Side
Cath's Side
Steed Side
TNG Link
First Name:
Last Name:
Whispers Past
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Hannah Thayer
1685 - 1762 (77 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Hannah Thayer
[1]
b. 17 Feb 1685 d. 14 Nov 1762
Thomas Vinton
b. 31 Jan 1687 d. 18 Jan 1757
2
Anna Vinton
[1.1]
b. 7 Sep 1718 d. Aft 1799
Sergeant John Burrill
b. 30 Nov 1717 d. 12 Mar 1765
3
Mary Burrell
[1.1.1]
b. 22 Feb 1741 d. 29 Nov 1820
John Vinton Shaw
b. 31 Jan 1738 d. 1 Jul 1814
4
Daniel Shaw
[1.1.1.1]
b. 1765 d. 12 Nov 1850
Elizabeth Phillips
b. 1770 d. 1 May 1843
5
Ziba Shaw
[1.1.1.1.1]
b. Abt 1798 d. 12 Oct 1861
Elizabeth Phillips
b. Abt 1805
6
Simon Lyman Shaw
[1.1.1.1.1.1]
b. 1828 d. 7 Apr 1897
Phoebe Gray
b. 1829 d. Bef 1891
7
Wesley F. Shaw
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 11 Dec 1850 d. 1909
Ellen F. (Nellie) Stackhouse
b. 31 Jul 1849 d. 29 Jun 1922
8
Cora Shaw
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1879 d. 1894
8
Harry Joseph Shaw
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 20 Jan 1881
+
Lucy Ann Cummings
b. 12 Feb 1889 d. 1957
8
Sarah Bernice Shaw
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 3 Jun 1883 d. 1 Oct 1933
Harvey Levi Faulkner
b. 14 Apr 1877 d. 19 Jun 1933
9
Ferne Leora Faulkner
[1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 14 Jan 1902 d. Nov 1967
+
George Frederick Cook
b. 24 Feb 1907 d. 12 Oct 1984
9
Annie Amelia Faulkner
[1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 24 Dec 1904
Arthur Stephen Cummings
b. 16 Feb 1902 d. Aug 1980
10
Willard Allison Cummings
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. 1934 d. 8 Feb 2007
Julia Carpenter
11
Janet Cummings
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.1]
Kenneth Harding
12
Cale Harding
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.1.1]
12
Neil Harding
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.1.2]
11
David Cummings
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.2]
11
Richard Cummings
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.1.3]
10
Jeane Cummings
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.2]
+
Donald Davis
10
Donald Cummings
[1.1.1.1.1.1.1.3.2.3]
d. Bef 2007
9
Ada Maude Faulkner
[1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 14 Dec 1906 d. 5 May 1996
Harry Leon Hatfield
b. 30 May 1903 d. 29 Jan 1989
10
Dawn Hatfield
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
+
Dean Greer
+
Warren Stiles
b. 27 Jan 1931
10
Carol Hatfield
[1.1.1.1.1.1.1.3.3.2]
9
Julia Ruth Faulkner
[1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 4 Oct 1912 d. 26 Dec 2000
Humbert Charles Harris
b. 11 Jul 1900 d. 21 Jul 1986
10
Darrell C. Harris
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 8 Mar 1932 d. 5 Mar 1987
Betty M.
11
Susanna Harris
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
11
Lois Jean Harris
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.2]
10
Ellen Elizabeth Harris
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.2]
Harold Wayne Corey
11
Clifford Wayne Corey
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.1]
Leisa McAllister
12
Joshua Wayne Corey
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.1.1]
12
Ashley Mae Corey
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.1.2]
12
Jordan Lewis Corey
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.1.3]
11
Cynthia Elizabeth Corey
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.2]
+
Kenneth Alfred Kinney
10
Glendon Harris
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
b. 28 Oct 1939 d. 9 Dec 1984
11
Terry Lee Harris
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.1]
11
Kimberley Harris
[1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.2]
8
Charlotte Marjorie Shaw
[1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 2 Apr 1885 d. 2 Jul 1955
Lee Percy Orser
b. 1 Aug 1886 d. 25 Dec 1958
9
Ella Orser
[1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 14 Aug 1911
Vaughan Craig
b. 15 Jul 1905 d. 30 May 1965
10
Eugene Craig
[1.1.1.1.1.1.1.4.1.1]
b. 1931
Frederick Lee Newell
b. Abt 1879 d. 1903
9
Frederick Harold Newell
[1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 31 Jan 1902 d. 15 Jul 1997
Georgie Abbott
b. 1904
10
Bertrum Newell
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 1924
10
David Newell
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 1925
10
Frederick Newell
[1.1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 1929
9
John Wesley Newell
[1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 31 Jan 1902 d. Jan 1983
+
Cecelia Theresa Haley
9
Addington George Newell
[1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 26 Nov 1903 d. 17 Aug 1995
Ada Maria Broad
b. 9 Mar 1896 d. May 1979
10
Rebecca Newell
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 1924
Chester Craig
11
Daniel Craig
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.1]
11
Chester Craig
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.1.2]
10
Laura Madeline Newell
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2]
b. 9 Jul 1922 d. 2002
John Peter Zdanowicz
b. 16 Mar 1920 d. 1995
11
Ronald J. Zdanowicz
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.2.1]
b. 1944 d. 22 Nov 1964
10
Pauline Newell
[1.1.1.1.1.1.1.4.4.3]
b. 1923
+
George Diamond
8
Sadie D Shaw
[1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 3 Jul 1882
8
John W. Shaw
[1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 6 Oct 1886
8
Rachel F. Shaw
[1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 21 Mar 1889
7
Wayman Beecher Shaw
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 25 Nov 1861 d. 1916
Georgina Emily Shaw
b. 20 May 1864 d. 16 Oct 1914
8
Evelyn Lillian Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 1 Jul 1884 d. May 1956
Charles Arthur Lockhart
b. Oct 1881 d. 14 May 1956
9
Madeline Evelyn Lockhart
[1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 7 Apr 1906 d. 19 Jul 1948
+
Roy Gordon Belding
9
Juanita Ada Lockhart
[1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 31 Jul 1907
+
G. Asa Robinson
b. 15 Dec 1902
9
Flora Enid Lockhart
[1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 7 Apr 1909 d. 16 Aug 1924
+
Merrill Thomas Cox
9
Greta Glee Lockhart
[1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 10 Jun 1910
+
Harry Brown
b. 4 Sep 1885 d. 1974
9
Gladys Blanche Lockhart
[1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 10 Feb 1912
+
Frederick Doak
9
Leora Elaine Lockhart
[1.1.1.1.1.1.2.1.6]
b. 28 Jun 1913
8
Josephine Amy Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 6 Dec 1885 d. 1938
8
Lois Gertrude Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 11 Nov 1887 d. 26 Aug 1968
Allan Appleby Barter
b. 30 Mar 1882 d. 11 Nov 1974
9
Aubrey Barter
[1.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 1905 d. 1907
9
Ward Barter
[1.1.1.1.1.1.2.3.2]
b. 1906 d. 1907
9
Mabel Olivia Barter
[1.1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 1910 d. 1975
9
Gertrude Barter
[1.1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 1916 d. 1953
9
Frank Barter
[1.1.1.1.1.1.2.3.5]
b. 1919 d. 1919
9
Basil Barter
[1.1.1.1.1.1.2.3.6]
b. 1923 d. 1923
9
Gladys Barter
[1.1.1.1.1.1.2.3.7]
b. 1914
8
Frank Urban Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 2 Apr 1890 d. 11 Dec 1959
Elsie Elaine Chase
b. 22 Mar 1901 d. Jun 1975
9
Willa Jean Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.4.1]
b. Abt 1941 d. 12 Jul 2002
9
Garnet Allison Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.4.2]
b. 15 Jun 1924 d. Bef 2002
9
Perley Waldo Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.4.3]
b. 12 Dec 1926 d. 26 Jun 1988
9
Thora Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.4.4]
b. 19 Sep 1932 d. Bef 2002
9
Max Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.4.5]
9
Ishmael Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.4.6]
9
Daphene Wanda Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.4.7]
b. 23 Jan 1929 d. 4 Oct 2007
9
Elaine Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.4.8]
8
Margaret Isabel Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 7 Sep 1892 d. 22 Oct 1938
+
Burton Lewellyn Dyer
b. 18 Feb 1887 d. 24 Aug 1934
Bertrum Brooks
9
Gerald N. Brooks
[1.1.1.1.1.1.2.5.1]
8
Clyde Melville Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 2 Dec 1895
8
Velma Alice Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 26 Dec 1899 d. 24 Aug 1923
8
Viola Alice Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 26 Dec 1899
8
Perley Hudson Shaw
[1.1.1.1.1.1.2.9]
b. Aug 1902 d. 28 Sep 1915
7
Jane Shaw
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 16 Jan 1854
James Barnett
b. 15 Jun 1845
8
Alice Barnett
[1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 17 Mar 1889
8
Elizabeth Barnett
[1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 7 Dec 1879
8
Ella Eliza Barnett
[1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 28 Jun 1876
8
James Allan Barnett
[1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 8 Sep 1885 d. 1960
+
Kathleen McIntyre
b. 1871 d. 1951
8
Mabel Jane Barnett
[1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 7 Dec 1883
8
Mary Elizabeth Barnett
[1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 24 Nov 1881
8
Olive Barnett
[1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 11 Jul 1891
8
William Arthur Barnett
[1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 16 Feb 1877
7
Alice Evelyn Shaw
[1.1.1.1.1.1.4]
b. Abt 1854 d. Abt 1905
William Robert Stapleford
b. 1850 d. Abt 1910
8
Della G. Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.1]
b. Sep 1877
8
Ernest L. Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.2]
b. May 1890
8
Wayman George Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.3]
b. Apr 1885
8
Guy Victor Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 1 Jul 1879
Edith S. Tozier
b. 3 Oct 1881 d. 15 Feb 1970
9
Charles Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 6 Feb 1906 d. May 1985
9
Clarence Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.4.2]
9
Dorothy ? Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.4.3]
9
Grey Hamilton Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.4.4]
b. 10 Dec 1913 d. Apr 1980
8
Elizabeth J. Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.5]
b. Jul 1875
8
William P. Stapleford
[1.1.1.1.1.1.4.6]
b. May 1882
7
Horatio W. Shaw
[1.1.1.1.1.1.5]
b. Abt 1857 d. 1920
+
Alice M. Irvine
b. 1860 d. Abt 1920
7
Julyann Shaw
[1.1.1.1.1.1.6]
b. Abt 1850
7
Malecia Shaw
[1.1.1.1.1.1.7]
b. Abt 1855
4
Elisha Shaw
[1.1.1.2]
b. 7 May 1771 d. 15 Jul 1841
Susannah Kinney
b. 1776 d. 1816
5
Susanna Shaw
[1.1.1.2.1]
b. 6 Feb 1808 d. 3 Jun 1885
William McGee
b. 31 Jan 1802 d. 13 Mar 1865
6
Lydia Ann McGee
[1.1.1.2.1.1]
b. 7 Oct 1839 d. 14 Oct 1908
Wilford F. Siprell
b. 12 May 1836 d. 28 Aug 1917
7
Wilmette (Wilmot) E. Siprell
[1.1.1.2.1.1.1]
b. 4 Mar 1862 d. 10 Dec 1956
Edwin Thatcher Wolverton
b. 4 Feb 1862 d. 24 Nov 1930
8
Maude Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.1]
b. 10 Jul 1896 d. 16 Mar 1919
8
Norville Edwin Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.2]
b. 30 Jun 1889 d. 25 Sep 1958
Lelia Rosannah Foy
b. 11 Nov 1891 d. 27 Oct 1984
9
Violet Lelia Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.2.1]
b. 10 Mar 1916 d. 17 Jan 2011
9
Noeville Foy Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.2.2]
b. 6 Apr 1918 d. 29 Jul 1975
9
Lois Maud Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.2.3]
b. 26 Nov 1919 d. 22 Sep 2011
9
Barbara Enid Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.2.4]
b. 14 Feb 1922 d. 28 Feb 2009
9
Wilmont Rosannah Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.2.5]
b. 26 Mar 1924 d. 29 Mar 1985
9
Thatcher Edwin Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.2.6]
b. 22 Jan 1926 d. 18 Oct 1987
+
Louise Madeline Favorel
b. 22 Aug 1929 d. 5 Mar 2005
8
Enid Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.3]
b. 17 Sep 1891 d. 30 Nov 1988
8
Thatcher Siprell Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.4]
b. 9 Aug 1899 d. 22 Jul 1970
Luella Florence Woodhouse
b. 30 Apr 1902 d. 27 Mar 2004
9
Enid Luella Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.4.1]
b. 29 Jun 1926 d. 15 Apr 1992
9
Inez Edna Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.4.2]
8
Edna Wolverton
[1.1.1.2.1.1.1.5]
b. 31 Mar 1888 d. 15 May 1888
7
Annabel Siprell
[1.1.1.2.1.1.2]
b. 3 Sep 1864 d. 26 Nov 1883
Richard Heron
b. Feb 1856 d. 1926
8
Annabel Maude Heron
[1.1.1.2.1.1.2.1]
b. 7 Nov 1883 d. 31 Aug 1961
Joseph W. Allen
b. Abt 1878 d. Abt 1953
9
Joseph W. Allen
[1.1.1.2.1.1.2.1.1]
b. Abt 1904
7
Norville Earl Siprell
[1.1.1.2.1.1.3]
b. 28 Sep 1866 d. 22 Apr 1921
Maria Ida Marion
b. 13 Sep 1872 d. 18 Nov 1894
8
Earle W Siprell
[1.1.1.2.1.1.3.1]
b. 23 Feb 1893 d. 4 Apr 1914
7
Susan M. Siprell
[1.1.1.2.1.1.4]
b. 3 Mar 1869 d. 22 Dec 1953
Francis Sydney Bolt
b. Nov 1854 d. 12 Jun 1933
8
Betty Bolt
[1.1.1.2.1.1.4.1]
b. 11 May 1896 d. 3 Aug 1967
Elmer Roley
b. 18 Nov 1905 d. 9 May 1981
9
Betty Jean Roley
[1.1.1.2.1.1.4.1.1]
b. 14 Sep 1924 d. 2 Feb 2005
7
Lavina Mabel Siprell
[1.1.1.2.1.1.5]
b. 14 Nov 1871 d. 19 Mar 1964
John M. Jones
b. 12 Oct 1850 d. 20 Sep 1910
8
Helen Elizabeth Jones
[1.1.1.2.1.1.5.1]
b. 3 Sep 1904 d. May 1981
Franklin Girard
b. 20 Jul 1892 d. Dec 1968
9
Jeanne Siprell Girard
[1.1.1.2.1.1.5.1.1]
b. 15 Feb 1928 d. 1 Oct 2010
Robert Bauguess
b. 20 Jan 1922 d. 4 Sep 1997
10
Douglas Robert Bauguess
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.1]
+
Juanita Cherie Landis
10
Flora Helen Bauguess
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.2]
d. 22 Dec 1953
10
Candace Louise Bauguess
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.3]
10
Susan Elizabeth Bauguess
[1.1.1.2.1.1.5.1.1.4]
+
James O. Beck
7
Fisher W. Siprell
[1.1.1.2.1.1.6]
b. 9 Jan 1875 d. 18 Oct 1888
5
Lavina 'Maria' Shaw
[1.1.1.2.2]
b. 17 May 1815 d. 28 Oct 1893
Seth Siprell
b. 20 Aug 1801 d. 22 Dec 1886
6
Pheobe W. Siprell
[1.1.1.2.2.1]
b. 7 Jun 1834 d. 20 May 1859
Judah K. Hartt
b. 17 Mar 1836 d. 29 Jul 1907
7
Minnie Hartt
[1.1.1.2.2.1.1]
b. 1859 d. 1867
6
Wilford F. Siprell
[1.1.1.2.2.2]
b. 12 May 1836 d. 28 Aug 1917
Lydia Ann McGee
b. 7 Oct 1839 d. 14 Oct 1908
7
Wilmette (Wilmot) E. Siprell
[1.1.1.2.2.2.1]
b. 4 Mar 1862 d. 10 Dec 1956
Edwin Thatcher Wolverton
b. 4 Feb 1862 d. 24 Nov 1930
8
Maude Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.1]
b. 10 Jul 1896 d. 16 Mar 1919
8
Norville Edwin Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.2]
b. 30 Jun 1889 d. 25 Sep 1958
Lelia Rosannah Foy
b. 11 Nov 1891 d. 27 Oct 1984
9
Violet Lelia Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.2.1]
b. 10 Mar 1916 d. 17 Jan 2011
9
Noeville Foy Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.2.2]
b. 6 Apr 1918 d. 29 Jul 1975
9
Lois Maud Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.2.3]
b. 26 Nov 1919 d. 22 Sep 2011
9
Barbara Enid Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.2.4]
b. 14 Feb 1922 d. 28 Feb 2009
9
Wilmont Rosannah Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.2.5]
b. 26 Mar 1924 d. 29 Mar 1985
9
Thatcher Edwin Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.2.6]
b. 22 Jan 1926 d. 18 Oct 1987
+
Louise Madeline Favorel
b. 22 Aug 1929 d. 5 Mar 2005
8
Enid Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.3]
b. 17 Sep 1891 d. 30 Nov 1988
8
Thatcher Siprell Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.4]
b. 9 Aug 1899 d. 22 Jul 1970
Luella Florence Woodhouse
b. 30 Apr 1902 d. 27 Mar 2004
9
Enid Luella Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.4.1]
b. 29 Jun 1926 d. 15 Apr 1992
9
Inez Edna Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.4.2]
8
Edna Wolverton
[1.1.1.2.2.2.1.5]
b. 31 Mar 1888 d. 15 May 1888
7
Annabel Siprell
[1.1.1.2.2.2.2]
b. 3 Sep 1864 d. 26 Nov 1883
Richard Heron
b. Feb 1856 d. 1926
8
Annabel Maude Heron
[1.1.1.2.2.2.2.1]
b. 7 Nov 1883 d. 31 Aug 1961
Joseph W. Allen
b. Abt 1878 d. Abt 1953
9
Joseph W. Allen
[1.1.1.2.2.2.2.1.1]
b. Abt 1904
7
Norville Earl Siprell
[1.1.1.2.2.2.3]
b. 28 Sep 1866 d. 22 Apr 1921
Maria Ida Marion
b. 13 Sep 1872 d. 18 Nov 1894
8
Earle W Siprell
[1.1.1.2.2.2.3.1]
b. 23 Feb 1893 d. 4 Apr 1914
7
Susan M. Siprell
[1.1.1.2.2.2.4]
b. 3 Mar 1869 d. 22 Dec 1953
Francis Sydney Bolt
b. Nov 1854 d. 12 Jun 1933
8
Betty Bolt
[1.1.1.2.2.2.4.1]
b. 11 May 1896 d. 3 Aug 1967
Elmer Roley
b. 18 Nov 1905 d. 9 May 1981
9
Betty Jean Roley
[1.1.1.2.2.2.4.1.1]
b. 14 Sep 1924 d. 2 Feb 2005
7
Lavina Mabel Siprell
[1.1.1.2.2.2.5]
b. 14 Nov 1871 d. 19 Mar 1964
John M. Jones
b. 12 Oct 1850 d. 20 Sep 1910
8
Helen Elizabeth Jones
[1.1.1.2.2.2.5.1]
b. 3 Sep 1904 d. May 1981
Franklin Girard
b. 20 Jul 1892 d. Dec 1968
9
Jeanne Siprell Girard
[1.1.1.2.2.2.5.1.1]
b. 15 Feb 1928 d. 1 Oct 2010
Robert Bauguess
b. 20 Jan 1922 d. 4 Sep 1997
10
Douglas Robert Bauguess
[1.1.1.2.2.2.5.1.1.1]
+
Juanita Cherie Landis
10
Flora Helen Bauguess
[1.1.1.2.2.2.5.1.1.2]
d. 22 Dec 1953
10
Candace Louise Bauguess
[1.1.1.2.2.2.5.1.1.3]
10
Susan Elizabeth Bauguess
[1.1.1.2.2.2.5.1.1.4]
+
James O. Beck
7
Fisher W. Siprell
[1.1.1.2.2.2.6]
b. 9 Jan 1875 d. 18 Oct 1888
6
Elisha Shaw Siprelle
[1.1.1.2.2.3]
b. 24 Jul 1838 d. 13 Dec 1926
Angeline Rebecca Stevens
b. 7 Sep 1857 d. 29 Jun 1924
7
Minnie Belle Siprelle
[1.1.1.2.2.3.1]
b. 9 Apr 1876 d. Oct 1965
John T. Love
b. Abt 1867 d. 9 Jun 1946
8
Rae Sutherland Love
[1.1.1.2.2.3.1.1]
b. 29 Jul 1911 d. 5 Jan 1992
Carl Blake Shoonhoven
b. 24 Feb 1912
9
Carlyn Jack Shoonhoven
[1.1.1.2.2.3.1.1.1]
9
Carla R. Shoonhoven
[1.1.1.2.2.3.1.1.2]
7
Burton Seth Siprelle
[1.1.1.2.2.3.2]
b. 17 Mar 1877 d. 26 Nov 1940
Maude Hatfield
8
Velma Siprelle
[1.1.1.2.2.3.2.1]
8
Pauline Siprelle
[1.1.1.2.2.3.2.2]
b. Abt 1906
8
Duane L. Siprelle
[1.1.1.2.2.3.2.3]
b. 11 Mar 1916 d. 21 Jun 2001
+
Estella Jilson
b. Abt 1882
7
Elisha Hood Siprelle
[1.1.1.2.2.3.3]
b. Abt 1880
7
William Steven Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4]
b. 14 Jun 1884 d. 9 May 1952
Josephine C. Gendrow
b. 2 Aug 1892 d. 15 Jan 1987
8
William John Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1]
b. 25 Feb 1913 d. 6 Feb 1995
Mary Olive Dale
b. 7 Apr 1915
9
William Dale Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.1]
b. 19 Mar 1932
10
Kathy Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.1.1]
10
Ann Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.1.2]
10
Holly S Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.1.3]
10
William Dale Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.1.4]
10
Andrew Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.1.5]
9
Doris Lee Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.2]
Harry Edward Brannan
b. 18 Mar 1929
10
Stephen Edward Brannan
[1.1.1.2.2.3.4.1.2.1]
10
Thomas Creegan Brannan
[1.1.1.2.2.3.4.1.2.2]
10
Harry (Hal) Williams Brannan
[1.1.1.2.2.3.4.1.2.3]
10
Mark Edward Brannan
[1.1.1.2.2.3.4.1.2.4]
10
Daniel Louis Brannan
[1.1.1.2.2.3.4.1.2.5]
10
Matthew Allen Brannan
[1.1.1.2.2.3.4.1.2.6]
10
Mary Louella Brannan
[1.1.1.2.2.3.4.1.2.7]
10
Patricia Marie Brannan
[1.1.1.2.2.3.4.1.2.8]
9
Suzanne Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.3]
Gary Garner
10
Gregory Garner
[1.1.1.2.2.3.4.1.3.1]
10
Ronald Garner
[1.1.1.2.2.3.4.1.3.2]
10
Joseph Garner
[1.1.1.2.2.3.4.1.3.3]
10
Mary Garner
[1.1.1.2.2.3.4.1.3.4]
10
Scott Garner
[1.1.1.2.2.3.4.1.3.5]
9
Richard Keith Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.4]
Marion Charlene Kennerly
10
Elizabeth Marion Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.4.1]
10
Gina Michelle Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.4.2]
9
Mary Josephine Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.5]
+
James G. Bowe
9
Michael Faye Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.1.6]
+
Patricia Beemer
8
Faye E. Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.2]
b. Abt 1915 d. Nov 1946
Mabel Lea Foster
9
Kenneth Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.2.1]
Arlene Redmond
10
Sharon Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.2.1.1]
Robert Flores
11
Ann Marie Flores
[1.1.1.2.2.3.4.2.1.1.1]
11
Marianne Flores
[1.1.1.2.2.3.4.2.1.1.2]
10
Sandra Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.2.1.2]
James Lanz
11
Christine Kay Lanz
[1.1.1.2.2.3.4.2.1.2.1]
8
Keith Roy Siprelle
[1.1.1.2.2.3.4.3]
b. 10 Mar 1918 d. 15 Mar 1994
7
Maude G Siprelle
[1.1.1.2.2.3.5]
b. 20 Dec 1888 d. 3 Mar 1977
John H Oleson
b. Abt 1874
8
Velma Olsen
[1.1.1.2.2.3.5.1]
b. Abt 1907
William J Gribble
b. Abt 1888
8
William Gribble
[1.1.1.2.2.3.5.2]
7
Kenneth Harry Siprelle
[1.1.1.2.2.3.6]
b. Sep 1896 d. 30 Jan 1915
6
Alice Maude Siprell
[1.1.1.2.2.4]
b. 10 Dec 1856 d. 4 May 1935
Nathan A. Ames
b. 11 Jul 1846 d. 20 Mar 1923
7
Nita Lavina Ames
[1.1.1.2.2.4.1]
b. 16 Apr 1892 d. 10 Aug 1901
7
Sarah (Sadie) J. Ames
[1.1.1.2.2.4.2]
b. 14 Feb 1898 d. 10 Aug 1901
7
Laura V. Ames
[1.1.1.2.2.4.3]
b. 18 Apr 1900 d. 1971
+
William Pendergast
5
Nathaniel Shaw
[1.1.1.2.3]
b. 1794 d. 24 Jul 1847
Phoebe Ackerson
b. Abt 1798 d. 14 Sep 1872
6
Letitia Shaw
[1.1.1.2.3.1]
b. 16 Jul 1816 d. 7 Apr 1902
Rev Ezekiel Siprell
b. 10 Aug 1799 d. 9 Apr 1895
7
Martha Sipprell
[1.1.1.2.3.1.1]
b. 20 Aug 1835 d. 13 Apr 1901
John Henderson
b. 30 May 1830 d. Abt 1904
8
John Colby Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1]
b. 17 Mar 1856 d. 13 Dec 1936
Amanda Jane Orser
b. 27 May 1854 d. 25 Mar 1925
9
George Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.1]
9
Alice Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.2]
9
Frank Arnold Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3]
b. 29 Sep 1881 d. 3 Dec 1960
Cora Ferne Henderson
b. Mar 1886 d. 26 Jan 1912
10
Anna Ferne Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.1]
b. 12 Apr 1907 d. Abt 1982
Robert Lawrence
b. Abt 1899 d. Abt 1974
11
June Lawrence
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.1.1]
b. 25 Jun 1928
Richard Keene
12
Wendy Keene
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.1.1.1]
12
Larry Keene
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.1.1.2]
11
Lloyd Lawrence
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.1.2]
+
Wendy Jackman
10
Eunice Matilda Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.2]
b. 17 Jan 1909 d. Abt 1985
Robert Thompson
d. Abt 1977
11
Roberta Thompson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.2.1]
b. 4 Dec 1928
11
Glenn Thompson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.2.2]
Jean Nelson
12
Steven Thompson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.2.2.1]
12
Keith Thompson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.2.2.2]
12
Kenneth Thompson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.2.2.3]
10
Robert Leroy Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.3]
b. 2 Dec 1911
Phyliss Mayson
11
Robert Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.3.3.1]
9
John Crowell Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.4]
b. 6 Dec 1886 d. 28 Sep 1918
9
Roy Sipprell Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.5]
b. 1888 d. 12 May 1898
9
Russell Max Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.6]
b. 8 Feb 1890 d. 12 May 1898
9
Anna Evelyn Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.7]
b. 3 Sep 1894 d. 1902
9
Barbara Bessie Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.1.8]
b. 27 Jun 1900 d. Abt 1975
William James Prendergast
b. Abt 1896 d. 1943
10
Agnes Dorothy Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.1]
b. 9 Jan 1922
Perry Summerfield
11
Sandra Joy Summerfield
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.1.1]
Albert K. (Arne) Johnson
12
Dean Albert Johnson
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.1.1.1]
12
Lisa Ann Johnson
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.1.1.2]
11
Leslie William Summerfield Uhrich
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.1.2]
Lorraine Rubenson
12
Julie Ann Uhrich
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.1.2.1]
12
Leslie Uhrich
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.1.2.2]
Richard J. Uhrich
11
Anna Marie Uhrich
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.1.3]
+
Alan Framke
11
Richard J. Uhrich
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.1.4]
10
Billy Russell Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.2]
b. 18 Jul 1923 d. 16 Feb 1956
Emma Mae Curtice
11
Billy Russell Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.2.1]
+
Linda Tchy
11
Barbara Rae Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.2.2]
11
Beverly Roberta Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.2.3]
+
Carl Gustav Eggehorn
10
Gilbert Donald Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.3]
b. 25 Sep 1925
Dauna Walker
11
James Michael Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.3.1]
b. 17 Aug 1951 d. 2 Jun 1967
11
Donald Lee Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.3.2]
11
Judith Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.3.3]
11
Catherine Iola Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.3.4]
11
Daniel Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.3.5]
b. 5 May 1956 d. 14 Feb 1968
11
Cynthia Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.3.6]
11
Lynn Juanita Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.3.7]
11
Frank Wayne Prendergast
[1.1.1.2.3.1.1.1.8.3.8]
+
Ruth Hurlburt
8
Annie Eliza Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.2]
b. 8 Jan 1857 d. 1949
Edward S. Gilmor
9
Kathleen Gilmor
[1.1.1.2.3.1.1.2.1]
b. 1892
Willis E. Kitchen
10
Pauline Kitchen
[1.1.1.2.3.1.1.2.1.1]
b. 1919
+
E. J. Powell
10
Wesley Kitchen
[1.1.1.2.3.1.1.2.1.2]
b. 1924
Joyce East
11
Michael Kitchen
[1.1.1.2.3.1.1.2.1.2.1]
10
Kathleen Donna Kitchen
[1.1.1.2.3.1.1.2.1.3]
9
Luella Grace Gilmor
[1.1.1.2.3.1.1.2.2]
b. 1890
8
Permelia (Prim) Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.3]
b. Abt 1863 d. 4 Jan 1955
David M. Robinson
b. Abt 1858 d. Abt 1910
9
Clair Willard Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1]
b. 25 Apr 1883 d. 18 Jun 1960
Helen Bancroft
b. 23 Feb 1889
10
Eleanor L. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.1]
b. 9 Jul 1916
10
Willard B. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.2]
b. 19 Apr 1918
Alice Alsen
11
David B. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.2.1]
11
Robin Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.2.2]
11
Paul Alden Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.2.3]
11
Claire Louise Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.2.4]
11
W. Scott Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.2.5]
10
David B. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.3]
b. 4 Feb 1924
Louise Neff
11
Margaret Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.3.1]
11
Claire B. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.3.2]
11
D. Dana Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.3.3]
11
Deborah Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.3.4]
11
Eleanor C. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.3.5]
10
Claire F. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.4]
b. 18 Mar 1927
G. F. Earnshaw
11
Dale S. Earnshaw
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.4.1]
11
Joyce Earnshaw
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.4.2]
11
Helen Grace Earnshaw
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.4.3]
11
Joan E. Earnshaw
[1.1.1.2.3.1.1.3.1.4.4]
9
Edith A. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.2]
b. 9 Sep 1884 d. 31 Jan 1952
+
Lester Leonard
9
Adelaide Letitia Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.3]
b. 25 Mar 1886 d. Aft 1974
+
Alton W. Jackson
d. Abt 1995
9
Della M. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.4]
b. 11 Jul 1887 d. 5 Jul 1958
A. E. Merrill
10
Eloise B. Merrill
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.1]
b. 29 Oct 1907 d. Abt 1982
George Eldredge
b. Abt 1901 d. Abt 1976
11
Merrill H. Eldredge
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.1.1]
b. 27 May 1927
Doris Crump
12
Donna L. Eldredge
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.1.1.1]
12
Carol J. Eldredge
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.1.1.2]
12
Garry A. Eldredge
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.1.1.3]
12
Larry Eldredge
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.1.1.4]
+
Carroll L. Floyd
10
Thelma A. Merrill
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.2]
b. 14 Jun 1912
+
John H. Morse
+
A. E. Wall
A. E. Wall
10
Barbara H. Wall
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.3]
b. 15 Oct 1920
Howard C. Peterson
11
Judith Peterson
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.3.1]
11
Lane V. Peterson
[1.1.1.2.3.1.1.3.4.3.2]
9
Albert Wallace Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5]
b. 10 Jan 1891 d. 22 Nov 1963
Clara Cecelia Pheasant
10
Fred Llewellyn Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.1]
b. 11 Jul 1913
Ruby Mason
11
Clair Lorne Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.1.1]
11
Roger Lynn Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.1.2]
11
Frederica Ann Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.1.3]
11
David Albert Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.1.4]
Kathleen Keenan
11
Anna Marie Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.1.5]
11
Frederick Albert Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.1.6]
11
William Pheasant Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.1.7]
11
Heather Jane Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.1.8]
10
Mildred Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.2]
b. 27 Feb 1915
J. D. Atkinson
11
Clara Jean Atkinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.2.1]
11
Mary Lynn Atkinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.2.2]
10
Marjorie Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.3]
b. 15 Dec 1916
Douglas Moore
11
Albert Robinson Moore
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.3.1]
11
Della Mae Moore
[1.1.1.2.3.1.1.3.5.3.2]
9
Bessie G. Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.6]
b. 19 Oct 1892 d. 21 May 1951
Chester E. Roach
10
Claire A. Roach
[1.1.1.2.3.1.1.3.6.1]
b. 12 May 1911
Clinton F. Dunbar
11
Lynne Dunbar
[1.1.1.2.3.1.1.3.6.1.1]
+
David Blake
10
Alton C. Roach
[1.1.1.2.3.1.1.3.6.2]
b. 5 Jul 1913
+
Marion Flynn
9
Robert Colby Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.3.7]
b. 3 Nov 1894 d. Abt 1969
+
Anna Constance Tiedeman
+
Irma Blanche Walter
+
Fred O'Donnell
8
Elspeth (Eppie) Cameron Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.4]
b. 9 Jun 1869 d. 2 Jan 1919
Wilmot Wilson Robinson
b. 25 Aug 1860 d. 15 Sep 1940
9
Idella Rae Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.4.1]
b. 19 Nov 1887 d. 24 Mar 1958
Cecil Fitzsimmons
10
Helen Fitzsimmons
[1.1.1.2.3.1.1.4.1.1]
b. 1912 d. 30 Oct 1973
+
Alexander F. Hector
b. Abt 1909 d. Abt 1984
9
Ruby Irma Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.4.2]
b. 4 Feb 1891 d. 1985
Joseph Gans
b. 20 Jun 1882
10
Kathleen Gans
[1.1.1.2.3.1.1.4.2.1]
Dr. W. A. Hargan
11
Kathleen Hargan
[1.1.1.2.3.1.1.4.2.1.1]
11
Patricia Hargan
[1.1.1.2.3.1.1.4.2.1.2]
9
Muriel Pearl Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.4.3]
b. 21 Apr 1895 d. 13 Sep 1964
Leroy Milton London
b. 9 May 1896 d. 10 Dec 1964
10
Glenna Elspeth London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.1]
b. 29 Sep 1918 d. 23 Apr 2007
Garnet Thorburn
b. Abt 1911 d. 28 Mar 1986
11
Garnella Vivian Thorburn
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.1.1]
10
Muriel Evelyn London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.2]
b. 9 Mar 1920 d. Abt 2007
+
Walter Wiiliam Metherell
b. 1917 d. 1943
+
Arnold Ambrose
10
Vivian Josephine London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.3]
b. 17 Mar 1922 d. 4 Jan 2011
Charles A. McCarthy
b. 7 Jan 1919 d. 22 Oct 1982
11
Patti Ruth McCarthy
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.3.1]
10
Eugene Roland London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.4]
b. 23 Mar 1925 d. 1 Oct 2010
Faustina Marie Bubar
b. 11 Oct 1921 d. 1949
11
Robert London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.4.1]
d. Bef 1970
Glenna McCordia
11
Gaylon London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.4.2]
11
David London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.4.3]
11
Judith Ann London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.4.4]
10
Thelma Pearl London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.5]
b. 11 May 1932
Earle London
11
Janet Irene London
[1.1.1.2.3.1.1.4.3.5.1]
9
William Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.4.4]
b. 12 May 1900 d. 24 May 1900
9
Ruth Elsie Robinson
[1.1.1.2.3.1.1.4.5]
b. 26 Oct 1901 d. 1 Oct 1978
8
Adelaide Lillian Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.5]
b. 17 Sep 1861 d. 13 Jan 1941
Crowell Gayton
d. Abt 1943
9
Genevieve Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.1]
b. 22 Sep 1884
Richard Kelsey
10
Marcella Adelaide Kelsey
[1.1.1.2.3.1.1.5.1.1]
b. 22 Aug 1907
Amner Petty
11
Adelaide Amneris Petty
[1.1.1.2.3.1.1.5.1.1.1]
Walter Ewing
12
Neal Walton Ewing
[1.1.1.2.3.1.1.5.1.1.1.1]
12
Carol June Ewing
[1.1.1.2.3.1.1.5.1.1.1.2]
12
Michele Joan Ewing
[1.1.1.2.3.1.1.5.1.1.1.3]
12
Kay Kaura Ewing
[1.1.1.2.3.1.1.5.1.1.1.4]
10
June Elizabeth Kelsey
[1.1.1.2.3.1.1.5.1.2]
b. 9 Jun 1910
+
Montel Montgomery
10
Claudia Juanita Kelsey
[1.1.1.2.3.1.1.5.1.3]
b. 8 Aug 1912
9
Claude Victor Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.2]
b. 11 May 1886 d. Dec 1937
Eileen McAlister
10
Terre Joan Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.1]
b. 9 Jul 1928
Donald Welch
11
Donald Edward Welch
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.1.1]
11
Bryan Gayton Welch
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.1.2]
11
Maris Christina Welch
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.1.3]
11
Victor Gayton Welch
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.1.4]
11
Stephen Gayton Welch
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.1.5]
11
Kyle Gayton Welch
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.1.6]
11
Tara Gayton Welch
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.1.7]
10
Carlo Bernadette Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2]
b. 8 Mar 1930
Francis Touhey
11
Tereze Maria Touhey
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2.1]
11
Francis William Touhey
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2.2]
11
Eileen Frances Touhey
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2.3]
11
Claudia Gayton Touhey
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2.4]
11
Anthony McAlister Touhey
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2.5]
11
James Patrick Touhey
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2.6]
11
Carl Edward Touhey
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2.7]
11
Justine Maria Touhey
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2.8]
11
Carlo Bernadette Touhey
[1.1.1.2.3.1.1.5.2.2.9]
9
Martha Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.3]
b. 1892
9
John Avard Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.4]
b. 3 May 1893 d. 10 Oct 1968
9
Donald McLeod Vince Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.5]
b. 5 Jan 1898
+
Mary Manchester
Josephine Hilt
10
Donald McLeod Vince Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.5.1]
b. 22 Nov 1919
Dorothy Rollesfon
11
Meredith Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.5.1.1]
11
Donald McLeod Vince Gayton
[1.1.1.2.3.1.1.5.5.1.2]
8
Geneva Fayette Henderson
[1.1.1.2.3.1.1.6]
b. 1 Jul 1880 d. 24 Apr 1966
Harry Fenwick Shaw
b. 2 May 1874 d. 12 Mar 1952
9
Juanita Fenwick Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.1]
b. 29 Jun 1898 d. 20 Sep 1988
Stanley Percy Tompkins
b. 16 Oct 1898 d. 27 Oct 1989
10
Phylis Estelle Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.1]
b. 2 Oct 1920
J. Edwin Nordquist
11
Dennis Edwin Nordquist
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.1.1]
10
Davis Vaughn Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.2]
b. 1 Dec 1923
Greta Darling Law
11
Carl Davis Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.2.1]
G. J. Dresser
12
Bryan Douglas Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.2.1.1]
12
Donna Ruth Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.2.1.2]
10
Chester Earl Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.3]
b. 9 May 1933
Gertrude Smith
11
Stanley William Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.3.1]
11
Steven Roger Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.3.2]
11
Juanita May Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.3.3]
11
Wayne Merrill Tompkins
[1.1.1.2.3.1.1.6.1.3.4]
9
Davis Spurgeon Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.2]
b. 17 Dec 1899 d. Bef 2009
Priscilla Young
10
Harry William Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.2.1]
Sandra Doctor
d. 1 Oct 1965
11
David Anthony Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.2.1.1]
b. 31 Dec 1958 d. 1 Oct 1965
11
Sydney Allison Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.2.1.2]
b. 29 Dec 1960 d. 1 Oct 1965
10
Ethel Marjorie Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.2.2]
Curtis Roderick
11
Gregory Roderick
[1.1.1.2.3.1.1.6.2.2.1]
11
Peter Roderick
[1.1.1.2.3.1.1.6.2.2.2]
9
Martha Jane Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.3]
b. 10 Jun 1901 d. 10 Sep 1907
9
Lottie Beatrice Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.4]
b. 25 Jan 1903 d. 6 Aug 1947
Guy Augustus Pratt
b. 17 Feb 1893 d. 30 Dec 1977
10
Cyril Raymond Pratt
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.1]
b. 11 May 1923 d. Bef 2006
Muriel Zwicker
11
Sharon Pratt
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.1.1]
11
Ivan Pratt
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.1.2]
10
Virginia Stewart Pratt
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2]
b. 17 May 1926 d. 11 Oct 2009
David Redmond Fry
b. 1 Feb 1919 d. 7 Jan 2007
11
Joan Elizabeth Fry
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2.1]
Steve Both
12
Lynette Both
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2.1.1]
12
Wayne Both
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2.1.2]
12
Gary Both
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2.1.3]
12
Lauralee Both
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2.1.4]
12
Andrew Both
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2.1.5]
11
Blair Sherman Fry
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2.2]
Janice Dimock
12
Justin Fry
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2.2.1]
12
Lauren Fry
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.2.2.2]
10
Guy Augustus Jr. Pratt
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.3]
b. 9 Jan 1929 d. 9 Oct 2006
Anna Pauline Sharpe
b. 14 Oct 1929 d. 3 Jan 2017
11
Donna Pratt
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.3.1]
11
Clifford Roy Pratt
[1.1.1.2.3.1.1.6.4.3.2]
b. 15 Aug 1965 d. 22 Dec 2015
9
Virginia Stewart Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.5]
b. 19 Jul 1904 d. Bef 2009
Ivan T. Forsberg
10
Susan Claire Forsberg
[1.1.1.2.3.1.1.6.5.1]
+
Gerald Radasci
10
Diana J. Forsberg
[1.1.1.2.3.1.1.6.5.2]
9
Annette Hill Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.6]
b. 13 Jan 1906 d. 30 Jun 1953
Casimo D. Caso
10
Barbara Evelyn Caso
[1.1.1.2.3.1.1.6.6.1]
b. 23 Aug 1932
Earl Sowell
d. 1970
11
Michael Sowell
[1.1.1.2.3.1.1.6.6.1.1]
11
Annette Sowell
[1.1.1.2.3.1.1.6.6.1.2]
11
Darryl Sowell
[1.1.1.2.3.1.1.6.6.1.3]
10
Priscilla Caso
[1.1.1.2.3.1.1.6.6.2]
9
Harry Fenton Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.7]
b. 7 Jun 1907 d. Bef 2009
Ethel M. White
10
Roland Willard Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.7.1]
b. 5 Apr 1930
Virginia Sanders
11
Sandra Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.7.1.1]
11
Sally Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.7.1.2]
11
Bruce Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.7.1.3]
11
Brenda Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.7.1.4]
9
Ruby Evelyn Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.8]
b. 15 Mar 1909 d. 12 Mar 1957
9
Mildred Fayette Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.9]
b. 26 Jan 1912 d. 15 Mar 1912
9
Etta Sherrill Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.10]
b. 16 Oct 1913 d. Aft Mar 2009
William J. Reeves
10
Roberta Ann Reeves
[1.1.1.2.3.1.1.6.10.1]
10
Sherrill Elizabeth Reeves
[1.1.1.2.3.1.1.6.10.2]
9
Earl Kitchener Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.11]
b. 10 Mar 1915 d. 6 Apr 1938
Ella E. Buckingham
10
Sherrille B. Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.11.1]
b. 31 Oct 1933
Lester Moznik
11
Danny Moznik
[1.1.1.2.3.1.1.6.11.1.1]
11
Dale Moznik
[1.1.1.2.3.1.1.6.11.1.2]
11
Jeannette Moznik
[1.1.1.2.3.1.1.6.11.1.3]
11
Roy Moznik
[1.1.1.2.3.1.1.6.11.1.4]
9
Geneva Fern Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.12]
b. 8 Dec 1916 d. 13 Nov 1935
9
Willis John Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.13]
b. 26 Jun 1919 d. Bef 2009
Isabel Olive White
10
Valerie Elaine Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.13.1]
10
Elspeth Evelyn Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.13.2]
9
Rowena Eloise Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.14]
b. 9 Dec 1920 d. 17 Mar 2009
Charles MacDonald
d. 16 Feb 2005
10
Rebecca Louise MacDonald
[1.1.1.2.3.1.1.6.14.1]
Myles MacCallum
11
Wade MacCallum
[1.1.1.2.3.1.1.6.14.1.1]
11
Garth MacCallum
[1.1.1.2.3.1.1.6.14.1.2]
10
Emily Louise MacDonald
[1.1.1.2.3.1.1.6.14.2]
Delbert Bouton
11
Greg Bouton
[1.1.1.2.3.1.1.6.14.2.1]
11
Sara Bouton
[1.1.1.2.3.1.1.6.14.2.2]
+
Coleman Erwin
9
Malcolm Gerald Shaw
[1.1.1.2.3.1.1.6.15]
b. 17 Oct 1922 d. 27 Oct 1922
7
Samuel Sipprell
[1.1.1.2.3.1.2]
b. 12 Apr 1836 d. 13 Apr 1836
7
Samuel Sipprell, II
[1.1.1.2.3.1.3]
b. 23 Feb 1837 d. 19 Jan 1905
Esther Ann Boyer
b. 7 Feb 1842 d. 10 Oct 1882
8
Ernest Alfred Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1]
b. 29 Jun 1868 d. Abt 1943
Beatrice Kilpatrick
b. Abt 1872 d. Abt 1947
9
James Winston Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1]
b. 1900 d. 1974
Helen Margaret Libby
b. 22 Oct 1905 d. Abt 1980
10
Robert Gaylon Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.1]
b. 1 Dec 1933 d. 19 Jul 2014
Shirley Brown
11
Barbara Lee Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.1.1]
11
Brian Leslie Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.1.2]
Edith Margaret Cleghorn
12
Megan Leslie Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.1.2.1]
12
Nicholas Brian Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.1.2.2]
11
Keith Allison Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.1.3]
11
Mark Winston Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.1.4]
11
Janice Maureen Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.1.5]
10
Ernest Delmont Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.2]
b. 11 Nov 1934 d. 28 Oct 2017
Jean Hamilton
11
Rhonda Lynn Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.2.1]
11
Edward Delmont Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.2.2]
11
Larry Bruce Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.2.3]
11
Carl Raymond Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.2.4]
11
Gayle Lorraine Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.2.5]
10
Dorothy Virginia Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.3]
Donald Greene
11
Kimberley Jayne Greene
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.3.1]
11
Rodney Stewart Greene
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.3.2]
11
Sandra Dawn Greene
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.3.3]
11
Darrell Leigh Greene
[1.1.1.2.3.1.3.1.1.3.4]
8
Walter W. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2]
b. 28 Sep 1873 d. 20 Jun 1905
Emma S. Underhill
b. Mar 1876 d. Abt 1950
9
Verna May Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.1]
b. 19 Feb 1896 d. 7 Jun 1913
9
Walter Leigh Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.2]
b. 22 Jun 1898 d. 22 Jun 1971
Helen Teresa Cuiheen
b. 8 Aug 1898 d. Abt 1973
10
Helen Marie Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.1]
b. 31 Mar 1924
+
John Depesa
10
Kathleen Esther Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.2]
b. 13 Oct 1926
Edward J. Murphy
11
Kathleen Margaret Murphy
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.2.1]
11
Patricia Ellen Murphy
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.2.2]
11
Robert Edmund Murphy
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.2.3]
11
Edward Joseph Murphy
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.2.4]
11
John Francis Murphy
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.2.5]
10
Walter Robert Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.3]
b. 15 Nov 1930 d. 16 Sep 1952
Maxine Newhall
d. Apr 1971
11
Sharon Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.3.1]
11
Maureen Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.3.2]
b. 6 May 1950 d. Jun 1973
11
Roberta Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.2.3.3]
9
Helen Wallace Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.3]
b. 4 Aug 1901
+
Ward L. Gilmore
9
Ruth A. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.2.4]
b. Abt 1903
8
Laura (Annie) Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.3]
b. 15 Jul 1874 d. 16 Feb 1934
Miles Henry Rideout
b. 22 Sep 1869 d. 1937
9
Walter Arnold Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.1]
b. 29 Mar 1897 d. 27 Sep 1952
Evelyn May Rideout
b. 22 Sep 1897
10
Kathleen Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.1.1]
b. 28 Nov 1918
Clayton Spencer
11
Darrell Arnold Spencer
[1.1.1.2.3.1.3.3.1.1.1]
+
Beverly Ann Bowers
11
Dale Allen Spencer
[1.1.1.2.3.1.3.3.1.1.2]
9
Miles Garfield Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.2]
b. 1 Jan 1899 d. 1979
Grace Mabel Shaw
b. 13 Apr 1902
10
Eugene Garfield Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.2.1]
b. 3 May 1923 d. 10 May 1991
+
Laura May Jonasson
b. 27 May 1924 d. 9 Nov 1994
10
Althea Barbara Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.2.2]
b. 8 Feb 1928 d. 28 Feb 2009
+
Donald Ganong
9
Burtt Sipprell Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.3]
b. 18 Apr 1901 d. 3 Jul 1937
Elizabeth McKay
b. 1899 d. 3 Dec 1975
10
Marguerite Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.3.1]
b. 14 Mar 1922
Rev. Harold L. Mitton
11
Ronald Mitton
[1.1.1.2.3.1.3.3.3.1.1]
11
Ruth Christine Mitton
[1.1.1.2.3.1.3.3.3.1.2]
9
Joseph Audrey Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.4]
b. 4 Sep 1903 d. 15 Oct 1972
Ena Electra Britton
b. 13 Nov 1902 d. 6 May 1973
10
Shirley Madelyn Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1]
b. 11 Mar 1924 d. 3 Apr 1999
Ralph Everett Culberson
b. 13 Jun 1924
11
Lloyd Everett Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.1]
Patricia Ann Lee McMaster
12
Matthew Lloyd Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.1.1]
[
=>
]
12
Mark Andrew Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.1.2]
[
=>
]
12
Necia Anne Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.1.3]
[
=>
]
11
Joseph Carl Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.2]
+
Deborah
11
Arnold Bruce Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.3]
+
Wanda Ruth Kimball
Wanda Ruth Kimball
12
Sebrina Ruth Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.3.1]
[
=>
]
12
Bruce Arnold Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.3.2]
[
=>
]
12
Tabitha Dawn Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.3.3]
[
=>
]
12
Jonah Amos Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.3.4]
11
Wayne Garfield Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.4]
Jean Witallmina Hemeon
12
Paula Jean Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.4.1]
12
Daniel Wayne Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.4.2]
12
Timothy Carl Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.4.3]
12
Nicolas Stephen Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.4.4]
12
Dustin Dlythe Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.4.5]
11
Wanda Grace Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.5]
+
Robert Clinton Everett
Robert Clinton Everett
12
Aaron Robert Everett
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.5.1]
12
Charles Benjamin Everett
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.5.2]
12
Starr Hannah Everett
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.5.3]
[
=>
]
11
Peter Malcolm Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.6]
Susan Ruth Knowles
12
Heidi Joy Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.6.1]
12
Cindy Lynn Culberson
[1.1.1.2.3.1.3.3.4.1.6.2]
9
Edna Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.3.5]
b. 1902
8
Martha (Mattie) Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.4]
b. 5 Jun 1876 d. 7 Mar 1897
8
Clara Belle Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.5]
b. 25 Apr 1878 d. 15 Feb 1958
Scott Rideout
b. 1875 d. 1 Nov 1911
9
Martha Evelyn Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.1]
b. 6 Feb 1899
George Adams Grant
10
Creighton Grant
[1.1.1.2.3.1.3.5.1.1]
b. 12 Dec 1925
Louise Nickerson
11
Judy Louise Grant
[1.1.1.2.3.1.3.5.1.1.1]
11
Carolyn Shirley Grant
[1.1.1.2.3.1.3.5.1.1.2]
R. Tracy
12
Michael Allen Tracy
[1.1.1.2.3.1.3.5.1.1.2.1]
11
Richard Creighton Grant
[1.1.1.2.3.1.3.5.1.1.3]
11
Stephen George Grant
[1.1.1.2.3.1.3.5.1.1.4]
9
George Samuel Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.2]
b. 7 Feb 1901 d. 10 Oct 1966
Velma Evelyn McCallum
b. 21 Aug 1900 d. 23 Nov 1961
10
Enid Alfreda Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.2.1]
b. 16 Jan 1925 d. 27 Aug 2014
Hollis Dickinson
11
Larry Hollis Dickinson
[1.1.1.2.3.1.3.5.2.1.1]
+
Vanessa Farrell
11
Randy Trent Dickinson
[1.1.1.2.3.1.3.5.2.1.2]
+
Myra Martha Shaw
b. 12 Sep 1907 d. 12 Jan 1965
9
Clayton Lewis Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3]
b. 23 Aug 1903 d. Jul 1974
Vera Gertrude Brooks
b. 23 Aug 1904 d. 10 Nov 1968
10
Reid Clayton Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3.1]
11
Randy Lewis Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3.1.1]
11
Linda Ann Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3.1.2]
11
Pamela Ferne Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3.1.3]
11
Heather Brooks Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3.1.4]
10
Paul Brooks Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3.2]
11
David Brooks Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3.2.1]
11
Lori Ann Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3.2.2]
11
Mark Clayton Rideout
[1.1.1.2.3.1.3.5.3.2.3]
+
Warren Rideout
b. 27 Jun 1859 d. 27 Jun 1924
8
Laura Sipprell, I
[1.1.1.2.3.1.3.6]
b. 20 Oct 1863 d. 1864
8
Murray Sipprell
[1.1.1.2.3.1.3.7]
b. 9 Jun 1867 d. 1868
+
Mary Elizabeth Moore
b. 1842 d. 17 Nov 1923
7
Abner Mesereau Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4]
b. 31 Mar 1839 d. 11 Jul 1916
Ruth Ann Ackerson
b. 13 Oct 1844 d. 5 Jan 1929
8
Lillian U. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.1]
b. 17 Nov 1867 d. 19 Oct 1889
8
Scott Talmadge Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.4.2]
b. 7 Dec 1874 d. 22 Jun 1946
Elizabeth Jane (Lizzie) Oliver
b. 9 Nov 1877 d. 25 Mar 1944
9
Elsa Maud Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.1]
b. 26 Nov 1898 d. 31 Oct 1982
Kenneth Webster Keith
b. 2 Oct 1898 d. 25 Jan 1970
10
Dorothy Emma Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.1]
b. 8 Apr 1921
James MacLeod
11
Ann Lorraine MacLeod
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.1.1]
+
Blair Kennedy
11
Shirley Elsalyn MacLeod
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.1.2]
+
Richard Dickinson
11
Doris Elizabeth MacLeod
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.1.3]
11
James Keith MacLeod
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.1.4]
10
Donald Sipprelle Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2]
b. 21 Aug 1928
Dorothy Pond
b. 13 Nov 1927
11
Donald Harrison Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2.1]
Janice Burger
12
Donald Kennedy Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2.1.1]
11
Judy Marie Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2.2]
+
David Loukes
11
Patsy Marlene Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2.3]
Malcolm MacFarlane
12
Kelly Jean MacFarlane
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2.3.1]
11
Karl Gregory Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2.4]
+
Jane Dorcas
11
Peter Guy Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2.5]
11
Elsa Anne Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2.6]
11
Kenneth Webster Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.2.7]
10
Kenneth Webster Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.3]
b. 3 Feb 1930
Louise Stiles
b. 23 Sep 1933
11
Cynthia Louise Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.3.1]
11
Kathryn Wendy Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.3.2]
11
Susan Elizabeth Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.3.3]
11
Kimberly Ann Keith
[1.1.1.2.3.1.4.2.1.3.4]
9
Ruth Amanda Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.2]
b. 18 May 1900 d. 5 Jan 1981
Thompson Eade
b. Abt 1895 d. Abt 1970
10
Joyce Elizabeth Eade
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.1]
b. 2 Oct 1920 d. 29 Sep 2003
Kenneth Coates
b. 31 Dec 1915 d. 31 May 2004
11
Kenneth Coates
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.1.1]
11
Constance Coates
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.1.2]
10
Vivian Ruth Eade
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.2]
b. 16 Jun 1929
Ralph Voltz
11
Sallie Ann Voltz
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.2.1]
11
Ralph Timothy Voltz
[1.1.1.2.3.1.4.2.2.2.2]
9
James Hamilton Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.4.2.3]
b. 27 Feb 1902 d. 12 Aug 1949
Mary Adelene Louise Allen
b. 17 Oct 1906 d. 6 Feb 1991
10
James Hamilton Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.1]
b. 18 Jan 1929 d. 8 Jul 2014
Bessie May Burgess
b. 22 Nov 1930 d. 6 Oct 2005
11
Susanne Louise Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.1.1]
11
Cynthia Lynn Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.1.2]
Joy Vance
11
Julietta Adelyn Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.1.3]
11
James Hamilton Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.1.4]
10
Betty Annetta Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.2]
b. 15 Oct 1930
Norman Wyatt Doane
b. 10 Jun 1923 d. 11 May 2009
11
Louise Annetta Doane
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.2.1]
11
Sharon Lee Doane
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.2.2]
+
Herbert Johnston Butler
b. 10 Sep 1954 d. 20 Feb 2009
11
James Wyatt Doane
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.2.3]
11
Richard Eric Doane
[1.1.1.2.3.1.4.2.3.2.4]
9
Ezekiel Foster Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.4.2.4]
b. 24 Jan 1904 d. 1 Mar 1985
Dolores Lee Dudley
10
Dudley Gene Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.4.1]
Linda Dekun Mills
b. 1935
11
Dwight Dudley Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.4.1.1]
11
Keith Andrew Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.4.1.2]
11
Scott Mills Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.4.1.3]
11
Mark Sheldon Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.4.1.4]
9
Wendell Scott Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.4.2.5]
b. 31 Mar 1909 d. 15 Mar 1976
Irene M. Elliott
b. Jul 1916 d. 30 Jun 1998
10
Richard Eugene Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.1]
Ramalia Lopes
11
Lurene Lynn Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.1.1]
+
Larry Espinoza
11
Sonia Lynn Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.1.2]
10
Doris Arlene Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.2]
Robert J. Doyle
11
Pamela Jean Doyle
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.2.1]
11
Susan Ann Doyle
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.2.2]
11
Robert James Doyle
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.2.3]
11
James Patrick Doyle
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.2.4]
10
Philip Reed Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.3]
b. 7 Mar 1942 d. 22 Jan 2000
Donna Joan Bailey
11
Terrill Ann Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.3.1]
b. 11 Sep 1961 d. 31 Oct 2002
11
Mark Phillip Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.3.2]
+
Carol S. Kirros
10
Norma Jean Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.4]
Henry David Schorr
11
Daniel Allen Schorr
[1.1.1.2.3.1.4.2.5.4.1]
8
Guy Carleton Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.3]
b. 2 Aug 1883 d. 18 Dec 1976
Ethel E Black
b. 6 Mar 1890 d. 28 Apr 1979
9
Walter William Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.3.1]
b. 5 Aug 1913 d. 30 Jan 1979
+
Viola Violet Rinell
b. 1910 d. 1968
9
Winnifred Ann Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.3.2]
b. 3 May 1915 d. 12 Mar 2013
Vern Whitmarsh
10
Deborah K. Whitmarsh
[1.1.1.2.3.1.4.3.2.1]
9
Merle Lester Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.3.3]
b. 13 Sep 1924 d. 16 Dec 1984
+
Mary Edna McLeod
b. 10 Jul 1922
8
Rev. Halden Abner Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.4]
b. 2 Jan 1886 d. 22 Dec 1955
Edith Belyea
b. 6 Jan 1888
9
Muriel Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.4.1]
b. Abt 1917
9
Lorne Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.4.2]
9
Robert Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.4.3]
8
Charles R. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.5]
b. 2 Jan 1870 d. 10 Apr 1873
8
Martha Pearl Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.6]
b. 13 Feb 1872 d. 3 Apr 1873
8
Leslie Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.7]
b. 31 Jul 1878 d. 11 Jun 1883
8
Roy Wendell Sipprell
[1.1.1.2.3.1.4.8]
b. 10 Aug 1880 d. 19 Jun 1883
7
Nathaniel Shaw Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5]
b. 14 Jun 1841 d. 18 Oct 1909
Lavinia A Gray
b. 1844 d. 18 Apr 1894
8
Nathaniel Perry Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.5.1]
b. 11 Jul 1871 d. 1943
+
Hildur C. Johnson
b. Abt 1898 d. Jan 1943
+
Florence S. Powell
b. Abt 1885 d. Aft Dec 1956
8
Ezekiel McLeod Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.2]
b. 23 Feb 1875 d. 15 Sep 1954
Velmont E. Soule
b. Abt 1885 d. 29 Apr 1967
9
Nathaniel Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.2.1]
b. Abt 1902 d. Abt 1904
9
Glendon O. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.2.2]
b. Abt 1905 d. Abt 1908
9
Carl Nathaniel Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.2.3]
b. 16 May 1918 d. 3 Aug 2004
Marian Anderson
10
Robert Carl Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.2.3.1]
b. 25 May 1948 d. 1 Jan 2005
+
Patricia A Sacker
Ms Shadish
11
Cara Ann Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.2.3.1.1]
10
Diane M. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.2.3.2]
9
Geraldine M. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.2.4]
b. 24 Mar 1922 d. 29 Aug 1992
Gerald Tine
10
David Tine
[1.1.1.2.3.1.5.2.4.1]
10
Martha Tine
[1.1.1.2.3.1.5.2.4.2]
10
Elizabeth Tine
[1.1.1.2.3.1.5.2.4.3]
10
Rebecca Tine
[1.1.1.2.3.1.5.2.4.4]
8
Nathalia L. (Queenie) Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.3]
b. 1878
+
Leo L. Babins
+
Luther A Stearns
8
Josephine P Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.5.4]
b. 7 Jan 1886 d. Aug 1963
8
Francis E. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.5]
b. 1866 d. Abt 1887
8
Percy Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.6]
b. 1867 d. Bef 1870
8
Edward Sipprell
[1.1.1.2.3.1.5.7]
b. 1869 d. Bef 1880
+
Bertha C. Kearney
b. Mar 1865
7
John Colby Sipprell
[1.1.1.2.3.1.6]
b. 3 Aug 1843 d. 28 Sep 1851
7
Mary Ann Sipprell
[1.1.1.2.3.1.7]
b. 17 Nov 1845 d. 1 Dec 1847
7
Ezekiel Mallory Siprell
[1.1.1.2.3.1.8]
b. 7 Jul 1847 d. 25 Oct 1922
Annie Gertrude Fritz
b. 13 Jan 1860 d. 14 Feb 1942
8
Winnifred May Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.1]
b. 13 Apr 1898 d. 9 Feb 1899
8
Harold Fritz Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.2]
b. 4 Apr 1900 d. 11 Dec 1976
Mary Logan
b. 16 Feb 1846 d. 19 Dec 1895
8
Garfield James Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3]
b. 15 Oct 1881 d. 23 Dec 1963
Louise Todd Churchill
b. Abt 1880
9
Roy Logan Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.1]
b. 7 Jul 1908 d. 25 May 1966
Cecile Francis (Nancy) Powell
10
John Garfield Logan Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.1.1]
Patricia Sheen
11
Justine Legh Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.1.1.1]
+
Adrian K Bowker
10
Robert Roy Legh Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.1.2]
Lilianne
11
Legh Anthony Powell Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.1.2.1]
10
Edward Harold Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.1.3]
10
Alfred Cecil Churchill Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.1.4]
10
Mary Susan Irene Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.1.5]
10
George Anthony Richard Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.1.6]
9
Robert Dickinson Todd Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.2]
b. 3 Aug 1910 d. Jun 1957
Morma Dickie
10
Marilyn Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.2.1]
Dr. John Brebner
11
Carol Brebner
[1.1.1.2.3.1.8.3.2.1.1]
11
James John Brebner
[1.1.1.2.3.1.8.3.2.1.2]
10
James Dickie Churchill Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.2.2]
b. 10 Feb 1941 d. 9 May 1961
10
William Todd Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.3.2.3]
8
Roy Logan Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.4]
b. 13 Jan 1884 d. 6 Dec 1925
Grace Keans Hayward
b. 5 Apr 1885 d. 14 Oct 1973
9
Harvey Hayward Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.4.1]
b. 6 Jun 1921 d. 30 Jun 1934
9
Doris Hayward Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.4.2]
b. 5 Mar 1916
G. Stewart Sheraton
10
Linda Sheraton
[1.1.1.2.3.1.8.4.2.1]
10
Barbara Sheraton
[1.1.1.2.3.1.8.4.2.2]
9
John Mallory Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.4.3]
b. 9 May 1918
+
Madeleine Got
8
Euphema (Effie) Mary Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.5]
b. 20 Mar 1886 d. 20 Oct 1918
Stanley Edmund Fisher
9
Kenneth Clarke Fisher
[1.1.1.2.3.1.8.5.1]
b. 5 Nov 1911 d. 22 Jan 1970
Jeanne Manery
10
Kenneth Robert Stanley Fisher
[1.1.1.2.3.1.8.5.1.1]
+
Dorothy Denyer
10
Marjorie Manery Fisher
[1.1.1.2.3.1.8.5.1.2]
+
Ian Fraser
9
Charlotte Logan Fisher
[1.1.1.2.3.1.8.5.2]
b. 28 Mar 1915
Milledge Hicks
10
Judith Louise Hicks
[1.1.1.2.3.1.8.5.2.1]
+
Peter Chalmers Smith
10
Mary Ellen Hicks
[1.1.1.2.3.1.8.5.2.2]
8
Olive (Ollie) Letitia Sipprell
[1.1.1.2.3.1.8.6]
b. 31 Dec 1888 d. 30 Jul 1968
+
Arnold MacNee
7
Ruth Ann Sipprell
[1.1.1.2.3.1.9]
b. 30 Mar 1850 d. 3 Jul 1931
+
Edwin Carpenter
b. 11 Sep 1832 d. 28 Apr 1905
7
Phoebe Jane (Jennie) Sipprell
[1.1.1.2.3.1.10]
b. 28 Nov 1852 d. 25 Apr 1930
Josiah Warren Smith
b. 22 Aug 1837 d. 7 Sep 1890
8
Martha (Mattie) Augusta Smith
[1.1.1.2.3.1.10.1]
b. 20 Aug 1878 d. 19 Nov 1971
+
Eugene Oliver Grant
+
Thomas L. Stetson
7
Letita Adelaide Sipprell
[1.1.1.2.3.1.11]
b. 8 Apr 1855 d. 19 May 1875
+
George A. Estabrooks
b. 26 Jul 1850 d. 1926
7
William Henry Sipprell
[1.1.1.2.3.1.12]
b. 24 Oct 1857 d. 12 Dec 1933
Ruth Ann Williams
b. Aug 1861 d. 4 May 1883
8
John Henry Sipprell
[1.1.1.2.3.1.12.1]
b. 15 Apr 1883 d. 29 Apr 1883
Edith Eliza Moore
b. 22 Nov 1863 d. 15 May 1899
8
Edna Moore Sipprell
[1.1.1.2.3.1.12.2]
b. 28 Mar 1885 d. 18 Dec 1955
+
Havelock Churchill
d. 13 Mar 1948
8
Bertha Leonra (Bertie) Sipprell
[1.1.1.2.3.1.12.3]
b. 8 May 1887 d. 12 Dec 1918
+
Herber Harold Hatfield
b. 17 Apr 1885 d. 3 Jan 1952
8
Harold C. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.12.4]
b. 1889 d. 1889
8
Frederick William Sipprell
[1.1.1.2.3.1.12.5]
b. May 1891 d. Sep 1891
8
Robert Henry Sipprell
[1.1.1.2.3.1.12.6]
b. May 1891 d. Sep 1891
8
Arthur Reginald Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.12.7]
b. 7 May 1894 d. 20 Oct 1964
Ella Pearl Miller
b. 12 Jul 1886 d. Abt 1966
9
William Henry Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.12.7.1]
b. 24 Feb 1918
Evelyn Marie Magnuson
b. 14 Sep 1917 d. Abt Dec 1973
10
Gary William Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.12.7.1.1]
+
Valarie Jean Millen
10
Guy Carl Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.12.7.1.2]
b. 4 Jun 1947 d. 8 Apr 2005
Jean Candy Barrington
11
Kristin Anne Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.12.7.1.2.1]
11
Sarah L. Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.12.7.1.2.2]
+
Gladys E. Kenney
8
Robina P. Sipprelle
[1.1.1.2.3.1.12.8]
b. 29 Aug 1898 d. 27 Jan 1987
+
Jennie E. Estey
b. 10 Nov 1857 d. 16 Mar 1911
+
Annie Irene Williams
b. 25 Jan 1870 d. 7 May 1915
7
Nehemiah James Sipprell
[1.1.1.2.3.1.13]
b. 23 May 1860 d. 20 Apr 1942
7
James N. Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14]
b. 23 May 1860 d. 20 Apr 1942
Mildred Jane Smith
b. May 1856 d. 30 Jan 1922
8
James Ernest Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1]
b. 26 Sep 1888 d. 8 Nov 1958
Palma R. Lee
b. 27 Jul 1890 d. 22 Jun 1966
9
James Ernest Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1.1]
b. 27 May 1915 d. 13 Apr 2000
+
Helen Caroline Bender
b. 1917 d. 16 Feb 1953
Sally Roberts
10
James Ernest Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1.1.1]
Erin
11
Emily Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1.1.1.1]
11
Natalie Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1.1.1.2]
10
Lisa Simone Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1.1.2]
Phillip Lasconia
11
Bronson Lasconia
[1.1.1.2.3.1.14.1.1.2.1]
11
Blake Lasconia
[1.1.1.2.3.1.14.1.1.2.2]
9
Arthur Edwin Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1.2]
b. 27 May 1915 d. 31 Oct 1996
Elizabeth Falconer Swanson
b. 3 Apr 1914 d. 4 Feb 1968
10
Elizabeth Ann Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1.2.1]
Donald Healy
11
Teresa Healy
[1.1.1.2.3.1.14.1.2.1.1]
Curt Halderson
12
Jessica Halderson
[1.1.1.2.3.1.14.1.2.1.1.1]
12
Lauren Halderson
[1.1.1.2.3.1.14.1.2.1.1.2]
11
Alissa Healy
[1.1.1.2.3.1.14.1.2.1.2]
10
Barbara Lee Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1.2.2]
Michael A. Washo
11
Benjamin M. Washo
[1.1.1.2.3.1.14.1.2.2.1]
Heidi
12
Cassidy Rose Washo
[1.1.1.2.3.1.14.1.2.2.1.1]
11
Bernard A. Washo
[1.1.1.2.3.1.14.1.2.2.2]
+
Lindsay
+
Millie Close
d. Abt 1980
+
Clara Josephine Galbraith
b. 30 Aug 1922 d. 27 Sep 2006
9
Jean Letitia Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.1.3]
b. 23 Feb 1920
Fred M. Quistorff
10
James Arthur Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.1]
Doris Larsen
11
James Arthur Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.1.1]
11
Patricia Jean Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.1.2]
11
Stephanie Ruth Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.1.3]
11
Sarah Ann Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.1.4]
11
Michelle Lee Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.1.5]
Ana Rasmussen
11
Daniel Lawrence Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.1.6]
Gayle
11
Cassidy Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.1.7]
11
Gabriel Michael Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.1.8]
10
Carla Jean Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.2]
Gary Richard Pfaff
11
Steven Michael Pfaff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.2.1]
Diane
12
Brooke Peidan Pfaff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.2.1.1]
11
Douglas James Pfaff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.2.2]
Deb
12
Alexander James Pfaff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.2.2.1]
12
Emma Louise Pfaff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.2.2.2]
11
Lara Lee Pfaff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.2.3]
Mr Morrison
12
Cassandra (Cassie) Morrison
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.2.3.1]
10
Lawrence F. Quistorff
[1.1.1.2.3.1.14.1.3.3]
b. 9 Feb 1947 d. Bef 2008
8
Ruby Mildred Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.2]
b. 3 Jan 1892 d. Abt 1976
+
George F. Mann
b. Abt 1887 d. Abt 1962
8
Ada Ruth Sipprell
[1.1.1.2.3.1.14.3]
b. 23 Oct 1894 d. 4 May 1964
George T. Knieriem
b. Abt 1893 d. Aug 1971
9
George Sipprell Knieriem
[1.1.1.2.3.1.14.3.1]
7
Sarah Ada Sipprell
[1.1.1.2.3.1.15]
b. 19 Oct 1863 d. 18 Jan 1926
George A. Estabrooks
b. 26 Jul 1850 d. 1926
8
Inez Maud Estabrooks
[1.1.1.2.3.1.15.1]
b. 7 Apr 1884 d. 15 Feb 1975
Ralph Jay Merrill
b. 8 Jul 1882 d. 22 Jan 1953
9
Roger Ellery Merrill
[1.1.1.2.3.1.15.1.1]
b. 19 Jun 1908 d. Jul 1976
9
Albert Ralph Merrill
[1.1.1.2.3.1.15.1.2]
b. 16 Aug 1909 d. 20 Sep 1981
+
Irene Alla Bileu
b. 29 Nov 1912 d. Oct 1993
+
Louise Jorgenson
b. 1911
+
Helen Pyle
b. 2 Nov 1911 d. 1963
9
Pauline Inez Merrill
[1.1.1.2.3.1.15.1.3]
b. 19 May 1911 d. Abt 2002
9
Ralph Jay Merrill
[1.1.1.2.3.1.15.1.4]
b. 19 Sep 1913 d. 10 May 1943
9
Helen Irene Merrill
[1.1.1.2.3.1.15.1.5]
b. 3 Apr 1916
+
Jack Achenbach
b. Abt 1901
9
Gertrude R. Merrill
[1.1.1.2.3.1.15.1.6]
b. 11 Oct 1919 d. 12 Jun 1967
+
William Travis Holley
b. 3 Feb 1913 d. 25 Sep 1983
8
James E. Estabrooks
[1.1.1.2.3.1.15.2]
b. 1888
8
Ruth Estabrooks
[1.1.1.2.3.1.15.3]
b. 1886
8
Frank E. Estabrooks
[1.1.1.2.3.1.15.4]
b. 1889 d. Bef 1974
+
George P. Sproule
b. 14 Sep 1863 d. 21 Jan 1945
7
Jane Siprell
[1.1.1.2.3.1.16]
+
Ann Snow
b. 9 Aug 1782 d. 6 Sep 1864
4
Elijah Shaw
[1.1.1.3]
b. 1771 d. 1841
4
Nathaniel Shaw
[1.1.1.4]
b. 1794 d. 24 Jul 1847
Phoebe Ackerson
b. Abt 1798 d. 14 Sep 1872
5
Letitia Shaw
[1.1.1.4.1]
b. 16 Jul 1816 d. 7 Apr 1902
Rev Ezekiel Siprell
b. 10 Aug 1799 d. 9 Apr 1895
6
Martha Sipprell
[1.1.1.4.1.1]
b. 20 Aug 1835 d. 13 Apr 1901
John Henderson
b. 30 May 1830 d. Abt 1904
7
John Colby Henderson
[1.1.1.4.1.1.1]
b. 17 Mar 1856 d. 13 Dec 1936
Amanda Jane Orser
b. 27 May 1854 d. 25 Mar 1925
8
George Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.1]
8
Alice Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.2]
8
Frank Arnold Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.3]
b. 29 Sep 1881 d. 3 Dec 1960
Cora Ferne Henderson
b. Mar 1886 d. 26 Jan 1912
9
Anna Ferne Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.3.1]
b. 12 Apr 1907 d. Abt 1982
Robert Lawrence
b. Abt 1899 d. Abt 1974
10
June Lawrence
[1.1.1.4.1.1.1.3.1.1]
b. 25 Jun 1928
Richard Keene
11
Wendy Keene
[1.1.1.4.1.1.1.3.1.1.1]
11
Larry Keene
[1.1.1.4.1.1.1.3.1.1.2]
10
Lloyd Lawrence
[1.1.1.4.1.1.1.3.1.2]
+
Wendy Jackman
9
Eunice Matilda Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.3.2]
b. 17 Jan 1909 d. Abt 1985
Robert Thompson
d. Abt 1977
10
Roberta Thompson
[1.1.1.4.1.1.1.3.2.1]
b. 4 Dec 1928
10
Glenn Thompson
[1.1.1.4.1.1.1.3.2.2]
Jean Nelson
11
Steven Thompson
[1.1.1.4.1.1.1.3.2.2.1]
11
Keith Thompson
[1.1.1.4.1.1.1.3.2.2.2]
11
Kenneth Thompson
[1.1.1.4.1.1.1.3.2.2.3]
9
Robert Leroy Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.3.3]
b. 2 Dec 1911
Phyliss Mayson
10
Robert Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.3.3.1]
8
John Crowell Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.4]
b. 6 Dec 1886 d. 28 Sep 1918
8
Roy Sipprell Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.5]
b. 1888 d. 12 May 1898
8
Russell Max Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.6]
b. 8 Feb 1890 d. 12 May 1898
8
Anna Evelyn Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.7]
b. 3 Sep 1894 d. 1902
8
Barbara Bessie Henderson
[1.1.1.4.1.1.1.8]
b. 27 Jun 1900 d. Abt 1975
William James Prendergast
b. Abt 1896 d. 1943
9
Agnes Dorothy Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.1]
b. 9 Jan 1922
Perry Summerfield
10
Sandra Joy Summerfield
[1.1.1.4.1.1.1.8.1.1]
Albert K. (Arne) Johnson
11
Dean Albert Johnson
[1.1.1.4.1.1.1.8.1.1.1]
11
Lisa Ann Johnson
[1.1.1.4.1.1.1.8.1.1.2]
10
Leslie William Summerfield Uhrich
[1.1.1.4.1.1.1.8.1.2]
Lorraine Rubenson
11
Julie Ann Uhrich
[1.1.1.4.1.1.1.8.1.2.1]
11
Leslie Uhrich
[1.1.1.4.1.1.1.8.1.2.2]
Richard J. Uhrich
10
Anna Marie Uhrich
[1.1.1.4.1.1.1.8.1.3]
+
Alan Framke
10
Richard J. Uhrich
[1.1.1.4.1.1.1.8.1.4]
9
Billy Russell Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.2]
b. 18 Jul 1923 d. 16 Feb 1956
Emma Mae Curtice
10
Billy Russell Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.2.1]
+
Linda Tchy
10
Barbara Rae Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.2.2]
10
Beverly Roberta Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.2.3]
+
Carl Gustav Eggehorn
9
Gilbert Donald Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.3]
b. 25 Sep 1925
Dauna Walker
10
James Michael Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.3.1]
b. 17 Aug 1951 d. 2 Jun 1967
10
Donald Lee Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.3.2]
10
Judith Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.3.3]
10
Catherine Iola Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.3.4]
10
Daniel Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.3.5]
b. 5 May 1956 d. 14 Feb 1968
10
Cynthia Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.3.6]
10
Lynn Juanita Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.3.7]
10
Frank Wayne Prendergast
[1.1.1.4.1.1.1.8.3.8]
+
Ruth Hurlburt
7
Annie Eliza Henderson
[1.1.1.4.1.1.2]
b. 8 Jan 1857 d. 1949
Edward S. Gilmor
8
Kathleen Gilmor
[1.1.1.4.1.1.2.1]
b. 1892
Willis E. Kitchen
9
Pauline Kitchen
[1.1.1.4.1.1.2.1.1]
b. 1919
+
E. J. Powell
9
Wesley Kitchen
[1.1.1.4.1.1.2.1.2]
b. 1924
Joyce East
10
Michael Kitchen
[1.1.1.4.1.1.2.1.2.1]
9
Kathleen Donna Kitchen
[1.1.1.4.1.1.2.1.3]
8
Luella Grace Gilmor
[1.1.1.4.1.1.2.2]
b. 1890
7
Permelia (Prim) Henderson
[1.1.1.4.1.1.3]
b. Abt 1863 d. 4 Jan 1955
David M. Robinson
b. Abt 1858 d. Abt 1910
8
Clair Willard Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1]
b. 25 Apr 1883 d. 18 Jun 1960
Helen Bancroft
b. 23 Feb 1889
9
Eleanor L. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.1]
b. 9 Jul 1916
9
Willard B. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.2]
b. 19 Apr 1918
Alice Alsen
10
David B. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.2.1]
10
Robin Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.2.2]
10
Paul Alden Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.2.3]
10
Claire Louise Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.2.4]
10
W. Scott Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.2.5]
9
David B. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.3]
b. 4 Feb 1924
Louise Neff
10
Margaret Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.3.1]
10
Claire B. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.3.2]
10
D. Dana Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.3.3]
10
Deborah Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.3.4]
10
Eleanor C. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.3.5]
9
Claire F. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.1.4]
b. 18 Mar 1927
G. F. Earnshaw
10
Dale S. Earnshaw
[1.1.1.4.1.1.3.1.4.1]
10
Joyce Earnshaw
[1.1.1.4.1.1.3.1.4.2]
10
Helen Grace Earnshaw
[1.1.1.4.1.1.3.1.4.3]
10
Joan E. Earnshaw
[1.1.1.4.1.1.3.1.4.4]
8
Edith A. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.2]
b. 9 Sep 1884 d. 31 Jan 1952
+
Lester Leonard
8
Adelaide Letitia Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.3]
b. 25 Mar 1886 d. Aft 1974
+
Alton W. Jackson
d. Abt 1995
8
Della M. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.4]
b. 11 Jul 1887 d. 5 Jul 1958
A. E. Merrill
9
Eloise B. Merrill
[1.1.1.4.1.1.3.4.1]
b. 29 Oct 1907 d. Abt 1982
George Eldredge
b. Abt 1901 d. Abt 1976
10
Merrill H. Eldredge
[1.1.1.4.1.1.3.4.1.1]
b. 27 May 1927
Doris Crump
11
Donna L. Eldredge
[1.1.1.4.1.1.3.4.1.1.1]
11
Carol J. Eldredge
[1.1.1.4.1.1.3.4.1.1.2]
11
Garry A. Eldredge
[1.1.1.4.1.1.3.4.1.1.3]
11
Larry Eldredge
[1.1.1.4.1.1.3.4.1.1.4]
+
Carroll L. Floyd
9
Thelma A. Merrill
[1.1.1.4.1.1.3.4.2]
b. 14 Jun 1912
+
John H. Morse
+
A. E. Wall
A. E. Wall
9
Barbara H. Wall
[1.1.1.4.1.1.3.4.3]
b. 15 Oct 1920
Howard C. Peterson
10
Judith Peterson
[1.1.1.4.1.1.3.4.3.1]
10
Lane V. Peterson
[1.1.1.4.1.1.3.4.3.2]
8
Albert Wallace Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5]
b. 10 Jan 1891 d. 22 Nov 1963
Clara Cecelia Pheasant
9
Fred Llewellyn Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.1]
b. 11 Jul 1913
Ruby Mason
10
Clair Lorne Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.1.1]
10
Roger Lynn Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.1.2]
10
Frederica Ann Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.1.3]
10
David Albert Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.1.4]
Kathleen Keenan
10
Anna Marie Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.1.5]
10
Frederick Albert Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.1.6]
10
William Pheasant Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.1.7]
10
Heather Jane Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.1.8]
9
Mildred Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.2]
b. 27 Feb 1915
J. D. Atkinson
10
Clara Jean Atkinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.2.1]
10
Mary Lynn Atkinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.2.2]
9
Marjorie Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.5.3]
b. 15 Dec 1916
Douglas Moore
10
Albert Robinson Moore
[1.1.1.4.1.1.3.5.3.1]
10
Della Mae Moore
[1.1.1.4.1.1.3.5.3.2]
8
Bessie G. Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.6]
b. 19 Oct 1892 d. 21 May 1951
Chester E. Roach
9
Claire A. Roach
[1.1.1.4.1.1.3.6.1]
b. 12 May 1911
Clinton F. Dunbar
10
Lynne Dunbar
[1.1.1.4.1.1.3.6.1.1]
+
David Blake
9
Alton C. Roach
[1.1.1.4.1.1.3.6.2]
b. 5 Jul 1913
+
Marion Flynn
8
Robert Colby Robinson
[1.1.1.4.1.1.3.7]
b. 3 Nov 1894 d. Abt 1969
+
Anna Constance Tiedeman
+
Irma Blanche Walter
+
Fred O'Donnell
7
Elspeth (Eppie) Cameron Henderson
[1.1.1.4.1.1.4]
b. 9 Jun 1869 d. 2 Jan 1919
Wilmot Wilson Robinson
b. 25 Aug 1860 d. 15 Sep 1940
8
Idella Rae Robinson
[1.1.1.4.1.1.4.1]
b. 19 Nov 1887 d. 24 Mar 1958
Cecil Fitzsimmons
9
Helen Fitzsimmons
[1.1.1.4.1.1.4.1.1]
b. 1912 d. 30 Oct 1973
+
Alexander F. Hector
b. Abt 1909 d. Abt 1984
8
Ruby Irma Robinson
[1.1.1.4.1.1.4.2]
b. 4 Feb 1891 d. 1985
Joseph Gans
b. 20 Jun 1882
9
Kathleen Gans
[1.1.1.4.1.1.4.2.1]
Dr. W. A. Hargan
10
Kathleen Hargan
[1.1.1.4.1.1.4.2.1.1]
10
Patricia Hargan
[1.1.1.4.1.1.4.2.1.2]
8
Muriel Pearl Robinson
[1.1.1.4.1.1.4.3]
b. 21 Apr 1895 d. 13 Sep 1964
Leroy Milton London
b. 9 May 1896 d. 10 Dec 1964
9
Glenna Elspeth London
[1.1.1.4.1.1.4.3.1]
b. 29 Sep 1918 d. 23 Apr 2007
Garnet Thorburn
b. Abt 1911 d. 28 Mar 1986
10
Garnella Vivian Thorburn
[1.1.1.4.1.1.4.3.1.1]
9
Muriel Evelyn London
[1.1.1.4.1.1.4.3.2]
b. 9 Mar 1920 d. Abt 2007
+
Walter Wiiliam Metherell
b. 1917 d. 1943
+
Arnold Ambrose
9
Vivian Josephine London
[1.1.1.4.1.1.4.3.3]
b. 17 Mar 1922 d. 4 Jan 2011
Charles A. McCarthy
b. 7 Jan 1919 d. 22 Oct 1982
10
Patti Ruth McCarthy
[1.1.1.4.1.1.4.3.3.1]
9
Eugene Roland London
[1.1.1.4.1.1.4.3.4]
b. 23 Mar 1925 d. 1 Oct 2010
Faustina Marie Bubar
b. 11 Oct 1921 d. 1949
10
Robert London
[1.1.1.4.1.1.4.3.4.1]
d. Bef 1970
Glenna McCordia
10
Gaylon London
[1.1.1.4.1.1.4.3.4.2]
10
David London
[1.1.1.4.1.1.4.3.4.3]
10
Judith Ann London
[1.1.1.4.1.1.4.3.4.4]
9
Thelma Pearl London
[1.1.1.4.1.1.4.3.5]
b. 11 May 1932
Earle London
10
Janet Irene London
[1.1.1.4.1.1.4.3.5.1]
8
William Robinson
[1.1.1.4.1.1.4.4]
b. 12 May 1900 d. 24 May 1900
8
Ruth Elsie Robinson
[1.1.1.4.1.1.4.5]
b. 26 Oct 1901 d. 1 Oct 1978
7
Adelaide Lillian Henderson
[1.1.1.4.1.1.5]
b. 17 Sep 1861 d. 13 Jan 1941
Crowell Gayton
d. Abt 1943
8
Genevieve Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.1]
b. 22 Sep 1884
Richard Kelsey
9
Marcella Adelaide Kelsey
[1.1.1.4.1.1.5.1.1]
b. 22 Aug 1907
Amner Petty
10
Adelaide Amneris Petty
[1.1.1.4.1.1.5.1.1.1]
Walter Ewing
11
Neal Walton Ewing
[1.1.1.4.1.1.5.1.1.1.1]
11
Carol June Ewing
[1.1.1.4.1.1.5.1.1.1.2]
11
Michele Joan Ewing
[1.1.1.4.1.1.5.1.1.1.3]
11
Kay Kaura Ewing
[1.1.1.4.1.1.5.1.1.1.4]
9
June Elizabeth Kelsey
[1.1.1.4.1.1.5.1.2]
b. 9 Jun 1910
+
Montel Montgomery
9
Claudia Juanita Kelsey
[1.1.1.4.1.1.5.1.3]
b. 8 Aug 1912
8
Claude Victor Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.2]
b. 11 May 1886 d. Dec 1937
Eileen McAlister
9
Terre Joan Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.2.1]
b. 9 Jul 1928
Donald Welch
10
Donald Edward Welch
[1.1.1.4.1.1.5.2.1.1]
10
Bryan Gayton Welch
[1.1.1.4.1.1.5.2.1.2]
10
Maris Christina Welch
[1.1.1.4.1.1.5.2.1.3]
10
Victor Gayton Welch
[1.1.1.4.1.1.5.2.1.4]
10
Stephen Gayton Welch
[1.1.1.4.1.1.5.2.1.5]
10
Kyle Gayton Welch
[1.1.1.4.1.1.5.2.1.6]
10
Tara Gayton Welch
[1.1.1.4.1.1.5.2.1.7]
9
Carlo Bernadette Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.2.2]
b. 8 Mar 1930
Francis Touhey
10
Tereze Maria Touhey
[1.1.1.4.1.1.5.2.2.1]
10
Francis William Touhey
[1.1.1.4.1.1.5.2.2.2]
10
Eileen Frances Touhey
[1.1.1.4.1.1.5.2.2.3]
10
Claudia Gayton Touhey
[1.1.1.4.1.1.5.2.2.4]
10
Anthony McAlister Touhey
[1.1.1.4.1.1.5.2.2.5]
10
James Patrick Touhey
[1.1.1.4.1.1.5.2.2.6]
10
Carl Edward Touhey
[1.1.1.4.1.1.5.2.2.7]
10
Justine Maria Touhey
[1.1.1.4.1.1.5.2.2.8]
10
Carlo Bernadette Touhey
[1.1.1.4.1.1.5.2.2.9]
8
Martha Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.3]
b. 1892
8
John Avard Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.4]
b. 3 May 1893 d. 10 Oct 1968
8
Donald McLeod Vince Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.5]
b. 5 Jan 1898
+
Mary Manchester
Josephine Hilt
9
Donald McLeod Vince Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.5.1]
b. 22 Nov 1919
Dorothy Rollesfon
10
Meredith Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.5.1.1]
10
Donald McLeod Vince Gayton
[1.1.1.4.1.1.5.5.1.2]
7
Geneva Fayette Henderson
[1.1.1.4.1.1.6]
b. 1 Jul 1880 d. 24 Apr 1966
Harry Fenwick Shaw
b. 2 May 1874 d. 12 Mar 1952
8
Juanita Fenwick Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.1]
b. 29 Jun 1898 d. 20 Sep 1988
Stanley Percy Tompkins
b. 16 Oct 1898 d. 27 Oct 1989
9
Phylis Estelle Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.1]
b. 2 Oct 1920
J. Edwin Nordquist
10
Dennis Edwin Nordquist
[1.1.1.4.1.1.6.1.1.1]
9
Davis Vaughn Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.2]
b. 1 Dec 1923
Greta Darling Law
10
Carl Davis Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.2.1]
G. J. Dresser
11
Bryan Douglas Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.2.1.1]
11
Donna Ruth Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.2.1.2]
9
Chester Earl Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.3]
b. 9 May 1933
Gertrude Smith
10
Stanley William Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.3.1]
10
Steven Roger Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.3.2]
10
Juanita May Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.3.3]
10
Wayne Merrill Tompkins
[1.1.1.4.1.1.6.1.3.4]
8
Davis Spurgeon Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.2]
b. 17 Dec 1899 d. Bef 2009
Priscilla Young
9
Harry William Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.2.1]
Sandra Doctor
d. 1 Oct 1965
10
David Anthony Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.2.1.1]
b. 31 Dec 1958 d. 1 Oct 1965
10
Sydney Allison Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.2.1.2]
b. 29 Dec 1960 d. 1 Oct 1965
9
Ethel Marjorie Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.2.2]
Curtis Roderick
10
Gregory Roderick
[1.1.1.4.1.1.6.2.2.1]
10
Peter Roderick
[1.1.1.4.1.1.6.2.2.2]
8
Martha Jane Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.3]
b. 10 Jun 1901 d. 10 Sep 1907
8
Lottie Beatrice Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.4]
b. 25 Jan 1903 d. 6 Aug 1947
Guy Augustus Pratt
b. 17 Feb 1893 d. 30 Dec 1977
9
Cyril Raymond Pratt
[1.1.1.4.1.1.6.4.1]
b. 11 May 1923 d. Bef 2006
Muriel Zwicker
10
Sharon Pratt
[1.1.1.4.1.1.6.4.1.1]
10
Ivan Pratt
[1.1.1.4.1.1.6.4.1.2]
9
Virginia Stewart Pratt
[1.1.1.4.1.1.6.4.2]
b. 17 May 1926 d. 11 Oct 2009
David Redmond Fry
b. 1 Feb 1919 d. 7 Jan 2007
10
Joan Elizabeth Fry
[1.1.1.4.1.1.6.4.2.1]
Steve Both
11
Lynette Both
[1.1.1.4.1.1.6.4.2.1.1]
11
Wayne Both
[1.1.1.4.1.1.6.4.2.1.2]
11
Gary Both
[1.1.1.4.1.1.6.4.2.1.3]
11
Lauralee Both
[1.1.1.4.1.1.6.4.2.1.4]
11
Andrew Both
[1.1.1.4.1.1.6.4.2.1.5]
10
Blair Sherman Fry
[1.1.1.4.1.1.6.4.2.2]
Janice Dimock
11
Justin Fry
[1.1.1.4.1.1.6.4.2.2.1]
11
Lauren Fry
[1.1.1.4.1.1.6.4.2.2.2]
9
Guy Augustus Jr. Pratt
[1.1.1.4.1.1.6.4.3]
b. 9 Jan 1929 d. 9 Oct 2006
Anna Pauline Sharpe
b. 14 Oct 1929 d. 3 Jan 2017
10
Donna Pratt
[1.1.1.4.1.1.6.4.3.1]
10
Clifford Roy Pratt
[1.1.1.4.1.1.6.4.3.2]
b. 15 Aug 1965 d. 22 Dec 2015
8
Virginia Stewart Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.5]
b. 19 Jul 1904 d. Bef 2009
Ivan T. Forsberg
9
Susan Claire Forsberg
[1.1.1.4.1.1.6.5.1]
+
Gerald Radasci
9
Diana J. Forsberg
[1.1.1.4.1.1.6.5.2]
8
Annette Hill Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.6]
b. 13 Jan 1906 d. 30 Jun 1953
Casimo D. Caso
9
Barbara Evelyn Caso
[1.1.1.4.1.1.6.6.1]
b. 23 Aug 1932
Earl Sowell
d. 1970
10
Michael Sowell
[1.1.1.4.1.1.6.6.1.1]
10
Annette Sowell
[1.1.1.4.1.1.6.6.1.2]
10
Darryl Sowell
[1.1.1.4.1.1.6.6.1.3]
9
Priscilla Caso
[1.1.1.4.1.1.6.6.2]
8
Harry Fenton Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.7]
b. 7 Jun 1907 d. Bef 2009
Ethel M. White
9
Roland Willard Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.7.1]
b. 5 Apr 1930
Virginia Sanders
10
Sandra Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.7.1.1]
10
Sally Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.7.1.2]
10
Bruce Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.7.1.3]
10
Brenda Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.7.1.4]
8
Ruby Evelyn Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.8]
b. 15 Mar 1909 d. 12 Mar 1957
8
Mildred Fayette Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.9]
b. 26 Jan 1912 d. 15 Mar 1912
8
Etta Sherrill Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.10]
b. 16 Oct 1913 d. Aft Mar 2009
William J. Reeves
9
Roberta Ann Reeves
[1.1.1.4.1.1.6.10.1]
9
Sherrill Elizabeth Reeves
[1.1.1.4.1.1.6.10.2]
8
Earl Kitchener Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.11]
b. 10 Mar 1915 d. 6 Apr 1938
Ella E. Buckingham
9
Sherrille B. Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.11.1]
b. 31 Oct 1933
Lester Moznik
10
Danny Moznik
[1.1.1.4.1.1.6.11.1.1]
10
Dale Moznik
[1.1.1.4.1.1.6.11.1.2]
10
Jeannette Moznik
[1.1.1.4.1.1.6.11.1.3]
10
Roy Moznik
[1.1.1.4.1.1.6.11.1.4]
8
Geneva Fern Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.12]
b. 8 Dec 1916 d. 13 Nov 1935
8
Willis John Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.13]
b. 26 Jun 1919 d. Bef 2009
Isabel Olive White
9
Valerie Elaine Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.13.1]
9
Elspeth Evelyn Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.13.2]
8
Rowena Eloise Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.14]
b. 9 Dec 1920 d. 17 Mar 2009
Charles MacDonald
d. 16 Feb 2005
9
Rebecca Louise MacDonald
[1.1.1.4.1.1.6.14.1]
Myles MacCallum
10
Wade MacCallum
[1.1.1.4.1.1.6.14.1.1]
10
Garth MacCallum
[1.1.1.4.1.1.6.14.1.2]
9
Emily Louise MacDonald
[1.1.1.4.1.1.6.14.2]
Delbert Bouton
10
Greg Bouton
[1.1.1.4.1.1.6.14.2.1]
10
Sara Bouton
[1.1.1.4.1.1.6.14.2.2]
+
Coleman Erwin
8
Malcolm Gerald Shaw
[1.1.1.4.1.1.6.15]
b. 17 Oct 1922 d. 27 Oct 1922
6
Samuel Sipprell
[1.1.1.4.1.2]
b. 12 Apr 1836 d. 13 Apr 1836
6
Samuel Sipprell, II
[1.1.1.4.1.3]
b. 23 Feb 1837 d. 19 Jan 1905
Esther Ann Boyer
b. 7 Feb 1842 d. 10 Oct 1882
7
Ernest Alfred Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1]
b. 29 Jun 1868 d. Abt 1943
Beatrice Kilpatrick
b. Abt 1872 d. Abt 1947
8
James Winston Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1]
b. 1900 d. 1974
Helen Margaret Libby
b. 22 Oct 1905 d. Abt 1980
9
Robert Gaylon Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.1]
b. 1 Dec 1933 d. 19 Jul 2014
Shirley Brown
10
Barbara Lee Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.1.1]
10
Brian Leslie Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.1.2]
Edith Margaret Cleghorn
11
Megan Leslie Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.1.2.1]
11
Nicholas Brian Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.1.2.2]
10
Keith Allison Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.1.3]
10
Mark Winston Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.1.4]
10
Janice Maureen Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.1.5]
9
Ernest Delmont Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.2]
b. 11 Nov 1934 d. 28 Oct 2017
Jean Hamilton
10
Rhonda Lynn Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.2.1]
10
Edward Delmont Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.2.2]
10
Larry Bruce Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.2.3]
10
Carl Raymond Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.2.4]
10
Gayle Lorraine Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.2.5]
9
Dorothy Virginia Sipprell
[1.1.1.4.1.3.1.1.3]
Donald Greene
10
Kimberley Jayne Greene
[1.1.1.4.1.3.1.1.3.1]
10
Rodney Stewart Greene
[1.1.1.4.1.3.1.1.3.2]
10
Sandra Dawn Greene
[1.1.1.4.1.3.1.1.3.3]
10
Darrell Leigh Greene
[1.1.1.4.1.3.1.1.3.4]
7
Walter W. Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2]
b. 28 Sep 1873 d. 20 Jun 1905
Emma S. Underhill
b. Mar 1876 d. Abt 1950
8
Verna May Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.1]
b. 19 Feb 1896 d. 7 Jun 1913
8
Walter Leigh Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.2]
b. 22 Jun 1898 d. 22 Jun 1971
Helen Teresa Cuiheen
b. 8 Aug 1898 d. Abt 1973
9
Helen Marie Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.2.1]
b. 31 Mar 1924
+
John Depesa
9
Kathleen Esther Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.2.2]
b. 13 Oct 1926
Edward J. Murphy
10
Kathleen Margaret Murphy
[1.1.1.4.1.3.2.2.2.1]
10
Patricia Ellen Murphy
[1.1.1.4.1.3.2.2.2.2]
10
Robert Edmund Murphy
[1.1.1.4.1.3.2.2.2.3]
10
Edward Joseph Murphy
[1.1.1.4.1.3.2.2.2.4]
10
John Francis Murphy
[1.1.1.4.1.3.2.2.2.5]
9
Walter Robert Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.2.3]
b. 15 Nov 1930 d. 16 Sep 1952
Maxine Newhall
d. Apr 1971
10
Sharon Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.2.3.1]
10
Maureen Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.2.3.2]
b. 6 May 1950 d. Jun 1973
10
Roberta Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.2.3.3]
8
Helen Wallace Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.3]
b. 4 Aug 1901
+
Ward L. Gilmore
8
Ruth A. Sipprell
[1.1.1.4.1.3.2.4]
b. Abt 1903
7
Laura (Annie) Sipprell
[1.1.1.4.1.3.3]
b. 15 Jul 1874 d. 16 Feb 1934
Miles Henry Rideout
b. 22 Sep 1869 d. 1937
8
Walter Arnold Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.1]
b. 29 Mar 1897 d. 27 Sep 1952
Evelyn May Rideout
b. 22 Sep 1897
9
Kathleen Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.1.1]
b. 28 Nov 1918
Clayton Spencer
10
Darrell Arnold Spencer
[1.1.1.4.1.3.3.1.1.1]
+
Beverly Ann Bowers
10
Dale Allen Spencer
[1.1.1.4.1.3.3.1.1.2]
8
Miles Garfield Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.2]
b. 1 Jan 1899 d. 1979
Grace Mabel Shaw
b. 13 Apr 1902
9
Eugene Garfield Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.2.1]
b. 3 May 1923 d. 10 May 1991
+
Laura May Jonasson
b. 27 May 1924 d. 9 Nov 1994
9
Althea Barbara Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.2.2]
b. 8 Feb 1928 d. 28 Feb 2009
+
Donald Ganong
8
Burtt Sipprell Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.3]
b. 18 Apr 1901 d. 3 Jul 1937
Elizabeth McKay
b. 1899 d. 3 Dec 1975
9
Marguerite Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.3.1]
b. 14 Mar 1922
Rev. Harold L. Mitton
10
Ronald Mitton
[1.1.1.4.1.3.3.3.1.1]
10
Ruth Christine Mitton
[1.1.1.4.1.3.3.3.1.2]
8
Joseph Audrey Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.4]
b. 4 Sep 1903 d. 15 Oct 1972
Ena Electra Britton
b. 13 Nov 1902 d. 6 May 1973
9
Shirley Madelyn Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.4.1]
b. 11 Mar 1924 d. 3 Apr 1999
Ralph Everett Culberson
b. 13 Jun 1924
10
Lloyd Everett Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1]
Patricia Ann Lee McMaster
11
Matthew Lloyd Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1.1]
Angela Margaret Rosenear
12
Aleska Lynn Krista Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1.1.1]
12
Carl Pyson Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1.1.2]
12
Mariah Jane Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1.1.3]
11
Mark Andrew Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1.2]
Darcy Elizabeth Galloway
12
Abigail Elizabeth Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1.2.1]
12
Kristin Annlee Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1.2.2]
11
Necia Anne Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1.3]
Mark Allan Dixon
12
Katelyn Anne Dixon
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.1.3.1]
10
Joseph Carl Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.2]
+
Deborah
10
Arnold Bruce Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3]
+
Wanda Ruth Kimball
Wanda Ruth Kimball
11
Sebrina Ruth Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.1]
Rodney Monte Shaw
12
Isaiah Monty Shaw
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.1.1]
12
Ashley Ruth Shaw
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.1.2]
11
Bruce Arnold Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.2]
Michele Dawn Dupuis
12
Makilie Dawn Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.2.1]
12
Emma Madeline Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.2.2]
11
Tabitha Dawn Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.3]
William Colin Savage
12
Thomas William Savage
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.3.1]
12
Alyasa Lori Shirley Savage
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.3.2]
11
Jonah Amos Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.3.4]
10
Wayne Garfield Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.4]
Jean Witallmina Hemeon
11
Paula Jean Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.4.1]
11
Daniel Wayne Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.4.2]
11
Timothy Carl Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.4.3]
11
Nicolas Stephen Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.4.4]
11
Dustin Dlythe Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.4.5]
10
Wanda Grace Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.5]
+
Robert Clinton Everett
Robert Clinton Everett
11
Aaron Robert Everett
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.5.1]
+
Jennifer Ann Colwell
11
Charles Benjamin Everett
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.5.2]
11
Starr Hannah Everett
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.5.3]
Robert Laughlin Cookson
12
Samuel Robert Cookson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.5.3.1]
12
Benjamin David Cookson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.5.3.2]
10
Peter Malcolm Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.6]
Susan Ruth Knowles
11
Heidi Joy Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.6.1]
+
Robert George Bannister
11
Cindy Lynn Culberson
[1.1.1.4.1.3.3.4.1.6.2]
8
Edna Rideout
[1.1.1.4.1.3.3.5]
b. 1902
7
Martha (Mattie) Sipprell
[1.1.1.4.1.3.4]
b. 5 Jun 1876 d. 7 Mar 1897
7
Clara Belle Sipprell
[1.1.1.4.1.3.5]
b. 25 Apr 1878 d. 15 Feb 1958
Scott Rideout
b. 1875 d. 1 Nov 1911
8
Martha Evelyn Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.1]
b. 6 Feb 1899
George Adams Grant
9
Creighton Grant
[1.1.1.4.1.3.5.1.1]
b. 12 Dec 1925
Louise Nickerson
10
Judy Louise Grant
[1.1.1.4.1.3.5.1.1.1]
10
Carolyn Shirley Grant
[1.1.1.4.1.3.5.1.1.2]
R. Tracy
11
Michael Allen Tracy
[1.1.1.4.1.3.5.1.1.2.1]
10
Richard Creighton Grant
[1.1.1.4.1.3.5.1.1.3]
10
Stephen George Grant
[1.1.1.4.1.3.5.1.1.4]
8
George Samuel Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.2]
b. 7 Feb 1901 d. 10 Oct 1966
Velma Evelyn McCallum
b. 21 Aug 1900 d. 23 Nov 1961
9
Enid Alfreda Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.2.1]
b. 16 Jan 1925 d. 27 Aug 2014
Hollis Dickinson
10
Larry Hollis Dickinson
[1.1.1.4.1.3.5.2.1.1]
+
Vanessa Farrell
10
Randy Trent Dickinson
[1.1.1.4.1.3.5.2.1.2]
+
Myra Martha Shaw
b. 12 Sep 1907 d. 12 Jan 1965
8
Clayton Lewis Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3]
b. 23 Aug 1903 d. Jul 1974
Vera Gertrude Brooks
b. 23 Aug 1904 d. 10 Nov 1968
9
Reid Clayton Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3.1]
10
Randy Lewis Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3.1.1]
10
Linda Ann Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3.1.2]
10
Pamela Ferne Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3.1.3]
10
Heather Brooks Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3.1.4]
9
Paul Brooks Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3.2]
10
David Brooks Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3.2.1]
10
Lori Ann Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3.2.2]
10
Mark Clayton Rideout
[1.1.1.4.1.3.5.3.2.3]
+
Warren Rideout
b. 27 Jun 1859 d. 27 Jun 1924
7
Laura Sipprell, I
[1.1.1.4.1.3.6]
b. 20 Oct 1863 d. 1864
7
Murray Sipprell
[1.1.1.4.1.3.7]
b. 9 Jun 1867 d. 1868
+
Mary Elizabeth Moore
b. 1842 d. 17 Nov 1923
6
Abner Mesereau Sipprell
[1.1.1.4.1.4]
b. 31 Mar 1839 d. 11 Jul 1916
Ruth Ann Ackerson
b. 13 Oct 1844 d. 5 Jan 1929
7
Lillian U. Sipprell
[1.1.1.4.1.4.1]
b. 17 Nov 1867 d. 19 Oct 1889
7
Scott Talmadge Sipprelle
[1.1.1.4.1.4.2]
b. 7 Dec 1874 d. 22 Jun 1946
Elizabeth Jane (Lizzie) Oliver
b. 9 Nov 1877 d. 25 Mar 1944
8
Elsa Maud Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.1]
b. 26 Nov 1898 d. 31 Oct 1982
Kenneth Webster Keith
b. 2 Oct 1898 d. 25 Jan 1970
9
Dorothy Emma Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.1]
b. 8 Apr 1921
James MacLeod
10
Ann Lorraine MacLeod
[1.1.1.4.1.4.2.1.1.1]
+
Blair Kennedy
10
Shirley Elsalyn MacLeod
[1.1.1.4.1.4.2.1.1.2]
+
Richard Dickinson
10
Doris Elizabeth MacLeod
[1.1.1.4.1.4.2.1.1.3]
10
James Keith MacLeod
[1.1.1.4.1.4.2.1.1.4]
9
Donald Sipprelle Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.2]
b. 21 Aug 1928
Dorothy Pond
b. 13 Nov 1927
10
Donald Harrison Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.2.1]
Janice Burger
11
Donald Kennedy Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.2.1.1]
10
Judy Marie Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.2.2]
+
David Loukes
10
Patsy Marlene Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.2.3]
Malcolm MacFarlane
11
Kelly Jean MacFarlane
[1.1.1.4.1.4.2.1.2.3.1]
10
Karl Gregory Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.2.4]
+
Jane Dorcas
10
Peter Guy Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.2.5]
10
Elsa Anne Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.2.6]
10
Kenneth Webster Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.2.7]
9
Kenneth Webster Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.3]
b. 3 Feb 1930
Louise Stiles
b. 23 Sep 1933
10
Cynthia Louise Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.3.1]
10
Kathryn Wendy Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.3.2]
10
Susan Elizabeth Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.3.3]
10
Kimberly Ann Keith
[1.1.1.4.1.4.2.1.3.4]
8
Ruth Amanda Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.2]
b. 18 May 1900 d. 5 Jan 1981
Thompson Eade
b. Abt 1895 d. Abt 1970
9
Joyce Elizabeth Eade
[1.1.1.4.1.4.2.2.1]
b. 2 Oct 1920 d. 29 Sep 2003
Kenneth Coates
b. 31 Dec 1915 d. 31 May 2004
10
Kenneth Coates
[1.1.1.4.1.4.2.2.1.1]
10
Constance Coates
[1.1.1.4.1.4.2.2.1.2]
9
Vivian Ruth Eade
[1.1.1.4.1.4.2.2.2]
b. 16 Jun 1929
Ralph Voltz
10
Sallie Ann Voltz
[1.1.1.4.1.4.2.2.2.1]
10
Ralph Timothy Voltz
[1.1.1.4.1.4.2.2.2.2]
8
James Hamilton Sipprelle
[1.1.1.4.1.4.2.3]
b. 27 Feb 1902 d. 12 Aug 1949
Mary Adelene Louise Allen
b. 17 Oct 1906 d. 6 Feb 1991
9
James Hamilton Sipprelle
[1.1.1.4.1.4.2.3.1]
b. 18 Jan 1929 d. 8 Jul 2014
Bessie May Burgess
b. 22 Nov 1930 d. 6 Oct 2005
10
Susanne Louise Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.3.1.1]
10
Cynthia Lynn Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.3.1.2]
Joy Vance
10
Julietta Adelyn Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.3.1.3]
10
James Hamilton Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.3.1.4]
9
Betty Annetta Sipprelle
[1.1.1.4.1.4.2.3.2]
b. 15 Oct 1930
Norman Wyatt Doane
b. 10 Jun 1923 d. 11 May 2009
10
Louise Annetta Doane
[1.1.1.4.1.4.2.3.2.1]
10
Sharon Lee Doane
[1.1.1.4.1.4.2.3.2.2]
+
Herbert Johnston Butler
b. 10 Sep 1954 d. 20 Feb 2009
10
James Wyatt Doane
[1.1.1.4.1.4.2.3.2.3]
10
Richard Eric Doane
[1.1.1.4.1.4.2.3.2.4]
8
Ezekiel Foster Sipprelle
[1.1.1.4.1.4.2.4]
b. 24 Jan 1904 d. 1 Mar 1985
Dolores Lee Dudley
9
Dudley Gene Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.4.1]
Linda Dekun Mills
b. 1935
10
Dwight Dudley Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.4.1.1]
10
Keith Andrew Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.4.1.2]
10
Scott Mills Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.4.1.3]
10
Mark Sheldon Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.4.1.4]
8
Wendell Scott Sipprelle
[1.1.1.4.1.4.2.5]
b. 31 Mar 1909 d. 15 Mar 1976
Irene M. Elliott
b. Jul 1916 d. 30 Jun 1998
9
Richard Eugene Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.5.1]
Ramalia Lopes
10
Lurene Lynn Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.5.1.1]
+
Larry Espinoza
10
Sonia Lynn Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.5.1.2]
9
Doris Arlene Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.5.2]
Robert J. Doyle
10
Pamela Jean Doyle
[1.1.1.4.1.4.2.5.2.1]
10
Susan Ann Doyle
[1.1.1.4.1.4.2.5.2.2]
10
Robert James Doyle
[1.1.1.4.1.4.2.5.2.3]
10
James Patrick Doyle
[1.1.1.4.1.4.2.5.2.4]
9
Philip Reed Sipprelle
[1.1.1.4.1.4.2.5.3]
b. 7 Mar 1942 d. 22 Jan 2000
Donna Joan Bailey
10
Terrill Ann Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.5.3.1]
b. 11 Sep 1961 d. 31 Oct 2002
10
Mark Phillip Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.5.3.2]
+
Carol S. Kirros
9
Norma Jean Sipprell
[1.1.1.4.1.4.2.5.4]
Henry David Schorr
10
Daniel Allen Schorr
[1.1.1.4.1.4.2.5.4.1]
7
Guy Carleton Sipprell
[1.1.1.4.1.4.3]
b. 2 Aug 1883 d. 18 Dec 1976
Ethel E Black
b. 6 Mar 1890 d. 28 Apr 1979
8
Walter William Sipprell
[1.1.1.4.1.4.3.1]
b. 5 Aug 1913 d. 30 Jan 1979
+
Viola Violet Rinell
b. 1910 d. 1968
8
Winnifred Ann Sipprell
[1.1.1.4.1.4.3.2]
b. 3 May 1915 d. 12 Mar 2013
Vern Whitmarsh
9
Deborah K. Whitmarsh
[1.1.1.4.1.4.3.2.1]
8
Merle Lester Sipprell
[1.1.1.4.1.4.3.3]
b. 13 Sep 1924 d. 16 Dec 1984
+
Mary Edna McLeod
b. 10 Jul 1922
7
Rev. Halden Abner Sipprell
[1.1.1.4.1.4.4]
b. 2 Jan 1886 d. 22 Dec 1955
Edith Belyea
b. 6 Jan 1888
8
Muriel Sipprell
[1.1.1.4.1.4.4.1]
b. Abt 1917
8
Lorne Sipprell
[1.1.1.4.1.4.4.2]
8
Robert Sipprell
[1.1.1.4.1.4.4.3]
7
Charles R. Sipprell
[1.1.1.4.1.4.5]
b. 2 Jan 1870 d. 10 Apr 1873
7
Martha Pearl Sipprell
[1.1.1.4.1.4.6]
b. 13 Feb 1872 d. 3 Apr 1873
7
Leslie Sipprell
[1.1.1.4.1.4.7]
b. 31 Jul 1878 d. 11 Jun 1883
7
Roy Wendell Sipprell
[1.1.1.4.1.4.8]
b. 10 Aug 1880 d. 19 Jun 1883
6
Nathaniel Shaw Sipprell
[1.1.1.4.1.5]
b. 14 Jun 1841 d. 18 Oct 1909
Lavinia A Gray
b. 1844 d. 18 Apr 1894
7
Nathaniel Perry Sipprelle
[1.1.1.4.1.5.1]
b. 11 Jul 1871 d. 1943
+
Hildur C. Johnson
b. Abt 1898 d. Jan 1943
+
Florence S. Powell
b. Abt 1885 d. Aft Dec 1956
7
Ezekiel McLeod Sipprell
[1.1.1.4.1.5.2]
b. 23 Feb 1875 d. 15 Sep 1954
Velmont E. Soule
b. Abt 1885 d. 29 Apr 1967
8
Nathaniel Sipprell
[1.1.1.4.1.5.2.1]
b. Abt 1902 d. Abt 1904
8
Glendon O. Sipprell
[1.1.1.4.1.5.2.2]
b. Abt 1905 d. Abt 1908
8
Carl Nathaniel Sipprell
[1.1.1.4.1.5.2.3]
b. 16 May 1918 d. 3 Aug 2004
Marian Anderson
9
Robert Carl Sipprell
[1.1.1.4.1.5.2.3.1]
b. 25 May 1948 d. 1 Jan 2005
+
Patricia A Sacker
Ms Shadish
10
Cara Ann Sipprell
[1.1.1.4.1.5.2.3.1.1]
9
Diane M. Sipprell
[1.1.1.4.1.5.2.3.2]
8
Geraldine M. Sipprell
[1.1.1.4.1.5.2.4]
b. 24 Mar 1922 d. 29 Aug 1992
Gerald Tine
9
David Tine
[1.1.1.4.1.5.2.4.1]
9
Martha Tine
[1.1.1.4.1.5.2.4.2]
9
Elizabeth Tine
[1.1.1.4.1.5.2.4.3]
9
Rebecca Tine
[1.1.1.4.1.5.2.4.4]
7
Nathalia L. (Queenie) Sipprell
[1.1.1.4.1.5.3]
b. 1878
+
Leo L. Babins
+
Luther A Stearns
7
Josephine P Sipprelle
[1.1.1.4.1.5.4]
b. 7 Jan 1886 d. Aug 1963
7
Francis E. Sipprell
[1.1.1.4.1.5.5]
b. 1866 d. Abt 1887
7
Percy Sipprell
[1.1.1.4.1.5.6]
b. 1867 d. Bef 1870
7
Edward Sipprell
[1.1.1.4.1.5.7]
b. 1869 d. Bef 1880
+
Bertha C. Kearney
b. Mar 1865
6
John Colby Sipprell
[1.1.1.4.1.6]
b. 3 Aug 1843 d. 28 Sep 1851
6
Mary Ann Sipprell
[1.1.1.4.1.7]
b. 17 Nov 1845 d. 1 Dec 1847
6
Ezekiel Mallory Siprell
[1.1.1.4.1.8]
b. 7 Jul 1847 d. 25 Oct 1922
Annie Gertrude Fritz
b. 13 Jan 1860 d. 14 Feb 1942
7
Winnifred May Sipprell
[1.1.1.4.1.8.1]
b. 13 Apr 1898 d. 9 Feb 1899
7
Harold Fritz Sipprell
[1.1.1.4.1.8.2]
b. 4 Apr 1900 d. 11 Dec 1976
Mary Logan
b. 16 Feb 1846 d. 19 Dec 1895
7
Garfield James Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3]
b. 15 Oct 1881 d. 23 Dec 1963
Louise Todd Churchill
b. Abt 1880
8
Roy Logan Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.1]
b. 7 Jul 1908 d. 25 May 1966
Cecile Francis (Nancy) Powell
9
John Garfield Logan Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.1.1]
Patricia Sheen
10
Justine Legh Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.1.1.1]
+
Adrian K Bowker
9
Robert Roy Legh Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.1.2]
Lilianne
10
Legh Anthony Powell Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.1.2.1]
9
Edward Harold Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.1.3]
9
Alfred Cecil Churchill Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.1.4]
9
Mary Susan Irene Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.1.5]
9
George Anthony Richard Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.1.6]
8
Robert Dickinson Todd Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.2]
b. 3 Aug 1910 d. Jun 1957
Morma Dickie
9
Marilyn Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.2.1]
Dr. John Brebner
10
Carol Brebner
[1.1.1.4.1.8.3.2.1.1]
10
James John Brebner
[1.1.1.4.1.8.3.2.1.2]
9
James Dickie Churchill Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.2.2]
b. 10 Feb 1941 d. 9 May 1961
9
William Todd Sipprell
[1.1.1.4.1.8.3.2.3]
7
Roy Logan Sipprell
[1.1.1.4.1.8.4]
b. 13 Jan 1884 d. 6 Dec 1925
Grace Keans Hayward
b. 5 Apr 1885 d. 14 Oct 1973
8
Harvey Hayward Sipprell
[1.1.1.4.1.8.4.1]
b. 6 Jun 1921 d. 30 Jun 1934
8
Doris Hayward Sipprell
[1.1.1.4.1.8.4.2]
b. 5 Mar 1916
G. Stewart Sheraton
9
Linda Sheraton
[1.1.1.4.1.8.4.2.1]
9
Barbara Sheraton
[1.1.1.4.1.8.4.2.2]
8
John Mallory Sipprell
[1.1.1.4.1.8.4.3]
b. 9 May 1918
+
Madeleine Got
7
Euphema (Effie) Mary Sipprell
[1.1.1.4.1.8.5]
b. 20 Mar 1886 d. 20 Oct 1918
Stanley Edmund Fisher
8
Kenneth Clarke Fisher
[1.1.1.4.1.8.5.1]
b. 5 Nov 1911 d. 22 Jan 1970
Jeanne Manery
9
Kenneth Robert Stanley Fisher
[1.1.1.4.1.8.5.1.1]
+
Dorothy Denyer
9
Marjorie Manery Fisher
[1.1.1.4.1.8.5.1.2]
+
Ian Fraser
8
Charlotte Logan Fisher
[1.1.1.4.1.8.5.2]
b. 28 Mar 1915
Milledge Hicks
9
Judith Louise Hicks
[1.1.1.4.1.8.5.2.1]
+
Peter Chalmers Smith
9
Mary Ellen Hicks
[1.1.1.4.1.8.5.2.2]
7
Olive (Ollie) Letitia Sipprell
[1.1.1.4.1.8.6]
b. 31 Dec 1888 d. 30 Jul 1968
+
Arnold MacNee
6
Ruth Ann Sipprell
[1.1.1.4.1.9]
b. 30 Mar 1850 d. 3 Jul 1931
+
Edwin Carpenter
b. 11 Sep 1832 d. 28 Apr 1905
6
Phoebe Jane (Jennie) Sipprell
[1.1.1.4.1.10]
b. 28 Nov 1852 d. 25 Apr 1930
Josiah Warren Smith
b. 22 Aug 1837 d. 7 Sep 1890
7
Martha (Mattie) Augusta Smith
[1.1.1.4.1.10.1]
b. 20 Aug 1878 d. 19 Nov 1971
+
Eugene Oliver Grant
+
Thomas L. Stetson
6
Letita Adelaide Sipprell
[1.1.1.4.1.11]
b. 8 Apr 1855 d. 19 May 1875
+
George A. Estabrooks
b. 26 Jul 1850 d. 1926
6
William Henry Sipprell
[1.1.1.4.1.12]
b. 24 Oct 1857 d. 12 Dec 1933
Ruth Ann Williams
b. Aug 1861 d. 4 May 1883
7
John Henry Sipprell
[1.1.1.4.1.12.1]
b. 15 Apr 1883 d. 29 Apr 1883
Edith Eliza Moore
b. 22 Nov 1863 d. 15 May 1899
7
Edna Moore Sipprell
[1.1.1.4.1.12.2]
b. 28 Mar 1885 d. 18 Dec 1955
+
Havelock Churchill
d. 13 Mar 1948
7
Bertha Leonra (Bertie) Sipprell
[1.1.1.4.1.12.3]
b. 8 May 1887 d. 12 Dec 1918
+
Herber Harold Hatfield
b. 17 Apr 1885 d. 3 Jan 1952
7
Harold C. Sipprell
[1.1.1.4.1.12.4]
b. 1889 d. 1889
7
Frederick William Sipprell
[1.1.1.4.1.12.5]
b. May 1891 d. Sep 1891
7
Robert Henry Sipprell
[1.1.1.4.1.12.6]
b. May 1891 d. Sep 1891
7
Arthur Reginald Sipprelle
[1.1.1.4.1.12.7]
b. 7 May 1894 d. 20 Oct 1964
Ella Pearl Miller
b. 12 Jul 1886 d. Abt 1966
8
William Henry Sipprelle
[1.1.1.4.1.12.7.1]
b. 24 Feb 1918
Evelyn Marie Magnuson
b. 14 Sep 1917 d. Abt Dec 1973
9
Gary William Sipprelle
[1.1.1.4.1.12.7.1.1]
+
Valarie Jean Millen
9
Guy Carl Sipprelle
[1.1.1.4.1.12.7.1.2]
b. 4 Jun 1947 d. 8 Apr 2005
Jean Candy Barrington
10
Kristin Anne Sipprelle
[1.1.1.4.1.12.7.1.2.1]
10
Sarah L. Sipprelle
[1.1.1.4.1.12.7.1.2.2]
+
Gladys E. Kenney
7
Robina P. Sipprelle
[1.1.1.4.1.12.8]
b. 29 Aug 1898 d. 27 Jan 1987
+
Jennie E. Estey
b. 10 Nov 1857 d. 16 Mar 1911
+
Annie Irene Williams
b. 25 Jan 1870 d. 7 May 1915
6
Nehemiah James Sipprell
[1.1.1.4.1.13]
b. 23 May 1860 d. 20 Apr 1942
6
James N. Sipprell
[1.1.1.4.1.14]
b. 23 May 1860 d. 20 Apr 1942
Mildred Jane Smith
b. May 1856 d. 30 Jan 1922
7
James Ernest Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1]
b. 26 Sep 1888 d. 8 Nov 1958
Palma R. Lee
b. 27 Jul 1890 d. 22 Jun 1966
8
James Ernest Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1.1]
b. 27 May 1915 d. 13 Apr 2000
+
Helen Caroline Bender
b. 1917 d. 16 Feb 1953
Sally Roberts
9
James Ernest Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1.1.1]
Erin
10
Emily Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1.1.1.1]
10
Natalie Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1.1.1.2]
9
Lisa Simone Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1.1.2]
Phillip Lasconia
10
Bronson Lasconia
[1.1.1.4.1.14.1.1.2.1]
10
Blake Lasconia
[1.1.1.4.1.14.1.1.2.2]
8
Arthur Edwin Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1.2]
b. 27 May 1915 d. 31 Oct 1996
Elizabeth Falconer Swanson
b. 3 Apr 1914 d. 4 Feb 1968
9
Elizabeth Ann Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1.2.1]
Donald Healy
10
Teresa Healy
[1.1.1.4.1.14.1.2.1.1]
Curt Halderson
11
Jessica Halderson
[1.1.1.4.1.14.1.2.1.1.1]
11
Lauren Halderson
[1.1.1.4.1.14.1.2.1.1.2]
10
Alissa Healy
[1.1.1.4.1.14.1.2.1.2]
9
Barbara Lee Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1.2.2]
Michael A. Washo
10
Benjamin M. Washo
[1.1.1.4.1.14.1.2.2.1]
Heidi
11
Cassidy Rose Washo
[1.1.1.4.1.14.1.2.2.1.1]
10
Bernard A. Washo
[1.1.1.4.1.14.1.2.2.2]
+
Lindsay
+
Millie Close
d. Abt 1980
+
Clara Josephine Galbraith
b. 30 Aug 1922 d. 27 Sep 2006
8
Jean Letitia Sipprell
[1.1.1.4.1.14.1.3]
b. 23 Feb 1920
Fred M. Quistorff
9
James Arthur Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.1]
Doris Larsen
10
James Arthur Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.1.1]
10
Patricia Jean Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.1.2]
10
Stephanie Ruth Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.1.3]
10
Sarah Ann Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.1.4]
10
Michelle Lee Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.1.5]
Ana Rasmussen
10
Daniel Lawrence Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.1.6]
Gayle
10
Cassidy Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.1.7]
10
Gabriel Michael Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.1.8]
9
Carla Jean Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.2]
Gary Richard Pfaff
10
Steven Michael Pfaff
[1.1.1.4.1.14.1.3.2.1]
Diane
11
Brooke Peidan Pfaff
[1.1.1.4.1.14.1.3.2.1.1]
10
Douglas James Pfaff
[1.1.1.4.1.14.1.3.2.2]
Deb
11
Alexander James Pfaff
[1.1.1.4.1.14.1.3.2.2.1]
11
Emma Louise Pfaff
[1.1.1.4.1.14.1.3.2.2.2]
10
Lara Lee Pfaff
[1.1.1.4.1.14.1.3.2.3]
Mr Morrison
11
Cassandra (Cassie) Morrison
[1.1.1.4.1.14.1.3.2.3.1]
9
Lawrence F. Quistorff
[1.1.1.4.1.14.1.3.3]
b. 9 Feb 1947 d. Bef 2008
7
Ruby Mildred Sipprell
[1.1.1.4.1.14.2]
b. 3 Jan 1892 d. Abt 1976
+
George F. Mann
b. Abt 1887 d. Abt 1962
7
Ada Ruth Sipprell
[1.1.1.4.1.14.3]
b. 23 Oct 1894 d. 4 May 1964
George T. Knieriem
b. Abt 1893 d. Aug 1971
8
George Sipprell Knieriem
[1.1.1.4.1.14.3.1]
6
Sarah Ada Sipprell
[1.1.1.4.1.15]
b. 19 Oct 1863 d. 18 Jan 1926
George A. Estabrooks
b. 26 Jul 1850 d. 1926
7
Inez Maud Estabrooks
[1.1.1.4.1.15.1]
b. 7 Apr 1884 d. 15 Feb 1975
Ralph Jay Merrill
b. 8 Jul 1882 d. 22 Jan 1953
8
Roger Ellery Merrill
[1.1.1.4.1.15.1.1]
b. 19 Jun 1908 d. Jul 1976
8
Albert Ralph Merrill
[1.1.1.4.1.15.1.2]
b. 16 Aug 1909 d. 20 Sep 1981
+
Irene Alla Bileu
b. 29 Nov 1912 d. Oct 1993
+
Louise Jorgenson
b. 1911
+
Helen Pyle
b. 2 Nov 1911 d. 1963
8
Pauline Inez Merrill
[1.1.1.4.1.15.1.3]
b. 19 May 1911 d. Abt 2002
8
Ralph Jay Merrill
[1.1.1.4.1.15.1.4]
b. 19 Sep 1913 d. 10 May 1943
8
Helen Irene Merrill
[1.1.1.4.1.15.1.5]
b. 3 Apr 1916
+
Jack Achenbach
b. Abt 1901
8
Gertrude R. Merrill
[1.1.1.4.1.15.1.6]
b. 11 Oct 1919 d. 12 Jun 1967
+
William Travis Holley
b. 3 Feb 1913 d. 25 Sep 1983
7
James E. Estabrooks
[1.1.1.4.1.15.2]
b. 1888
7
Ruth Estabrooks
[1.1.1.4.1.15.3]
b. 1886
7
Frank E. Estabrooks
[1.1.1.4.1.15.4]
b. 1889 d. Bef 1974
+
George P. Sproule
b. 14 Sep 1863 d. 21 Jan 1945
6
Jane Siprell
[1.1.1.4.1.16]
Counts