Home
Bob's Side
Cath's Side
Steed Side
TNG Link
First Name:
Last Name:
Whispers Past
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Recordings
Videos
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Search
|
Advanced Search
|
Search Families
|
Search Site
First Name:
Last Name:
ID:
Print
Bookmark
Lady Agnes Sinclair
1509 - 1572 (63 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Lady Agnes Sinclair
[1]
b. 1509 d. 21 Mar 1572
Patrick III Hepburn
b. 1512 d. 9 Sep 1556
2
Lady Jean Hepburn
[1.1]
b. 1542 d. 27 Jul 1599
John Stewart
b. 1 May 1531 d. 1 Nov 1563
3
Francis Stewart
[1.1.1]
b. Abt 1563 d. Abt 1612
Margaret Douglas
b. 1558 d. 1640
4
Elizabeth Stewart
[1.1.1.1]
b. Aug 1588 d. 10 Dec 1625
Rev. James Cranstoun
b. Abt 1585 d. 8 Feb 1634
5
William Cranstoun
[1.1.1.1.1]
b. 16 Dec 1611 d. Aft 29 Jul 1664
Mary Leslie
b. 1615 d. 27 Sep 1663
6
Margaret Cranstoun
[1.1.1.1.1.1]
b. 1654 d. Abt 1687
Adam Thomson
b. 14 Mar 1652 d. 30 Jun 1710
7
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 14 Mar 1679 d. 1720
Helen Beattie
b. 1687 d. Bef 1742
8
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 5 Feb 1713 d. 21 Dec 1792
Jannett Scott
b. 25 Oct 1717 d. 22 Feb 1802
9
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 30 Sep 1763 d. 22 Jun 1834
Mary Glendinning
b. 28 Jan 1768 d. 8 Nov 1847
10
James D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 29 Apr 1789 d. 26 Mar 1867
Isabella Johnston
b. 26 Jun 1794 d. 11 Aug 1854
11
Sonny Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. Jul 1817 d. 9 Jul 1817
11
Jannet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 31 Aug 1818 d. 12 Mar 1819
11
David James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 5 Jun 1821 d. 28 Nov 1894
Agnes Burns
b. 24 May 1844 d. 8 Jan 1917
12
James B. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 9 Apr 1866 d. 4 Nov 1940
12
Margaret Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. May 1868 d. 31 Dec 1935 [
=>
]
12
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 2 Mar 1871 d. 8 Jul 1948 [
=>
]
12
Andrew J Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 16 Sep 1873 d. 2 Feb 1947 [
=>
]
12
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 30 Jul 1875 d. Jan 30 1938 [
=>
]
12
Elizabeth Ann (Janie) Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 12 Jul 1877 d. 20 Jul 1942 [
=>
]
12
Robert Burns Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 2 Jun 1880 d. Abt 1902
12
Thaddeus A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 7 Apr 1889 d. Aft 1920
12
Richard John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9]
b. 2 Jun 1884 d. 24 May 1887
11
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 12 Feb 1823 d. 30 Jan 1895
John Underwood
b. 1 May 1822 d. 24 Oct 1906
12
Archibald Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 6 Feb 1848 d. Aft 1881
12
Catherine Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 7 Oct 1849 d. 10 Jan 1929 [
=>
]
12
Jannet Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 14 Aug 1852 d. 31 Jan 1931 [
=>
]
12
Elizabeth Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 26 Apr 1855 d. 24 Aug 1932 [
=>
]
12
Rebecca Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 1860 d. 13 Sep 1900 [
=>
]
12
James Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6]
b. Apr 1858 d. 16 Oct 1879
12
Mary Ann Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 3 Oct 1853 d. 25 Jun 1904 [
=>
]
11
Robert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 4 May 1825 d. 11 Apr 1894
Mary Sellers
b. 25 Feb 1847 d. 7 Dec 1926
12
Sarah Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 26 Dec 1872 d. 27 Jun 1952
12
James A Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 9 Sep 1874 d. 20 Jan 1940
12
William David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3]
b. 20 Sep 1876 d. 30 Jan 1949
12
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.4]
b. 1 May 1879 d. Jul 1940
12
Stephen Sidney Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5]
b. 26 May 1883 d. 30 Oct 1969 [
=>
]
12
Sophie Annie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.6]
b. 2 Oct 1885 d. 27 Feb 1962 [
=>
]
11
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 1829
11
Andrew James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 27 Jan 1830 d. 20 Oct 1907
Mary McKirgan
b. 15 Jul 1837 d. 18 Jan 1931
12
James Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 29 Jan 1865 d. 2 Apr 1924 [
=>
]
12
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 30 Apr 1863 d. 14 Jul 1943 [
=>
]
12
Martha Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 7 Apr 1867 d. 11 Mar 1909 [
=>
]
12
George McKergan Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4]
b. 10 Feb 1874 d. 22 Jul 1940 [
=>
]
11
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 4 Jan 1831 d. 14 Feb 1899
James Walter Miller
b. 15 Sep 1830 d. 23 Nov 1918
12
Robert Miller
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 11 Dec 1852 d. 23 Nov 1902 [
=>
]
12
Isabella Miller
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 15 Jun 1857 d. 3 Jun 1936 [
=>
]
12
Elizabeth Jane Miller
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3]
b. 18 Aug 1859 d. 3 Feb 1893 [
=>
]
12
Janet T. Miller
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 2 May 1862 d. 30 Nov 1930 [
=>
]
12
James Miller
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.5]
b. 31 Mar 1864 d. 1888
12
David Andrew Miller
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6]
b. 24 Apr 1870 d. 26 May 1882
12
John Miller
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7]
b. 17 Aug 1872 d. 1 Sep 1883
12
Mary Ida Miller
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.8]
b. 23 Mar 1866 d. 29 Jul 1900 [
=>
]
12
William Robert Miller
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.9]
b. 15 Feb 1869 d. 17 Aug 1937 [
=>
]
10
Andrew D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 23 Nov 1790 d. 27 Jul 1854
Clarissa (Clarcy) Stevens
b. Feb 1799 d. 28 Jan 1888
11
Susanah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 9 Aug 1829 d. 20 Mar 1898
Charles Sanderson
b. 16 Jan 1819 d. 16 Jul 1884
12
Isabella Jane Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 17 Nov 1865 d. 9 Mar 1936 [
=>
]
12
Hannah Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 13 Jun 1853 d. 30 Aug 1926 [
=>
]
12
John Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 6 Aug 1856 d. 22 Jun 1925 [
=>
]
12
Seneca Charles Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 11 Sep 1859 d. 18 Sep 1865
12
Clarissa Ann Sanderson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 21 Oct 1863 d. 6 Dec 1948 [
=>
]
11
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 25 Sep 1820 d. 20 Oct 1897
Richard Sylvester
b. 1819 d. 22 Jul 1876
12
Clarissa Adelaide Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 4 Jun 1842 d. 15 Jul 1921 [
=>
]
12
Elizabeth Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2]
b. 18 Jul 1843 d. 24 Jul 1854
12
Charles Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 6 Dec 1844 d. 7 May 1917 [
=>
]
12
Mary Isabella Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 29 Jan 1847 [
=>
]
12
Boyd Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 29 Jan 1849 d. 21 Nov 1885
12
Hannah Delphina Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6]
b. 1 Jul 1850 d. 28 Jan 1883 [
=>
]
12
Experience Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7]
b. 23 Dec 1851 d. 10 Oct 1859
12
Richard Thomson Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8]
b. 3 May 1854 d. Aft 1881 [
=>
]
12
Andrew Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9]
b. 10 Aug 1857 d. 1934 [
=>
]
11
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 7 Aug 1821 d. 19 Nov 1894
James Seneca Palmer
b. 11 May 1821 d. 1881/1891
12
Mary Ann Palmer
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 9 Jan 1855 d. 15 Jun 1934 [
=>
]
12
Ida H. Palmer
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2]
b. 23 Mar 1860 d. 18 Oct 1924 [
=>
]
12
Jennie Palmer
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 23 Mar 1850
12
Etta Palmer
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 23 Mar 1860 d. 8 Aug 1925 [
=>
]
12
Seneca Palmer
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.5]
b. 2 Apr 1851 [
=>
]
12
James Thomson Palmer
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6]
b. 20 Apr 1862 [
=>
]
12
William Palmer
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.7]
b. 25 Mar 1846 d. 16 Sep 1854
11
William Andrew David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 21 Jan 1823 d. 16 Feb 1902
Elizabeth Douglas
b. 14 Dec 1836 d. 9 Jan 1917
12
Sarah J. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1]
b. 15 May 1858
12
Adelaide Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2]
b. 1860 d. Oct 1881
12
Sarah Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3]
b. 29 Jun 1868 d. 26 Nov 1924 [
=>
]
12
Janet E. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4]
b. 18 Jun 1873 d. 17 Feb 1949
12
Clarissa Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5]
b. 27 Oct 1875 d. 28 Oct 1938 [
=>
]
12
Agnes Bella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.6]
b. 18 Aug 1877 d. 23 Mar 1958 [
=>
]
12
Edith Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.7]
b. 2 May 1880 d. 26 Jun 1956 [
=>
]
12
Susannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8]
b. 8 Mar 1865 d. 23 Jun 1878
11
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 1826 d. 8 Jun 1879
Robert Heron
b. 1819 d. 1854
12
David Heron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1]
b. 1846 d. 1846
12
Andrew Heron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.2]
b. 1848 d. 1848
12
Caroline Heron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.3]
b. 4 Dec 1851 d. 14 Feb 1913 [
=>
]
12
Hannah Heron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.4]
b. 16 Jan 1855 d. 19 Feb 1910 [
=>
]
Robert Sisley
b. Abt 1832 d. Circa Apr 11 1866
12
Janet Adelaide Sisley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.5]
b. 13 Jan 1859 d. 4 May 1949
11
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 1824 d. 8 Jun 1896
11
Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 7 Dec 1827 d. 20 Oct 1908
William Sylvester
b. 20 Mar 1822 d. 22 Oct 1860
12
Richard Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 18 Aug 1847 d. 23 May 1911 [
=>
]
12
Clarissa Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 14 Jun 1855 d. 16 Jul 1924 [
=>
]
12
Andrew Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 15 Sep 1850
12
William Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.4]
b. 19 Aug 1857
12
Hannah Ellen Sylvester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5]
b. 6 Jul 1861 d. 6 Jan 1890 [
=>
]
11
Seneca George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 5 Aug 1839 d. 18 Oct 1904
Mary Harriet Fitzpatrick
b. 8 May 1845 d. 3 Jul 1908
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 1863 d. 1930 [
=>
]
12
Mary Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.2]
b. 1871 d. 1895 [
=>
]
12
Seneca George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.3]
b. Oct 1874 d. Aft 2 Jan 1920 [
=>
]
12
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4]
b. May 1866 d. 1945 [
=>
]
12
Olive Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.5]
b. Jun 1877 d. 1948 [
=>
]
12
Valtina Maud Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.6]
b. Aug 1879 d. Jul 1946 [
=>
]
12
Clara C. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.7]
b. Sep 1882 [
=>
]
12
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.8]
b. 15 Dec 1869 d. 5 May 1870
11
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9]
b. 24 Mar 1833 d. 25 Mar 1915
John Barzillis Mosher
b. 1821 d. 23 Jun 1893
12
Clarissa Mosher
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.1]
b. 19 Sep 1850 d. 19 Sep 1924
12
Gertrude Mosher
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.2]
b. 1853 [
=>
]
12
William Thomson Mosher
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.3]
b. 1854 d. 11 Feb 1929 [
=>
]
12
Reuben Andrew Mosher
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.4]
b. 15 Jul 1856 d. 12 Jul 1935
12
David George Mosher
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.5]
b. 3 Aug 1864 d. 1944 [
=>
]
12
Seneca Richard Mosher
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.6]
b. 22 Jul 1862 d. 7 May 1950 [
=>
]
12
Estella May Mosher
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.7]
b. 14 Aug 1871 d. 30 Sep 1960 [
=>
]
12
Agirta Mosher
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.8]
b. 1867
11
Richard A.D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10]
b. 1835 d. 28 Mar 1877
Elizabeth Glendinning
b. 22 Jan 1835 d. 24 Sep 1893
12
Andrew Alexander Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10.1]
b. 9 Jul 1859 d. 26 Feb 1928 [
=>
]
12
Archibald Stobo Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10.2]
b. 28 Feb 1861 d. 18 May 1877
12
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10.3]
11
Charles Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.11]
b. 10 Feb 1837 d. 29 Jul 1909
Esther Clementine Stewart
b. 6 Sep 1853 d. 5 May 1926
12
Violet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.11.1]
b. 30 Nov 1870 d. 23 Aug 1918
12
Clara M. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.11.2]
b. 1 May 1873 d. 2 Feb 1943 [
=>
]
12
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.11.3]
b. 1876 d. 15 Apr 1881
12
Bernice Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.11.4]
b. 25 Sep 1878 d. 1961 [
=>
]
12
Florence May Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.11.5]
b. 1883 d. Aug 1962
12
Ernest Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.11.6]
b. 1879
11
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.12]
b. 31 Mar 1832 d. Bef 1881
Christina Glendinning
b. 6 Jan 1837 d. 10 May 1920
12
Isabella Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.12.1]
b. 19 May 1859 d. 18 May 1885
12
Andrew Borthwick Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.12.2]
b. 16 May 1862 d. 10 Mar 1877
12
William H. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.12.3]
b. 1865 d. 12 Mar 1877
12
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.12.4]
b. 1857 d. 29 Mar 1877
Janet Thomson
b. Abt 1796
11
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13]
b. 25 Jul 1813 d. 14 Jul 1890
Joseph Walton
b. 4 May 1804 d. 12 Feb 1888
12
Eunice Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.1]
b. 4 Aug 1834 d. 3 Jan 1904 [
=>
]
12
Esther H. Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.2]
b. 28 Mar 1839 d. 23 Apr 1869
12
Henry Watson Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.3]
b. 4 Feb 1856 d. 20 Aug 1927 [
=>
]
12
Jane (Jennie) Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.4]
b. 26 Sep 1833 d. 20 Apr 1900 [
=>
]
12
Wallace Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.5]
b. 1840 d. 30 Jun 1896 [
=>
]
12
Sarah Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.6]
b. Abt 1844
12
William Joseph Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.7]
b. 1845 d. 9 Feb 1917
12
Caroline Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.8]
b. Abt 1848 d. Bef 1881
12
Andrew Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.13.9]
b. Abt 1851 d. Aft 1886
10
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 8 Jan 1793 d. 15 Aug 1872
Peter Little
b. 18 Aug 1796 d. 12 Jul 1847
11
Thomas A Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 18 Jun 1825 d. 6 Mar 1869
Eunice Walton
b. 4 Aug 1834 d. 3 Jan 1904
12
Lydia Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 16 Mar 1854 d. 20 Apr 1929
12
Andrew Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2]
b. 1 Mar 1856 d. 30 Apr 1921 [
=>
]
12
Joseph Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.3]
b. 9 Dec 1858 d. 14 Jan 1935
12
Thomas Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 21 Jan 1861 d. 21 Feb 1907
12
Isabell Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.5]
b. 22 Dec 1864 d. 13 Feb 1935 [
=>
]
12
Sarah Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.6]
b. 11 May 1865 d. 11 May 1865
12
Charles Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.7]
b. 5 Apr 1867
12
Carrie Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.8]
b. 17 Mar 1869 d. 21 Dec 1875
11
Mary Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 22 Feb 1822 d. 19 Oct 1886
Robert Sellers
b. 28 Apr 1809 d. 8 Mar 1895
12
Martha Sellers
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. 1861 d. 3 Oct 1864
12
Helen Sellers
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2]
b. 27 Feb 1845 d. 22 Apr 1853
12
Robert Peter Sellers
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.3]
b. 19 Jan 1855 d. 17 Feb 1927 [
=>
]
12
William Sellers
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4]
b. 2 Jul 1851 d. 26 Jan 1932 [
=>
]
12
Frances Sellers
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.5]
b. 1 Aug 1860 d. 21 Jun 1914 [
=>
]
12
Isabella Sellers
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.6]
b. 28 Nov 1852 d. 3 May 1889 [
=>
]
12
Janet (Jennie) B. Sellers
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.7]
b. 1 Jan 1858 d. 8 Mar 1886 [
=>
]
12
Mary Sellers
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.8]
b. 29 Jan 1849 d. 31 Mar 1902 [
=>
]
12
Peter Sellers
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.9]
b. 18 Sep 1846 d. 21 Apr 1853
11
David Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 1833
Helen
b. 1831
12
Andrew Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 1859
11
Janet (Jennie) Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 16 Jan 1828 d. 2 Dec 1893
Andrew Janulet Taylor
b. May 1826 d. 12 Sep 1893
12
Richard Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 7 Oct 1846 d. 7 May 1853
12
Peter Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2]
b. 30 Sep 1848 d. 30 Apr 1853
12
David Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
b. 4 Apr 1860 d. 8 Feb 1885
12
Isabella Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4]
b. 17 Mar 1857 d. 28 Jun 1878
12
James Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 1852
12
Robert Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.6]
b. 14 Dec 1850 d. 15 Mar 1924 [
=>
]
12
Andrew Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.7]
b. 23 Oct 1855 [
=>
]
12
Frances (Fanny) Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8]
b. 6 Feb 1862 d. 20 Oct 1901 [
=>
]
12
Anthenatte (Nettie) Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.9]
b. 29 Nov 1867 d. 15 Mar 1903 [
=>
]
12
Mary A. Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.10]
b. 30 May 1864 [
=>
]
12
Ellen Taylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11]
b. 8 Aug 1870 [
=>
]
11
Helen (Ellen) Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 27 May 1831 d. 19 Jun 1911
William Curtis
b. 1827 d. 19 Jul 1879
12
Andrew Little Curtis
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.1]
b. 11 Feb 1860 d. 25 Jul 1932
12
David Curtis
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.2]
b. 12 Sep 1865 d. Aft 1901
12
Isabella Curtis
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3]
b. 1867 d. Aft 1901
12
Thomas Curtis
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.4]
b. 1870
10
Richard D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 18 Oct 1794 d. 22 Feb 1878
Harriet Smith
b. Dec 1799 d. 17 May 1881
11
David R. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 1 Dec 1821 d. 30 Apr 1891
Rebecca Chester
b. 7 Oct 1825 d. 4 Mar 1916
12
Richard D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.1]
b. 3 Sep 1850 d. 18 Sep 1934 [
=>
]
12
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.2]
b. 11 Mar 1852 d. 10 Sep 1937 [
=>
]
12
Isaac Whiteford Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3]
b. 1854 [
=>
]
12
Henry Utrech Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.4]
b. 12 Jul 1865 d. 1944
12
Arthur Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.5]
b. Jun 1859 d. 4 Oct 1863
12
Rebecca Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.6]
b. 1 Sep 1862 d. 9 Aug 1948 [
=>
]
11
Amos R Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 17 Jun 1824 d. 8 Jan 1908
Margaret Rae
b. 1829 d. 9 Aug 1860
12
Agnes Hamilton Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 26 Aug 1856 d. 28 Dec 1928 [
=>
]
12
Harriet Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. 20 Jun 1858 d. Aft 31 Mar 1901 [
=>
]
Isabella Brownlie
b. 20 Dec 1834 d. 1924
12
Jane Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. 18 Jul 1862 d. 14 Dec 1934
12
Richard Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 27 Feb 1865 d. 26 Mar 1923
12
John Mark Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 19 Sep 1867 d. 1919
12
Abigail Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.6]
b. 9 May 1870 d. 1954
12
Isabella Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.7]
b. 16 May 1874 d. Dec 1969 [
=>
]
12
Arthur Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.8]
b. 7 Dec 1875 d. 30 Aug 1953 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.9]
b. 15 Nov 1873 d. 6 Jan 1949
11
Richard R. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 28 Mar 1827 d. 26 May 1914
Helen Dimma
b. 1826 d. 25 Aug 1885
12
Richard W Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 10 Apr 1853
12
Christina Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.2]
b. 21 Jul 1855 d. 24 Nov 1937
12
James Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.3]
b. 31 Aug 1857 d. 8 Dec 1904 [
=>
]
12
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.4]
b. 1860
12
David Henry Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.5]
b. 25 Jun 1865 d. 28 Dec 1901 [
=>
]
12
Cessford Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.6]
b. 30 Aug 1869 d. 1947
12
Agnes Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.7]
b. 21 Jan 1863 d. Bef 1928 [
=>
]
12
Robert S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.8]
b. 1870
11
Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 1828 d. 1 Jun 1900
Elizabeth Bell
b. 1831 d. 21 Aug 1897
12
Isabella Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 6 May 1855 d. Aft 31 Mar 1911 [
=>
]
12
Richard S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.2]
b. 8 Sep 1855 [
=>
]
12
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.3]
b. 20 Dec 1859 d. 21 Jan 1921 [
=>
]
11
William R. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 10 Mar 1834 d. 28 Oct 1903
Violet Henderson Brown
b. 25 Apr 1843 d. 8 Aug 1908
12
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.1]
b. 12 May 1864 d. 23 Sep 1925 [
=>
]
12
Marion Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.2]
b. 1866 [
=>
]
12
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.3]
b. 1868
12
Frank Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.4]
b. 1871
12
Egbert Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.5]
b. 1872 d. 13 Mar 1907
12
Agnes Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.6]
b. 1876 [
=>
]
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.7]
b. 1878
12
Violet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.5.8]
11
James Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6]
b. 29 Dec 1839 d. 6 Nov 1924
Agnes Davidson
b. 7 Oct 1845
12
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6.1]
b. 26 Feb 1873
12
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6.2]
b. Jun 1875 d. 3 Apr 1887
12
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6.3]
b. 1876
12
Smith Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6.4]
b. 9 May 1879
12
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6.5]
b. 28 Jul 1880 [
=>
]
12
Charles Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6.6]
b. 29 Mar 1883
12
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.6.7]
b. 17 Jun 1885 [
=>
]
11
Abigail Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.7]
b. 4 Apr 1843 d. 19 Oct 1905
William Underwood
b. Apr 1835 d. 14 Nov 1894
12
Harriet Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.7.1]
b. 13 Nov/Oct 1878 d. 6 Jul 1893
12
Catherine Elizabeth Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.7.2]
b. 15 Apr 1881 d. 22 May 1947
12
Jane Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.7.3]
b. 15 Jun 1883 d. 13 Aug 1971
12
Archibald Underwood
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.7.4]
b. 21 Feb 1885 d. 26 Apr 1926 [
=>
]
11
John Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.8]
b. 31 Dec 1836 d. 3 Jul 1886
Agnes Brown
b. 14 May 1839 d. 27 Sep 1875
12
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.8.1]
b. 14 Nov 1860 d. 3 Jun 1914 [
=>
]
12
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.8.2]
b. 24 Jun 1862 [
=>
]
12
Marion Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.8.3]
b. 30 Aug 1865 [
=>
]
12
Abigail Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.8.4]
b. 1871 [
=>
]
12
Dr. John Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.8.5]
b. 1874 d. 31 Oct 1955 [
=>
]
12
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.8.6]
b. Oct 1870 d. Feb 1871
10
Archibald D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 2 Aug 1796 d. 27 Dec 1877
Hannah Walton
b. 4 Jan 1801 d. 11 Apr 1886
11
Jennet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 30 Mar 1823 d. 26 May 1896
George Evans
b. 1816
12
Archibald Evans
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.1]
12
Robert Evans
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1.2]
b. 1850 [
=>
]
11
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 30 Mar 1823 d. 27 Nov 1851
Fullerton Gibson
b. 30 Apr 1825 d. 23 May 1912
12
Mary Gibson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.2.1]
b. Abt 1852 [
=>
]
12
James Gibson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.2.2]
b. 4 Mar 1850 d. Aft 31 Mar 1901 [
=>
]
11
Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3]
b. 15 Mar 1828 d. 4 Apr 1915
David Pherrill
b. 1824 d. 5 Mar 1896
12
David Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3.1]
b. 1 Jun 1862 d. 24 Feb 1963
12
Mary Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3.2]
b. Feb 1853 d. 15 Mar 1854
12
Stephen Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3.3]
b. 2 Dec 1850 d. 11 Jan 1915
12
James Albert Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3.4]
b. 17 Jan 1861 d. 10 Apr 1931 [
=>
]
12
Archibald George Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3.5]
b. 6 Aug 1858 d. 8 Jan 1916 [
=>
]
12
Thomson David Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3.6]
b. 9 Aug 1866 d. 21 Dec 1946
12
Jane Isabella Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3.7]
b. 1853 [
=>
]
12
Margaret Pherrill
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3.8]
b. 17 Jul 1863
11
Archibald A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.4]
b. Jan 1831 d. 8 Jul 1896
Eliza Richardson
b. 14 Jun 1838 d. 29 Mar 1915
12
George A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.1]
b. 17 Jan 1866 d. 1937
12
Margaret Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.2]
b. 28 Jan 1878 d. 28 Nov 1947
12
David Charles Thomas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.4.3]
b. 18 Jun 1875 d. 25 Jan 1952
11
David A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5]
b. 21 Feb 1834 d. 30 Mar 1893
Margaret Paterson
b. 1840 d. 29 Jan 1875
12
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.1]
b. 9 Jun 1862 d. Aft 31 Mar 1901 [
=>
]
12
Mary Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.2]
b. 31 Jul 1867 d. 29 Jun 1909
12
Archibald D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.3]
b. 21 Feb 1868 d. 29 Mar 1944 [
=>
]
12
Annie J. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.4]
b. 1872 d. 2 Aug 1935 [
=>
]
12
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.5]
12
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.6]
11
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.6]
b. 10 Apr 1837 d. 6 Jul 1924
William Ionson
b. 17 Sep 1834 d. 4 Jan 1905
12
James Ionson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.6.1]
b. 24 Apr 1862 d. 8 Jun 1945 [
=>
]
12
Archibald William Ionson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.6.2]
b. 7 Jun 1864 d. 21 Feb 1949 [
=>
]
12
Mary Hannah Ionson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.6.3]
b. 18 Jan 1871 d. 11 Mar 1930 [
=>
]
12
Albert Ionson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.6.4]
b. 11 May 1868 d. Jul 1936 [
=>
]
11
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7]
b. 22 Dec 1839 d. Aft 1901
Simpson Barron
b. 29 Jul 1830
12
George Barron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.1]
b. 15 Oct 1866
12
Archibald Barron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.2]
b. 1868
12
Wesley Walton Barron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.3]
b. 22 Oct 1878 d. 7 Sep 1930 [
=>
]
12
Hannah Barron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.4]
b. 27 Dec 1869 [
=>
]
12
Isabella Barron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.5]
b. 6 Jul 1872 d. Abt 1968 [
=>
]
12
Mary Jane Barron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.6]
b. 6 Apr 1874 d. 4 Nov 1968
12
Sarah Anne Barron
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7.7]
b. Abt 1877 d. Jul 1957 [
=>
]
11
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.8]
b. Abt 1845 d. 1 Apr 1872
Adam Richardson
b. 1 Nov 1846
12
Isabella Richardson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.8.1]
b. Mar 1872 d. 27 Jul 1872
11
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.9]
b. 9 Sep 1841 d. 31 Aug 1842
10
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 27 Feb 1798 d. 12 Oct 1852
Rebecca Miskie
b. Dec 1804 d. 23 Jun 1863
11
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 1824
+
Mrs. Pheonix
11
John D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 1826 d. 18 Jan 1857
Mary Ann Teasdale
b. 11 Mar 1837 d. 23 Dec 1914
12
David J. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. 7 Mar 1856 d. 14 Sep 1874
11
Sarah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 28 May 1831 d. Aft 1901
Francis Little
b. 1829 d. 4 Oct 1881
12
Mary Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 1850 [
=>
]
12
Rebecca Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.2]
12
David Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 25 Jul 1854 d. 22 Jun 1878
12
Janet Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.4]
12
Isabella Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 1859 [
=>
]
11
David Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 11 Jul 1830 d. 22 Mar 1902
Mary Walker
b. 1832
12
Thaddeus Wright Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.1]
b. 21 Oct 1863 d. 16 Apr 1933 [
=>
]
12
Rebecca Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2]
b. Abt 1857 [
=>
]
11
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5]
b. 1840 d. 3 Dec 1885
John McCaffrey
b. 1838
12
James McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.1]
b. 11 Jul 1863 d. 7 Dec 1939 [
=>
]
12
Andrew McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.2]
b. 1853 [
=>
]
12
David McCaffrey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.3]
b. 20 Jul 1866 [
=>
]
11
Thaddeus Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.6]
b. 16 Mar 1834 d. 23 Oct 1915
Barbara Walker
b. 9 Apr 1846 d. 4 Jan 1924
12
Thaddeus Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.6.1]
b. 1864
11
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7]
b. 23 Nov 1844 d. 9 Apr 1922
Francis Little
b. 1829 d. 4 Oct 1881
12
James Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.1]
12
Isabella Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.2]
10
Janet (Jennet) Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 18 May 1800 d. 11 Jan 1862
Andrew Johnston
b. 7 Sep 1796 d. 3 Sep 1868
11
James Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 22 Jan 1821 d. 13 Sep 1853
Isabella Little
b. 22 Jul 1820 d. 7 Jul 1912
12
Andrew Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1]
b. 9 Jul 1843 [
=>
]
12
John Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.2]
b. 30 Nov 1844 d. 26 Apr 1906 [
=>
]
12
William Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3]
b. 4 Jul 1846 d. 1925 [
=>
]
12
Mary Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.4]
b. Jul 1849 d. 13 Sep 1851
12
Robert Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.5]
b. 30 Sep 1850 d. 14 Feb 1852
12
Mary Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.6]
b. 3 Mar 1853 d. 10 Oct 1944 [
=>
]
11
Mary Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 19 Dec 1818 d. 2 Mar 1876
John Donaldson
b. 1815 d. 28 Feb 1895
12
John Donaldson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.1]
b. Feb 1837 d. 30 May 1914 [
=>
]
12
Elizabeth Donaldson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.2]
b. 21 Aug 1854
12
Mary Donaldson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.3]
12
Jennet Donaldson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.4]
b. 5 Jul 1852 d. 1911 [
=>
]
12
Isabella Donaldson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.5]
12
Helen Donaldson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.6]
b. 19 Apr 1859 d. 1 Jan 1933 [
=>
]
12
Andrew Donaldson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.7]
b. Abt 1846 [
=>
]
12
Christina Donaldson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.8]
b. Abt 1857 [
=>
]
11
William Richard Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1825 d. 6 Feb 1872
11
Robert Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4]
b. 27 May 1827 d. 19 Aug 1896
Melinda Harrington
b. 1 Jul 1833 d. 18 Nov 1860
12
Andrew Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.1]
b. 14 Mar 1855 d. 16 Feb 1857
12
William James Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.2]
b. 23 Sep 1857 d. 15 Mar 1918 [
=>
]
Elizabeth Harrington
b. 31 Mar 1844 d. 12 Jan 1929
12
Hiram Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.3]
b. 1864
12
Melinda Jane (Minnie) Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.4]
b. 4 Jun 1866 d. 1935 [
=>
]
12
David J. Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.5]
b. 1873
12
Mary A. Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.6]
b. 21 Jun 1875
12
Robert A. Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.7]
b. Aug 1880
11
David Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5]
b. 1830 d. 31 Jan 1895
Laura Secor
b. 18 Sep 1830 d. 16 Jun 1907
12
James Henry Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.1]
b. 1853 d. 25 Aug 1925 [
=>
]
12
Alice Mary Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.2]
b. 26 Aug 1855 d. 27 Jun 1925 [
=>
]
12
William George Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.3]
b. 7 Mar 1858 d. 1932 [
=>
]
12
Ellen Maria (Nellie) Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.4]
b. 11 Mar 1860 d. 1919 [
=>
]
12
Elizabeth Janet (Lily) Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.5]
b. 20 Apr 1863 d. 21 Jun 1907 [
=>
]
11
Janet Johnston
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6]
b. 1833 d. 28 May 1899
John Chester
b. 1828 d. 15 Mar 1901
12
Andrew C. Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.1]
b. 9 Jul 1856 d. 25 Apr 1929 [
=>
]
12
Thomas Elliot Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.2]
b. 10 Sep 1866
12
Frances Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.3]
b. Dec 1870 d. 1 Aug 1893
12
Georgina Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.4]
b. 20 Jan 1877
12
Elizabeth Helen (Nellie) Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.5]
b. 9 May 1875 [
=>
]
12
John Herbert Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.6]
b. 3 Aug 1872
12
Emma Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.7]
b. 1869
12
William George Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.8]
b. 6 Aug 1859 d. Aft 1901
12
Janet Nettie Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.9]
b. 1863
12
Mary Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.10]
b. 27 Aug 1858 d. 20 May 1927
12
George Chester
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.11]
b. 1864 d. 21 Nov 1872
10
William D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 4 Mar 1802 d. 3 May 1877
Isabella Lowes
b. 24 Sep 1807 d. 20 Jul 1888
11
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.1]
b. 3 Jun 1848 d. 15 Nov 1848
11
David W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2]
b. 22 Dec 1828 d. 26 May 1907
Elizabeth Chester
b. Oct 1829 d. 18 Mar 1894
12
William Wesley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.1]
b. 31 Jan 1858 d. 15 Apr 1935 [
=>
]
12
Emily Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.2]
b. 5 Apr 1864 d. 7 Sep 1905 [
=>
]
12
Sidney Chester Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.3]
b. 7 Jul 1867 d. Aft 1945 [
=>
]
12
Herbert Isaac Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.4]
b. 23 Jan 1872 [
=>
]
12
Frances E. (Fanny) Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.5]
b. 21 Aug 1859 d. 2 Oct 1876
12
Colin Campbell Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.2.6]
b. 23 Jan 1872 d. 3 Oct 1872
11
Richard W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3]
b. Dec 1838 d. 19 Nov 1878
Lillian Alderson
b. Abt 1855
12
Mabel Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.1]
b. 8 Jun 1879
12
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.3.2]
b. 11 May 1877 d. 25 Feb 1882
11
Archibald W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4]
b. 16 Jan 1852 d. 29 Dec 1941
Anne Elizabeth (Libbie) Alderson
b. 1855 d. 12 Feb 1888
12
Alfred James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.1]
b. 7 Nov 1880 d. May 1955 [
=>
]
12
George Edwin Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.2]
b. 20 Sep 1885 d. 6 Feb 1907
12
Nellie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.3]
b. 12 Nov 1882 d. 14 Nov 1966
Sarah Jackson
b. 16 Mar 1857 d. 15 Jun 1955
12
Flora Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.4]
b. 20 Nov 1889 d. 8 May 1955 [
=>
]
12
Walter Opie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.5]
b. 10 Feb 1892 d. 1972 [
=>
]
12
Nathan Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.6]
b. 22 Sep 1894 d. 18 Nov 1915
12
Wilfred G. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.7]
b. 23 Dec 1896 d. Aft 1955
12
Celia Amelia Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.4.8]
b. 1 Jan 1899 d. 30 Mar 1943
11
Joseph W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.5]
b. 23 Nov 1834 d. 25 Nov 1915
Anna Bella Atkinson
b. 1848 d. 17 Dec 1890
12
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.5.1]
b. 17 Sep 1884 d. 20 Feb 1955 [
=>
]
12
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.5.2]
b. 4 Jan 1890 d. 22 Sep 1956
11
William Wesley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6]
b. 1833 d. 6 Apr 1900
Joanne Paterson
b. 1836 d. 14 Oct 1871
12
William W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.1]
b. 2 Jun 1866 d. 17 Mar 1920 [
=>
]
12
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.2]
b. 1860 d. 8 Apr 1870
Amelia H. Patton
b. 5 Jan 1844 d. 28 Nov 1922
12
Lincoln Thomas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.3]
b. 13 Nov 1873 d. 18 Dec 1956 [
=>
]
12
Horace Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.4]
b. 21 May 1877 d. 9 Apr 1963
12
Isabella L. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.5]
b. 6 Jul 1879 d. 26 Aug 1955 [
=>
]
12
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.6]
b. 26 Nov 1881 [
=>
]
12
Heatherington James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.6.7]
b. 13 Dec 1885 d. 25 Apr 1955 [
=>
]
11
Robert W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7]
b. 7 Jun 1843 d. 13 Mar 1916
Hannah Walton
b. 15 Sep 1848 d. 24 May 1882
12
William R. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7.1]
b. 11 Jun 1872 d. 5 Jan 1948 [
=>
]
12
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7.2]
b. 1874 [
=>
]
12
Mary M. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7.3]
b. 3 Jan 1878 d. 2 Nov 1957
12
Annie Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7.4]
b. 16 Sep 1881 d. 19 Jun 1957 [
=>
]
12
Alfred Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7.5]
b. 7 Nov 1880
Elizabeth Jane Miller
b. 18 Aug 1859 d. 3 Feb 1893
12
James Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7.6]
b. 6 Nov 1889 d. 25 Nov 1926
12
Elizabeth Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7.7]
b. 20 Jan 1893 d. 7 Mar 1933
12
Ellen Gertrude Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.7.8]
b. 8 Jul 1891
11
Bridget Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.8]
b. 24 Nov 1830 d. 12 Dec 1910
+
William Carmichael
b. 13 Oct 1832 d. 13 Nov 1910
11
Mary L. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.9]
b. Abt 15 Oct 1836 d. 25 Dec 1895
Beeby Carnaghan
b. 15 Jul 1831 d. 22 Sep 1919
12
Isabella Carnaghan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.9.1]
b. 17 May 1864 d. 9 Jan 1953 [
=>
]
12
Sarah Ida Carnaghan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8.9.2]
b. 10 Oct 1872 d. 19 Jan 1957 [
=>
]
10
John D. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 10 Apr 1804 d. 4 Dec 1888
Mary Walton
b. 1 Nov 1806 d. 29 Dec 1863
11
Jane Wallace Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1]
b. 23 Oct 1829 d. 17 Nov 1904
Robert Loveless
b. 28 Jun 1825 d. 15 Jul 1906
12
Mary Alice Loveless
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.1]
b. 23 Oct 1861 d. 29 Jan 1899 [
=>
]
12
William Loveless
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.2]
b. 5 May 1863 d. 26 Apr 1931 [
=>
]
12
John Wolstenholme Loveless
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.3]
b. 9 Sep 1865 d. 23 Dec 1931 [
=>
]
12
Thomas Thomson Loveless
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.4]
b. 7 Jun 1867 d. 27 Sep 1934 [
=>
]
12
Rev. Elijah Edgar Loveless
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.5]
b. 30 May 1870 d. 10 Mar 1931 [
=>
]
12
Hannah Ellen Loveless
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.6]
b. 2 Jul 1872 d. 16 Mar 1953 [
=>
]
11
David Guy Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2]
b. 25 Dec 1834 d. 5 Dec 1919
Emily Jane Proud
b. 23 Sep 1836 d. 4 Oct 1912
12
John Wesley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.1]
b. 7 Jul 1859 d. Aft 1901 [
=>
]
12
Thomas Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.2]
b. 1861
12
William Norman Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.3]
b. 1862 d. 1 Oct 1939
12
Walton Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.4]
b. 11 Jan 1866 d. 15 Jan 1907 [
=>
]
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.5]
b. 14 Oct 1866 d. 17 Dec 1956 [
=>
]
12
Ruth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.6]
b. 4 Mar 1868 [
=>
]
12
David Lapsley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.7]
b. 25 Nov 1869 d. 21 Apr 1951 [
=>
]
12
Maitland Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.8]
b. 19 Dec 1872 [
=>
]
12
Percival H. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.9]
b. 14 Dec 1886
11
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3]
b. 28 Feb 1831 d. 14 Apr 1875
Rev. Thomas Dudley
b. 1821
12
Mary Jane Dudley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3.1]
b. 3 Mar 1869
12
Hattie Mildred Dudley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3.2]
b. 19 Feb 1872 d. 17 Nov 1944 [
=>
]
11
Thomas Graham Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4]
b. 16 Nov 1842 d. 19 Jun 1933
10
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 10 Jun 1807 d. 9 Dec 1879
John Walton
b. 15 Mar 1799 d. 11 May 1877
11
Ellen Elizabeth Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1]
b. 31 Mar 1825 d. 5 Apr 1888
Francis Thompson
b. 15 Aug 1821 d. 18 Mar 1890
12
William Wallace Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1]
b. 10 Sep 1847 d. 22 Mar 1914 [
=>
]
12
Mary Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.2]
b. 27 Aug 1850 d. 3 Jun 1906
12
David Walton Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.3]
b. 21 Oct 1853 d. Bef 1901 [
=>
]
12
Hannah Janet Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.4]
b. 18 Apr 1855 d. 27 Oct 1912
12
Helen Isabella Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.5]
b. 18 Aug 1858 d. 29 Sep 1932
11
Thomas Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2]
b. 12 Jan 1828 d. 17 Apr 1876
Frances (Fanny) Scott
b. 4 Mar 1835 d. 13 Dec 1907
12
David Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.1]
b. 1855 d. 31 Aug 1866
12
William Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.2]
b. 1856 d. 11 Mar 1857
12
Mary Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.3]
b. Jul 1862 d. Between 1920 and 1930 [
=>
]
12
William Albert Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.4]
b. 11 Sep 1865 d. 1934 [
=>
]
12
John Wallace Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.5]
b. 24 Feb 1860 d. 20 Mar 1932 [
=>
]
12
Thomas A Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.6]
b. 2 Dec 1867 d. 1951 [
=>
]
12
Lavina Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.7]
b. 4 Feb 1858 d. 1923 [
=>
]
12
George Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.8]
b. 1870 d. 17 Dec 1870
12
Frank Edwin Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.9]
b. 10 Aug 1872 [
=>
]
12
Alice Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.10]
b. Abt 1876
11
William Wallace Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3]
b. 10 Mar 1834 d. Bef 1901
Caroline Brooks
b. 17 Jun 1835 d. 10 May 1929
12
Emily Jane Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3.1]
b. 1856
12
John E Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3.2]
b. 13 Nov 1856 d. 28 Dec 1940 [
=>
]
12
William Wallace Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3.3]
b. 1 Apr 1861 d. 17 May 1923 [
=>
]
12
Albert E. Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3.4]
b. 22 Dec 1869
12
David Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3.5]
b. 10 Jun 1867 d. Feb 1964
12
Mary Ida Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3.6]
b. 1864
12
Charles Wesley Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3.7]
b. 13 May 1872
11
John Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4]
b. 29 Oct 1835 d. 27 Jul 1912
Margaret Brooks
b. 14 Mar 1840 d. 12 Aug 1904
12
Annie Maria Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.1]
b. 10 Jul 1858 d. 22 Jun 1935 [
=>
]
12
James Edward Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.2]
b. 20 Jul 1860 d. 14 Aug 1930 [
=>
]
12
Margaret Isabella Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.3]
b. 26 Aug 1870 d. 14 Jun 1954 [
=>
]
12
John Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.4]
b. 13 Jan 1868 d. 8 Jul 1955 [
=>
]
12
Thomas Thomson Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.5]
b. 27 Apr 1873 d. 4 Feb 1953 [
=>
]
12
Lillian Loretta (Lillie) Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.6]
b. 2 Sep 1875 d. 21 Aug 1960
12
Charles Ward Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.7]
b. 2 Sep 1875 d. 22 Mar 1953 [
=>
]
12
Archibald Ashford Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.8]
b. 26 Mar 1878 d. 1 Sep 1961 [
=>
]
12
Lorenza Herbert Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.9]
b. 11 Jun 1880 d. 29 May 1957 [
=>
]
12
Sarah Helen Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.10]
b. 22 Mar 1884 d. 28 Nov 1976
12
Mary Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.11]
b. 1 Sep 1862 d. 2 Jan 1936 [
=>
]
12
Susannah Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.12]
b. 11 Jul 1865 d. 16 Sep 1951 [
=>
]
11
Guy Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.5]
b. 15 Nov 1839 d. 24 May 1910
Isabella McLevin
b. 24 Aug 1839 d. 13 Mar 1912
12
John Wesley Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.5.1]
b. 6 Oct 1876 d. 5 Jan 1947 [
=>
]
12
Archibald A G Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.5.2]
b. 27 May 1878 d. 7 Nov 1941
12
Isabella Mary Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.5.3]
b. 16 Sep 1881 d. 20 Apr 1961
11
Isabella Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6]
b. 25 Jan 1842 d. 18 Feb 1920
William Ezekiel Gooderham
b. 6 May 1843 d. 15 Mar 1917
12
David W Gooderham
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.1]
b. Jan 1870 d. 9 Aug 1875
12
Walter Worts Gooderham
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.2]
b. 5 Aug 1872 d. 14 Mar 1925
12
Mary Henrietta Gooderham
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.3]
b. 27 Sep 1874 [
=>
]
12
Hattie Gooderham
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.4]
b. Jul 1876 d. 20 Aug 1876
12
William Herbert Gooderham
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.5]
b. 17 Mar 1878 [
=>
]
12
Ethel Gooderham
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.6]
b. Jul 1882 d. 23 Aug 1882
12
Ineous E Gooderham
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.7]
b. Jan 1888 d. 27 Apr 1888
11
David Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7]
b. 7 Jun 1830 d. 4 Dec 1850
11
Archibald Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8]
b. 13 Apr 1844 d. 6 Apr 1845
11
Mary Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.9]
b. 23 Jun 1837 d. 20 Mar 1876
+
James Taylor
b. Abt 1835
11
Janet (Jennie) Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10]
b. 7 Jan 1832 d. 14 Aug 1902
William Giles
b. 25 May 1834 d. 30 Mar 1887
12
John Lapsley Giles
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.1]
b. 13 May 1867 d. 12 Feb 1940 [
=>
]
11
Thomson Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11]
b. 17 Oct 1849 d. 1916
Annie Palmer
b. 31 Jul 1856 d. 15 May 1934
12
John Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11.1]
b. 19 Nov 1875 d. 10 Mar 1878
12
Mary Ida Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11.2]
b. 5 Feb 1878 d. Aft 24 Sep 1944
12
Sarah Mabel Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11.3]
b. 1879 d. 3 Jul 1881
12
Edith Louise Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11.4]
b. 31 May 1884 d. 1 Jul 1935 [
=>
]
12
William Gordon Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11.5]
b. 1 May 1887
12
Norman Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11.6]
b. 16 Apr 1890 d. 6 May 1955 [
=>
]
12
Garnet B Walton
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11.7]
b. 11 Apr 1897
10
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.11]
b. 5 Aug 1809 d. 23 Jul 1844
9
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 6 Sep 1747 d. 13 Feb 1837
Anna Little
b. 26 Apr 1765 d. 24 Feb 1855
10
Simon Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 10 Mar 1795 d. 15 Dec 1876
Elizabeth Johnston
b. 21 Jul 1801 d. 15 Aug 1860
11
Robert S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 26 Jan 1827 d. 26 Apr 1907
Mary S. Little
b. 18 Jun 1841
12
Margaret Nichol Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1.1]
b. 26 Sep 1877 d. 26 Nov 1942 [
=>
]
11
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 1828
11
Archibald S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 14 Dec 1829 d. 19 Apr 1892
Mary
b. Abt 1831
12
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.1]
b. Abt 1855
12
Lucy E. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.2]
b. Abt 1857
12
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.3]
b. Abt 1858
12
William J. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3.4]
b. Abt 1860
11
William S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 1832 d. 31 May 1899
11
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 22 Feb 1837 d. 1 Sep 1885
James Elliot
b. 26 Nov 1835 d. 25 Aug 1930
12
John Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.1]
b. 1863
12
Simon Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.2]
b. 1866
12
Robert Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.3]
b. 8 Aug 1868
12
Elizabeth Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.4]
b. 15 Nov 1870 d. 12 Jan 1961 [
=>
]
12
William J. Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.5]
b. 18 Aug 1875
12
Archibald T. Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.6]
b. 30 Sep 1876
12
George E. Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.7]
b. 13 Nov 1879
12
Jane Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.8]
b. 25 Jan 1882 [
=>
]
12
William Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5.9]
b. 22 Aug 1885
11
Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6]
b. 27 Oct 1839 d. 1 Dec 1893
James Chartres Brown
b. 8 Nov 1834 d. 11 Nov 1913
12
Elizabeth Johnston Brown
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.1]
b. 18 Sep 1862 d. 21 Jun 1930 [
=>
]
12
Margaret Brown
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.2]
b. 12 May 1865 [
=>
]
12
John Brown
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.3]
b. 1 May 1868 d. 4 Apr 1939 [
=>
]
12
Simon Thomson Brown
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6.4]
b. 20 Jun 1875 d. 13 Sep 1938 [
=>
]
10
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 31 Aug 1796 d. 13 Dec 1879
Mary Thomson
b. 14 May 1800 d. 14 Dec 1876
11
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 5 Sep 1820 d. 30 May 1876
Margaret Dand
b. 4 Feb 1843 d. 24 Mar 1916
12
Marion Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.1]
b. 1864 d. 6 Mar 1895 [
=>
]
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.2]
b. 1866 d. 1934
12
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.3]
b. 15 Jul 1867 d. 1948
12
William Walter Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.4]
b. 27 Jul 1869 [
=>
]
12
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.5]
b. 15 Oct 1872 [
=>
]
12
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.6]
b. 29 Oct 1873 d. 4 Nov 1956 [
=>
]
12
Eleanor Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1.7]
b. 1874
11
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2]
b. 24 Jun 1822 d. 26 Dec 1880
11
Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 20 Feb 1824
William Nichol
b. Abt 1818
12
Mary Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.1]
b. 27 Jan 1844 d. 23 May 1917 [
=>
]
12
Rachel Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.2]
b. 1 Jan 1846 d. 1 May 1928 [
=>
]
12
Ann Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.3]
b. 1847 [
=>
]
12
David Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.4]
b. 15 Nov 1849 d. 19 Sep 1923 [
=>
]
12
Christopher Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.5]
b. 18 Oct 1852 d. 6 Jun 1933
12
William Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.6]
b. 5 Jan 1855 d. 15 Dec 1916
12
Andrew Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.7]
b. 24 Jan 1856 d. 13 Aug 1926
12
Isabella Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.8]
b. 1860
12
John Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.9]
b. 20 Jan 1863 d. 13 Jan 1926 [
=>
]
12
Jane Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3.10]
b. 18 Sep 1866 d. 18 Aug 1926 [
=>
]
11
Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 30 Sep 1825
Ichabod Vanderburgh
b. Abt 1815 d. 28 Jan 1892
12
William Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.1]
b. Aug 1850 d. 4 Feb 1896
12
Mary Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.2]
b. Abt 1853
12
Christopher Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.3]
b. 1855
12
Bradley Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.4]
b. Abt 1857 [
=>
]
12
Elizabeth Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.5]
b. Abt 1859
12
Annie Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4.6]
b. Abt 1866
11
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 19 Apr 1827 d. 21 Jan 1894
Ann Hudson
b. 1841 d. Bef 1891
12
Annie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.1]
b. 1864
12
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.2]
b. 1872
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5.3]
b. 1874
11
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6]
b. 14 Feb 1829
+
Charlotte Thompson
b. 1832
11
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7]
b. 14 Feb 1829 d. 11 Jun 1906
Mary Ross
b. 9 Oct 1836 d. 11 Nov 1913
12
James Ross Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.1]
b. 14 Nov 1867 d. 1953 [
=>
]
12
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.2]
b. 5 Jan 1870 d. 1950
12
Susannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.3]
b. 23 Aug 1874 d. 1950 [
=>
]
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.4]
b. 1862 d. 1 Jun 1926 [
=>
]
12
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.5]
b. 20 Sep 1862 d. 1951
12
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.6]
b. 11 Aug 1872
12
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7.7]
b. Jan 1878 d. 15 Mar 1882
11
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8]
b. 22 Mar 1832 d. 27 Feb 1911
Charlotte Ross
b. 10 Jun 1839 d. 16 Aug 1905
12
Susan Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.1]
b. 6 Jun 1863 d. 11 Feb 1920 [
=>
]
12
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.2]
b. 1867
12
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.3]
b. 10 Sep 1868 d. 19 Aug 1932 [
=>
]
12
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.4]
b. 7 Jan 1871 d. 29 Nov 1937
12
Flora Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.5]
b. 1873 [
=>
]
12
Charlotte Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.6]
b. 14 Mar 1876 [
=>
]
12
Janet F. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8.7]
b. 1878
11
Frances Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9]
b. 23 Dec 1838
James Thompson
12
Fanny Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9.1]
11
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.10]
b. 20 Dec 1840 d. 22 Jan 1893
11
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.11]
b. 23 Feb 1843 d. 17 May 1917
11
Simon Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.12]
b. 22 Mar 1836 d. 21 Mar 1889
Sarah Scott
b. 1836 d. 2 Apr 1921
12
Christopher William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.12.1]
b. 22 Jun 1867 [
=>
]
12
Frances A Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.12.2]
b. 1871
12
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.12.3]
b. 1869
11
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.13]
b. 1 May 1834 d. Bef 1881
James Main
b. 26 Aug 1827
12
Charles Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.13.1]
b. 1859
12
Mary Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.13.2]
b. 1861
12
Janet Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.13.3]
b. 1863
12
Ann Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.13.4]
b. 20 Nov 1864
12
Elizabeth Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.13.5]
b. 22 Nov 1866
12
Christopher Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.13.6]
b. 11 Mar 1870 [
=>
]
10
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 6 Oct 1797 d. 15 Dec 1866
Mary Murray
b. 1804 d. 27 Dec 1883
11
Thomas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1]
b. 28 Feb 1831 d. 4 Jan 1877
Agnes Dalgleish
b. 1845 d. 21 Mar 1877
12
Mary Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1.1]
b. 1877 d. 21 Jul 1955
Euphemia Allan
12
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.1.2]
b. 1 Aug 1854
11
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2]
b. 15 Dec 1832 d. Aft 4 Apr 1881
Elizabeth Richardson
b. 27 Jan 1839 d. Aft 1881
12
Maryanne Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.2.1]
b. 1860
11
Simon Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3]
b. 17 Aug 1834 d. 2 Dec 1885
Janet Thomson
b. 2 Dec 1837 d. 16 May 1921
12
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.1]
b. 10 Jan 1873 d. 18 Jun 1948 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.2]
b. 14 Nov 1862 d. 4 Feb 1864
12
David Simon Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.3]
b. 4 Jun 1864 d. 29 Mar 1937
12
Jane Jemmina Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.4]
b. 13 Mar 1869 d. 30 Dec 1951
12
Thomas Telford Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.5]
b. 12 Dec 1870 d. 9 May 1948
12
Margaret E. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.6]
b. 16 Feb 1875 d. 6 May 1949
12
Jenett Rabina Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.7]
b. 10 Jul 1879 d. 24 May 1963
12
William S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.3.8]
b. 7 Nov 1866 d. 7 Mar 1954
11
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4]
b. 5 Aug 1836 d. Aft 4 Apr 1881
Mary Lattimer
b. 1845 d. Aft 4 Apr 1881
12
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1]
b. 24 Nov 1863 d. 25 Nov 1935 [
=>
]
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.2]
b. 9 Jul 1866
12
Christopher John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3]
b. 29 Mar 1872 d. 1909 [
=>
]
12
Thomas Telfer Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4]
b. 3 Mar 1874 d. 31 Jan 1942 [
=>
]
12
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.4.5]
b. 29 Nov 1880 d. 11 Jun 1973 [
=>
]
11
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.5]
b. 19 Dec 1838 d. Aft 4 Apr 1881
+
Elizabeth
b. Abt 1847
11
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6]
b. 6 Mar 1841 d. Jul 1918
John Irving
b. 1853 d. 4 Jul 1928
12
Janet Ann Irving
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.1]
b. 29 Apr 1874 d. Oct 1961
12
William Irving
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.2]
b. 1875
12
Mary Isabella Irving
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.3]
b. 1877
12
Helen Irving
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.4]
b. 1879
12
Thomas Telfer Irving
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.5]
b. 1882 d. 1958
12
Scott Irving
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.6]
b. 1883
12
Elizabeth Irving
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.6.7]
b. 28 Feb 1886
11
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.7]
b. 10 Apr 1843 d. 26 Feb 1845
11
Andrew George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8]
b. 1846 d. 8 Oct 1889
Isabella Hood
b. 1847 d. 29 Mar 1922
12
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8.1]
b. 1877 d. Aft 21 Apr 1922
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.8.2]
b. 1879 d. 29 Mar 1887
11
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.9]
b. 1830
11
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.3.10]
b. 1848
10
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 18 Jul 1799 d. 23 Sep 1882
Jane (Jean) Edgar
b. 7 Apr 1798 d. 10 Apr 1874
11
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1]
b. 22 Oct 1826 d. 13 Dec 1920
Jessie Park
b. Abt 1827 d. 16 Jan 1901
12
David Park Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.1]
b. 23 Jan 1850 d. 13 Aug 1947 [
=>
]
12
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.2]
b. Abt Jun 1851
12
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.3]
b. 12 Sep 1853
12
Robert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.4]
b. 22 May 1855 d. 23 May 1921 [
=>
]
12
Christine Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.5]
b. 17 Apr 1857 d. Bef 1940 [
=>
]
12
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.6]
b. 16 Jul 1861 d. 15 Apr 1957 [
=>
]
12
Donald Campbell Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.7]
b. 11 Jun 1864 d. 14 Apr 1927
12
Jane Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.8]
b. 10 Jul 1866 d. 23 Nov 1874
12
Jessie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.9]
b. 2 Aug 1869 d. 19 Aug 1940
12
James Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.1.10]
b. 16 Nov 1873 d. Abt 1950
11
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2]
b. 8 Apr 1828 d. 19 Mar 1913
Jane Allan
b. 18 Jan 1849 d. 17 Nov 1925
12
Jane Edgar Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.1]
b. 28 Feb 1869 d. 4 Apr 1917
12
Catherine Murray Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.2]
b. 1 Feb 1871 d. 1 Jan 1950 [
=>
]
12
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.3]
b. 20 Nov 1872 d. 31 Jan 1945 [
=>
]
12
David Edgar Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.4]
b. 1 Dec 1874 d. 7 Nov 1933 [
=>
]
12
John Allan Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.5]
b. 8 Dec 1876 d. 7 Jan 1942 [
=>
]
12
Archibald Robert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.6]
b. 29 Dec 1878 d. 26 Nov 1954 [
=>
]
12
William James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.7]
b. 22 Mar 1881 d. 5 Feb 1963 [
=>
]
12
Margaret Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.8]
b. 16 Feb 1883 d. 21 May 1965 [
=>
]
12
Elizabeth Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.9]
b. 18 Apr 1885 d. 11 May 1964 [
=>
]
12
Martha Mowat Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.10]
b. 21 Feb 1887 d. 11 Dec 1956 [
=>
]
12
George Grant Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.11]
b. 1 Feb 1889 d. 3 Apr 1965 [
=>
]
12
Simon Gray Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.2.12]
b. 30 Oct 1891 d. 19 Feb 1977 [
=>
]
11
Robert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3]
b. 26 Mar 1830 d. 20 Jan 1879
Mary Cameron
b. 29 Jun 1847 d. 25 Oct 1935
12
Duncan Cameron Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.1]
b. 25 Sep 1868 d. 7 Jun 1954 [
=>
]
12
Jane Robena Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.2]
b. 28 Feb 1870 d. 9 Feb 1947 [
=>
]
12
David Edgar Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.3]
b. 13 Feb 1872 d. Bef 1879
12
William John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.4]
b. 20 Feb 1874 d. 17 Nov 1956 [
=>
]
12
Margaret Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.5]
b. 25 Feb 1875 d. 20 Feb 1939 [
=>
]
12
Robina Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.3.6]
b. 17 Mar 1879 d. 24 Dec 1952 [
=>
]
11
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4]
b. 2 Dec 1837 d. 16 May 1921
Simon Thomson
b. 17 Aug 1834 d. 2 Dec 1885
12
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.1]
b. 10 Jan 1873 d. 18 Jun 1948 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.2]
b. 14 Nov 1862 d. 4 Feb 1864
12
David Simon Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.3]
b. 4 Jun 1864 d. 29 Mar 1937
12
Jane Jemmina Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.4]
b. 13 Mar 1869 d. 30 Dec 1951
12
Thomas Telford Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.5]
b. 12 Dec 1870 d. 9 May 1948
12
Margaret E. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.6]
b. 16 Feb 1875 d. 6 May 1949
12
Jenett Rabina Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.7]
b. 10 Jul 1879 d. 24 May 1963
12
William S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.4.8]
b. 7 Nov 1866 d. 7 Mar 1954
11
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5]
b. 30 Nov 1832 d. 5 Feb 1916
Elizabeth Graham
b. 24 Nov 1839 d. 21 Mar 1902
12
Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.1]
b. 5 Jul 1861 d. Abt 1949 [
=>
]
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.2]
b. 13 Dec 1862 [
=>
]
12
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.3]
b. 5 Nov 1864 d. 28 May 1942 [
=>
]
12
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.4]
b. 15 Mar 1866 d. Abt 1940 [
=>
]
12
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.5]
b. 8 Dec 1867 d. 28 Sep 1951 [
=>
]
12
Margaret Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.6]
b. 23 Aug 1869 d. 25 Oct 1917
12
Christine Little Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.7]
b. 19 Apr 1871 [
=>
]
12
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.8]
b. 13 Jan 1873 d. Abt 1947 [
=>
]
12
Mary Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.9]
b. 17 Jun 1874 d. Abt 1956 [
=>
]
12
Georgina Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.10]
b. 28 Dec 1875 d. Abt 1962
12
Robert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.11]
b. 12 Jan 1878 d. 26 Feb 1954
12
Agnes Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.12]
b. 20 Aug 1880 d. 13 Jul 1950
12
John Charles Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.13]
b. 26 Jun 1882 [
=>
]
12
Effie Rae Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.5.14]
b. 3 Oct 1885 d. 13 Jul 1972
11
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.6]
b. 25 Dec 1835 d. Bef 7 Jun 1841
11
Anne Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.7]
b. 27 Aug 1840
11
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8]
b. 18 Feb 1843 d. 9 Aug 1908
Margaret Dunn
b. 1 Jun 1846 d. 4 Mar 1915
12
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8.1]
b. Abt Feb 1871 d. 28 Oct 1953
12
Thomas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8.2]
b. 28 Nov 1872 d. 20 Mar 1940
12
Margaret Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.8.3]
b. 28 Jan 1875 d. 26 Oct 1958 [
=>
]
11
Margaret Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9]
b. 28 Sep 1845 d. 28 Jun 1933
Daniel Walker
b. 12 May 1841 d. 24 Jul 1918
12
Edga Jane Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9.1]
b. 24 Sep 1869 d. 24 May 1938 [
=>
]
12
George Daniel Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9.2]
b. 26 Apr 1871 d. 28 Jan 1942 [
=>
]
12
Janet Maria Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9.3]
b. 21 Jun 1873 d. 17 May 1945 [
=>
]
12
David Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9.4]
b. 24 Aug 1875 d. 30 Dec 1951 [
=>
]
12
Edmund Joseph Wilfred Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9.5]
b. 30 Sep 1878 d. 11 Aug 1958 [
=>
]
12
Archibald Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9.6]
b. 17 Jun 1881 d. 10 Nov 1954
12
Margaret Ida Maud Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.9.7]
b. 5 Dec 1883 d. 20 Sep 1953 [
=>
]
11
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10]
b. 16 Dec 1823 d. 29 Mar 1907
Adeline Elliott
b. Abt 1831 d. 25 Oct 1898
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.1]
b. 31 Mar 1853 d. Abt 1853
12
Annie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.2]
b. 15 May 1854 d. 28 Dec 1941 [
=>
]
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.3]
b. 8 Jun 1856 d. 7 Apr 1939 [
=>
]
12
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.4]
b. 1 Mar 1859 d. 19 Jan 1929 [
=>
]
12
Fanny Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.5]
b. 8 Sep 1861 d. 17 Sep 1942 [
=>
]
12
Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.6]
b. 16 Apr 1864 d. 8 Jun 1927 [
=>
]
12
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.7]
b. 20 Feb 1867 d. Abt Sep 1940 [
=>
]
12
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.8]
b. 25 Feb 1870 d. 27 Apr 1938
12
Mary Adeline Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.9]
b. 1 Nov 1872 d. 26 Aug 1953
12
Robert Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.10]
b. 1 Nov 1875 d. 22 Mar 1919
12
John Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.4.10.11]
b. 17 Apr 1879 d. 8 Oct 1936 [
=>
]
10
Janet (Jane) Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 18 Jul 1801 d. 27 Feb 1874
George Harvey
b. 26 Feb 1798 d. 7 Nov 1869
11
Margaret Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.1]
b. 8 Nov 1829 d. 9 Jan 1849
11
James Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.2]
b. 3 Oct 1831 d. 5 Jan 1895
Elizabrth McNab
b. Jun 1840
12
George Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.1]
b. 1869
12
Peter Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.2]
b. 1870
12
John James Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.2.3]
b. 25 May 1874
11
Anne Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.3]
b. 11 Mar 1834 d. 6 Jul 1906
11
George Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.4]
b. 11 Aug 1836 d. 21 Aug 1905
Mary Wilson
b. 1838 d. 26 Jul 1903
12
John Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.4.1]
b. 1876
12
Thomas Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.4.2]
b. 2 Dec 1878 d. 24 Feb 1950 [
=>
]
12
Mary Elizabeth Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.4.3]
b. 1881
11
Elizabeth Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.5]
b. 4 Mar 1839 d. 14 Feb 1894
Frank Dickson
b. 1833 d. 15 Feb 1909
12
Margaret Dickson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.5.1]
b. 1861
12
Frank Dickson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.5.2]
b. 24 Dec 1863 d. 1953
11
William Harvey
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.5.6]
b. 22 Dec 1843 d. 22 Sep 1901
10
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 22 Apr 1803 d. 18 Oct 1823
James Glendinning
b. 13 Oct 1800 d. 6 Nov 1855
11
John Glendinning
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 6 May 1821 d. 14 Apr 1822
10
Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 27 May 1805 d. 2 Oct 1879
+
Thomas Telfer
b. 1788 d. 21 Oct 1830
10
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 8 Nov 1807
10
Bridget Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.9]
b. 8 May 1809
10
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.10]
b. 4 Feb 1811
Margaret Anderson
b. 29 Apr 1753 d. 23 Jun 1789
10
Joan Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.11]
b. 14 Jan 1776
+
Walter Clark
10
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.12]
b. 19 Jul 1780
10
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.13]
b. 19 Jul 1780 d. 11 May 1872
10
Anne Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.14]
b. 3 Dec 1782 d. Abt 1782
10
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.15]
b. 18 Apr 1785 d. 22 Nov 1819
Elizabeth
b. Abt 1788
11
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.15.1]
11
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.15.2]
b. Aft 1806
10
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.2.16]
b. 18 Apr 1789 d. Abt 1789
9
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 7 May 1749 d. 22 Jan 1819
Elizabeth McKay
b. 1762 d. 22 Apr 1817
10
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 25 Apr 1782 d. Abt 1850
Sarah Smith
b. Abt 1790 d. 15 Oct 1879
11
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 1814
Sophia Prout
b. 28 Sep 1821
12
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.1]
b. 1845
12
Marshall Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.2]
b. 1848
12
Edward Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.3]
b. 1847
12
Adolphus Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.4]
b. 17 Mar 1851 d. 19 Oct 1926 [
=>
]
12
Bessie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1.5]
b. 1857
11
Archibald C. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2]
b. 1815 d. 29 Oct 1887
Saphronia Maria Strohn
b. 13 Aug 1831 d. 28 Jul 1901
12
Florence M. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2.1]
b. 14 Feb 1852 [
=>
]
12
Sarah Emma Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2.2]
b. 25 Feb 1856 d. 1929 [
=>
]
12
Cora Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2.3]
b. 1858
12
George Manley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2.4]
b. 1859 d. 25 Apr 1914 [
=>
]
12
Frank Russell Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2.5]
b. 1862 d. 19 May 1914 [
=>
]
12
Hiram Benson Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2.6]
b. 1864
12
Harry Frank Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2.7]
b. 1866
12
Nellie Cora Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2.8]
b. 1874 [
=>
]
11
Sophia Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.3]
b. 1818
John Prout
b. 1 Oct 1810 d. 7 Dec 1894
12
William Andrew Prout
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.3.1]
b. Jul 1846 [
=>
]
12
Isabella Prout
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.3.2]
11
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 1820 d. 9 Feb 1856
John Charles Michell
b. 5 Jan 1813 d. 9 Jun 1873
12
Tobias Michell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.4.1]
b. 1850 d. 14 Nov 1898 [
=>
]
12
Isabella Michell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.4.2]
b. 1854 d. 9 Feb 1877 [
=>
]
12
Alfred Tracy Michell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.4.3]
b. 23 Sep 1844 [
=>
]
12
Sophia Ann Michell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.4.4]
b. 1846 d. 1880
11
Susan Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.5]
b. 1826 d. 21 Oct 1912
John Sleigh
b. 1826 d. 21 Sep 1899
12
Minnie M. Sleigh
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.5.1]
b. 1864
11
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.6]
b. 1832 d. 19 Mar 1897
John Ritchie
b. 1826 d. 1868
12
Sophia Ann Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.6.1]
b. 19 Aug 1864 d. 23 Feb 1940 [
=>
]
12
Flora (Sarah) Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.6.2]
b. 1866 [
=>
]
12
Adele Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.6.3]
b. 1868 d. 10 Feb 1890
12
Andrew W. Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.6.4]
b. 1862 d. 30 Jan 1874
12
Oscar Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.6.5]
b. Abt 1860 d. 1868
11
Charles Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.7]
b. Abt 1827 d. 17 May 1897
Elizabeth Locke
b. 1834
12
Martha Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.7.1]
b. 1859
12
Samuel Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.7.2]
b. Abt 1873
10
Mary Catherine Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 7 Dec 1783 d. 20 Aug 1827
John Scarlett
b. 30 Jul 1777 d. 31 Jul 1865
11
Archibald Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. 1813
11
Mary Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2]
b. Jul 1815 d. 26 Nov 1884
Rev. Robert Harding
b. 4 Feb 1804 d. 2 Sep 1892
12
Mary Elizabeth Harding
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2.1]
b. 10 Mar 1840
12
Prudence Sarah Harding
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2.2]
b. 20 May 1849 d. 1 Jun 1904
12
Frances ( Fanny) Louisa Harding
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2.3]
b. 16 Apr 1851 d. 1935
12
Robert St. George Harding
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2.4]
b. 18 Oct 1853
12
John Edward Henry. Harding
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2.5]
b. Jan 1854 d. 22 May 1881
11
Edward Christopher Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.3]
b. 1811 d. 20 Jan 1894
11
John Archibald Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4]
b. 1819 d. 30 Oct 1897
Louisa Henriod
b. 4 Jul 1820 d. 28 Dec 1883
12
John Henry Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4.1]
b. 1846 d. 1903 [
=>
]
12
Isabella Mary Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4.2]
b. 4 Sep 1849 d. 15 Feb 1924
12
Catherine Elizabeth Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4.3]
b. 29 Jan 1851 d. 4 Mar 1937
12
Edward William Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4.4]
b. 22 Sep 1854 d. 2 Jan 1923 [
=>
]
12
Robert Arthur Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4.5]
b. 23 Feb 1857 d. 2 Aug 1909 [
=>
]
12
Joseph George Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4.6]
b. 1860 d. 14 Jan 1913
12
James Alfred Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4.7]
b. 4 Jun 1861 d. 11 Jan 1917
12
Frank Christopher Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4.8]
b. 13 Jul 1866 d. 2 Jan 1872
11
St. George Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.5]
b. 1820 d. 1 Oct 1900
Alice Jane Lee
b. 31 Jan 1829 d. 22 May 1911
12
Clark Edward Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.5.1]
b. 21 Dec 1859 d. 1924 [
=>
]
12
Louisa Mary Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.5.2]
b. 4 Nov 1861 d. 1861
12
James Rolph Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.5.3]
b. 2 Mar 1863 d. 1 Jan 1942 [
=>
]
12
Alice Maude Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.5.4]
b. 1865 d. 1941
12
Mary Elizabeth Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.5.5]
b. 23 Nov 1869 d. 9 Apr 1904
12
Samuel Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.5.6]
11
Elizabeth Maria Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.6]
b. 1823 d. 23 Aug 1837
11
Samuel Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.7]
b. 20 Sep 1826 d. 17 Dec 1880
+
Sarah Fisher
b. 19 Dec 1816 d. 6 Apr 1889
Harriet Emma Fisher
b. 8 Aug 1827 d. 15 Dec 1871
12
Emma Elizabeth Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.7.1]
b. 23 Aug 1857 d. Aug 1871
12
Ada Mary Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.7.2]
b. 23 Nov 1859 d. 18 Aug 1934
12
John Edwin Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.7.3]
b. 28 Feb 1861 d. 18 Oct 1938 [
=>
]
12
Laura Sarah Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.7.4]
b. 2 Feb 1863 d. 3 Jun 1884
12
Ellen Louisa Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.7.5]
b. 2 Jan 1866 d. 30 Mar 1951 [
=>
]
12
Mary Harriet Scarlett
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.7.6]
b. 1 May 1869 d. 21 Mar 1946 [
=>
]
10
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 3 Sep 1785 d. 13 Jul 1871
James Elliott
b. 2 Jun 1773 d. 11 Apr 1849
11
Elizabeth Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 11 Jul 1803 d. 1875
John B Willer
b. 1786 d. 1868
12
Thomas Willer
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.1]
b. 1830 [
=>
]
12
William Willer
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.2]
b. 1838 d. 3 May 1894 [
=>
]
12
Hugh Willer
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.3]
b. Dec 1841 d. 17 Jun 1916 [
=>
]
12
Mary M Willer
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.4]
b. 1843 d. 1878
12
Ged Willer
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.5]
b. 1833
12
Hannah Willer
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1.6]
b. 10 Mar 1846 [
=>
]
11
Janet Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 20 Jun 1805 d. 14 Jan 1863
Robert Oliver
b. 6 Mar 1792 d. 6 Oct 1870
12
Isabel Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.1]
b. 12 Jan 1835 d. 1914 [
=>
]
12
Francis Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.2]
b. 1826
12
James Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.3]
b. 1828
12
Elizabeth Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.4]
b. 13 Nov 1831 d. 29 Aug 1903 [
=>
]
12
Janet Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.5]
b. 10 Nov 1836 [
=>
]
12
Margaret Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.6]
b. 1 Feb 1839 d. 28 Jun 1923 [
=>
]
12
Jane Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.7]
b. 15 Dec 1841 d. 10 Oct 1920 [
=>
]
12
Robert Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.8]
b. 1847 [
=>
]
12
Agnes Nancy Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2.9]
b. 4 Oct 1830 d. 4 May 1907 [
=>
]
11
John Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 23 Jan 1807 d. 24 Jan 1887
Jane Tacket
b. 1814 d. 19 Mar 1860
12
James Elliot
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.1]
b. 26 Nov 1835 d. 25 Aug 1930 [
=>
]
12
George Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.2]
b. 16 May 1841 d. 18 Mar 1926
12
Janet Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.3]
b. 11 Apr 1843 d. Mar 1927
12
Christina Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.4]
b. 23 Apr 1845
12
Margaret Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.5]
b. 6 Apr 1847
12
Hellen Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.6]
b. 29 Nov 1848
12
Mary Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.7]
b. 18 Oct 1851
12
John Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3.8]
b. 18 Dec 1854 d. 13 Sep 1944 [
=>
]
+
Jeanette Jackson
b. 15 Jan 1827
+
Mary Philips
b. 1832 d. 27 Jun 1884
11
Archibald Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 18 Jul 1810 d. 28 May 1824
11
Mary Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 8 Jul 1813 d. 18 Sep 1887
John Ruddick
b. 21 Jun 1802 d. 15 Jul 1874
12
Ann Ruddick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.1]
b. 7 Oct 1833 d. 10 Jun 1924 [
=>
]
12
Jane Ruddick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.2]
b. 30 Nov 1835 d. 2 Apr 1897 [
=>
]
12
Lawrence Ruddick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.3]
b. 16 Mar 1836 d. 11 Apr 1922 [
=>
]
12
Elizabeth Jane Ruddick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.4]
b. 14 Mar 1841 d. 18 Feb 1891 [
=>
]
12
James Ruddick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.5]
b. 18 Jun 1843 d. 17 Sep 1924 [
=>
]
12
Janet Ruddick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.6]
b. 25 Apr 1846 [
=>
]
12
Ellen Ruddick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.7]
b. 25 Aug 1848 d. 23 Feb 1928 [
=>
]
12
John Archibald Ruddick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5.8]
b. Aug 1853
11
Matilda Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6]
b. 27 Mar 1816 d. Aft 1881
Samuel Wilson
b. 1816 d. 18 Mar 1881
12
William E. Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.1]
b. 10 Nov 1839 d. 2 Nov 1918 [
=>
]
12
George Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.2]
b. 25 Oct 1844 d. 1923 [
=>
]
12
Samuel Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.3]
b. 1847 d. 1901
12
Janet Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.4]
b. 1856
12
James Wilson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6.5]
b. 1841 d. 1923
11
Hugh Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7]
b. 28 Jan 1819 d. 13 Apr 1907
+
Jane Reeve
b. 1821 d. 20 Nov 1843
Georgina Park
b. 11 Jun 1820 d. 2 Feb 1909
12
Matthew Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.1]
b. 23 Nov 1848 d. 28 Jan 1928 [
=>
]
12
William P. Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.2]
b. Apr 1847 d. 24 Mar 1859
12
James Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.3]
b. 1851 d. 11 Jun 1856
12
Andrew Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.4]
b. 1854 d. 26 Jun 1856
12
Jean Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.5]
b. 1860 d. 1953 [
=>
]
12
Janet Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.6]
b. 1862 d. 26 Apr 1890
12
Margaret Lillian Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7.7]
b. 11 Nov 1865 d. 1956 [
=>
]
11
Margaret Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.8]
b. 25 Oct 1821
+
James Brown
b. 1817
11
Archibald Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.9]
b. 24 Jul 1824 d. 25 Mar 1904
Margaret Allison
b. 16 Jun 1829 d. 12 Jul 1912
12
Janet Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.9.1]
b. 1850 [
=>
]
12
Mary Jane Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.9.2]
b. 1852 d. 14 Dec 1893 [
=>
]
12
James F. Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.9.3]
b. 18 Sep 1863 [
=>
]
12
Flora Elliott
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.9.4]
b. 1863
10
Elizabeth McKay Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. 5 Jun 1787 d. 24 Nov 1873
Thomas Forfar
b. 29 Jun 1760 d. 6 Apr 1825
11
Mary Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 14 Jan 1808 d. 23 Jul 1864
David Walker
b. May 1800 d. 29 Nov 1866
12
Barbara Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.1]
b. 9 Apr 1846 d. 4 Jan 1924 [
=>
]
12
Ann Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.2]
b. 1824 [
=>
]
12
Andrew Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.3]
b. 21 Nov 1826 d. 17 Nov 1904 [
=>
]
12
Ellen Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.4]
b. Nov 1827 d. 11 Feb 1893 [
=>
]
12
Thomas Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.5]
b. 1832 [
=>
]
12
Elizabeth Ann Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.6]
b. May 1837 d. Aug 1875 [
=>
]
12
Jane Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.7]
b. 1842 [
=>
]
12
David George Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1.8]
b. May 1843 d. 28 Aug 1865
11
Archibald Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2]
b. 30 Sep 1809 d. 22 Jun 1882
Elizabeth White
b. 25 Sep 1811 d. 29 Oct 1884
12
Thomas Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.1]
b. 22 Jun 1834 d. 25 Sep 1932 [
=>
]
12
William Archibald Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.2]
b. Mar 1838 d. 6 Apr 1874 [
=>
]
12
Joseph L. Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.3]
b. 10 Mar 1839 d. 10 Nov 1919 [
=>
]
12
Anne Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.4]
b. 3 Jun 1841 d. 1931 [
=>
]
12
Jane Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.5]
b. 1844
12
Elizabeth Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.6]
b. Sep 1845 d. 8 Jul 1867 [
=>
]
12
Bella Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.7]
b. 1847
12
Archibald A. Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.8]
b. 13 Apr 1849 d. 1922 [
=>
]
12
Sarah Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2.9]
b. 1857 d. 7 Apr 1862
11
Helen Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
b. 1 Jan 1812 d. 6 Apr 1897
+
James Bowes
b. 1799 d. 29 Dec 1873
John Pilkey
b. 1806 d. Aft 1900
12
Edward (Ned) Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.1]
b. 2 Sep 1832 d. 2 Jun 1913 [
=>
]
12
Mary Anne Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.3.2]
b. 23 Aug 1834 d. 2 Feb 1918 [
=>
]
11
Jane Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4]
b. 13 May 1813 d. 9 Jun 1894
Charles Pilkey
b. 8 Sep 1808 d. 27 Dec 1883
12
Archibald Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.1]
b. 27 Apr 1833 d. 1906 [
=>
]
12
Peter Thomas Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.2]
b. 1836 d. 4 Apr 1860 [
=>
]
12
Rev. John C. Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.3]
b. 7 Mar 1838 d. 11 Apr 1914 [
=>
]
12
Joseph Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.4]
b. 1 Apr 1840 d. 22 May 1908 [
=>
]
12
Charles Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.5]
b. 22 Aug 1843 d. 31 May 1857
12
William Charles Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.6]
b. 6 Mar 1846 d. 25 Jul 1924 [
=>
]
12
Elizabeth Jane Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.7]
b. 23 Nov 1848
12
Thomas Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.8]
b. 27 Aug 1850 d. 10 Jul 1936 [
=>
]
12
David Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.9]
b. 14 Jan 1853 d. 26 May 1933 [
=>
]
12
Agnes Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.10]
b. 6 May 1855 d. 23 Jul 1941 [
=>
]
12
Charles Henry Pilkey
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4.11]
b. 28 May 1857 d. 8 Jul 1938 [
=>
]
11
William Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 27 Apr 1817 d. 23 May 1888
Agnes McLevin
b. 21 Dec 1817 d. 11 Aug 1896
12
Catherine Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.1]
b. 12 Oct 1844 d. 24 Mar 1887 [
=>
]
12
Archibald W. Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.2]
b. 3 Mar 1849 d. 12 Feb 1907 [
=>
]
12
Thomas Frederick Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.3]
b. 22 Sep 1842 d. Bef 1911 [
=>
]
12
Elizabeth Jane Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.4]
b. 28 Feb 1847 d. 26 Dec 1849
12
Mary Ann Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.5]
b. 9 Mar 1851 d. 27 Aug 1910 [
=>
]
12
Elizabeth Thomson Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.6]
b. 20 Mar 1854 d. 1935 [
=>
]
12
Sarah Helen Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.7]
b. 13 Jul 1856
12
William Henry Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.8]
b. 24 Jul 1858 d. 22 Oct 1863
12
Catherine Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5.9]
b. 27 Sep 1840 d. 17 Aug 1842
11
Thomas Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.6]
b. 27 Feb 1819 d. 10 Jan 1892
Elizabeth Johnston
b. 1826 d. 18 Feb 1897
12
Helen Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.6.1]
b. Aft 1845
12
Jennie Isabelle Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.6.2]
b. 29 Mar 1866 [
=>
]
12
Florence Elizabeth Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.6.3]
b. 1867 [
=>
]
+
Elizabeth McLevin
11
John William Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.7]
b. 23 Apr 1821 d. 8 Feb 1881
Jane Cobbledick
b. 10 Sep 1825 d. 28 Feb 1903
12
William Thomas Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.7.1]
b. 25 Nov 1852 d. 6 Apr 1895 [
=>
]
12
George Henry Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.7.2]
b. Nov 1854 d. 15 Jun 1879
12
Dr. James Edward Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.7.3]
b. 5 Feb 1857 d. 21 Sep 1945 [
=>
]
12
Charles E. Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.7.4]
b. 19 Oct 1859 d. 28 May 1915 [
=>
]
11
Elizabeth Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8]
b. 23 May 1823 d. 1859
Richard Cooper
b. 1822 d. 1862
12
William Cooper
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8.1]
b. 1842
12
Sophia Cooper
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8.2]
b. 1845
12
Elizabeth Cooper
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8.3]
b. 6 Jul 1846 d. 1938 [
=>
]
12
Frances Cooper
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8.4]
b. 1849 d. Aft 1911 [
=>
]
12
Sarah Cooper
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8.5]
12
Helen Cooper
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8.6]
b. 11 May 1857 d. 11 Jan 1930 [
=>
]
12
Agnes Cooper
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8.7]
b. 25 Apr 1860 [
=>
]
11
David Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.9]
b. 28 Mar 1825 d. 31 Oct 1901
Elizabeth Galbraith
b. 16 May 1835 d. 11 Feb 1883
12
Robert Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.9.1]
b. 1 Dec 1855 d. 9 Feb 1941
12
Elizabeth Ann Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.9.2]
b. 5 Aug 1857 d. 22 Nov 1882
12
Thomas James Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.9.3]
b. 1860 d. 6 Jul 1933 [
=>
]
12
Sarah Maria Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.9.4]
b. 12 Oct 1863 d. 23 Dec 1934
12
Lavina Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.9.5]
b. 15 Jul 1866 [
=>
]
12
Lena Maude Forfar
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.9.6]
b. 7 Nov 1877 d. 26 Dec 1953 [
=>
]
James Moyle
b. 1800
11
Alexander B Moyle
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.10]
b. 1830 d. 12 Dec 1864
11
Letitia Moyle
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11]
b. 1831 d. 11 Dec 1891
John Malcolm
b. 30 Jun 1830 d. 24 Aug 1865
12
Archibald Malcolm
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11.1]
b. 19 Apr 1852 d. 5 Nov 1910 [
=>
]
12
Elizabeth Margaret Malcolm
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11.2]
b. 27 Jan 1854 d. 19 Aug 1919 [
=>
]
12
James Thomas Bain Malcolm
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11.3]
b. 30 Nov 1855 d. 21 Jan 1937 [
=>
]
12
Christina Grant Malcolm
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11.4]
b. 13 Dec 1857 d. 28 Apr 1891
12
John Armour Malcolm
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11.5]
b. 2 Dec 1859 d. 1935
12
Andrew William Malcolm
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11.6]
b. 26 Oct 1861 d. 12 Mar 1914 [
=>
]
12
Robert Alexander Malcolm
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11.7]
b. 25 Jan 1864 d. 1933
10
Helen Eleanor Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 30 Apr 1789 d. 30 Mar 1872
James Fenwick
b. 8 Mar 1777 d. 8 Jul 1862
11
William Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.1]
b. 1809 d. 25 Nov 1835
11
Mary Anne Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.2]
b. 1811
Rev. Duncan McMillan
b. 1806
12
Annie McMillan
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.2.1]
b. 1846
11
Archibald Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3]
b. 1814 d. Bef 1881
Barbara
b. 1824
12
James W. Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.1]
b. 1842 [
=>
]
12
George Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.2]
b. 1844
12
Ellen Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.3]
b. 1847
12
Benjamin Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.4]
b. 1849 d. 1895 [
=>
]
12
Jane Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.5]
b. 1853
12
Andrew Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.6]
b. 1857
12
Mary Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.7]
b. 1860
12
Catherine Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.8]
b. 1863
12
Malcolm Fenwick
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3.9]
b. 1865
+
John Thomson
b. 1 Dec 1782 d. 19 Nov 1873
10
Hugh Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 11 Aug 1791 d. 23 Apr 1834
Elizabeth Ruttan
b. 1798 d. 3 Apr 1876
11
Rev. Charles Edward Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.1]
b. 10 Nov 1832 d. 15 Nov 1903
Margaret Geddes Gilkinson
b. 1837 d. 18 Sep 1928
12
Henry Andrew Hoffman Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.1]
b. Dec 1862 d. 29 Mar 1943 [
=>
]
12
Adelaide Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.2]
b. 1859 d. 20 Jan 1944 [
=>
]
12
Charles Townley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.3]
b. 1860
12
Charlotte Margaret Cecilia Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.4]
b. 1864 d. 26 Feb 1953 [
=>
]
12
William Colburne Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.5]
b. 1867
12
Reginald Hugh Ruttan Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.6]
b. 1869 d. 1887
12
Frances Dora Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.7]
b. 1872 d. 1887
12
Kenneth Gilbert Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.1.8]
b. Jun 1880 d. Jun 1966 [
=>
]
11
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.2]
+
John Snowden
11
William Henry Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.3]
b. Jul 1824 d. 20 Aug 1825
11
Jane McLeod Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.4]
b. May 1826 d. 8 Jul 1826
11
Reginald Heber Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.5]
b. 1829 d. 6 Nov 1833
11
Adolphus Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.6]
b. 1830
11
Mary Adelaide Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.7]
b. 31 May 1831 d. 4 Mar 1847
11
Hugh Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.6.8]
b. 1834
+
Elizabeth Spafford
b. 1792 d. 7 Jul 1814
10
Edward William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 15 Jan 1794 d. 20 Apr 1865
Sarah Maria Terry
b. 22 Oct 1796 d. 1827
11
Elizabeth Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.1]
b. 18 Mar 1816 d. 2 Jun 1839
Rev. Andrew Bell
12
Andrew Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.1.1]
b. 1834 [
=>
]
12
William Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.1.2]
b. 1835
12
Eliza Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.1.3]
b. 1837
11
Mary Debra Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.2]
b. 14 Jun 1817 d. 21 Apr 1851
Rev. Thomas Champion
12
Thomas Champion
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.2.1]
12
Jane Champion
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.2.2]
12
Minnie Champion
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.2.3]
12
Henry Champion
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.2.4]
b. 28 Nov 1847 [
=>
]
11
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.3]
b. 6 Feb 1819 d. 1852
Mary White
12
Edward William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.3.1]
[
=>
]
Sarah Fisher
b. 19 Dec 1816 d. 6 Apr 1889
12
Edward Thomas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.3.2]
b. 16 Dec 1838 d. 1845
11
Hugh Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.4]
b. 15 Feb 1821 d. 11 Jan 1877
Esther Lippincott Denison
12
Hugh Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.4.1]
12
Florence Esther Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.4.2]
12
Grace Maria Lippincott Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.4.3]
11
Francis Lydia Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.5]
b. 12 Aug 1822 d. 17 Oct 1852
+
Henry Thomas Imlach
11
Edward William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.6]
b. 27 Apr 1824 d. 1 Feb 1899
Margaret Hamilton Foley
b. 3 May 1827 d. Aft 31 Mar 1881
12
Margaret Hamilton Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.6.1]
b. 1861 [
=>
]
12
Charles P. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.6.2]
12
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.6.3]
12
Sarah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.6.4]
12
Frances Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.6.5]
b. 10 Mar 1846 d. 28 Nov 1922 [
=>
]
12
Edward William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.6.6]
b. 12 Feb 1849 d. 5 Mar 1924 [
=>
]
12
Bernard Henry Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.6.7]
b. 14 Oct 1850 d. 1889 [
=>
]
11
Sarah Maria Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7]
b. 20 Feb 1826 d. 11 Mar 1867
Edwin C. Fisher
12
Thomas Fisher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7.1]
b. Abt 1848
12
Edwin Chisholm Fisher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7.2]
12
Sarah Maria Fisher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7.3]
b. Abt 1861
12
Frances Mary Fisher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7.4]
12
Richard Fisher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7.5]
12
William Fisher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7.6]
12
Aylmer Hugh Fisher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7.7]
12
Sidney Fisher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7.8]
b. Abt 1859
12
Frederick T. Fisher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.7.9]
b. Abt 1864
Mary Ketchum
b. Sep 1804 d. 7 Mar 1832
11
Jesse Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.8]
b. 18 Jul 1830
Elvira Maria Talbot
b. 27 Apr 1834 d. 10 Sep 1864
12
Adelaide Mary Eliza Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.8.1]
b. 2 May 1856 d. 12 May 1856
12
Edward Freeman Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.8.2]
b. 26 May 1857 d. 10 Jul 1884
12
Lily Selina Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.8.3]
b. 3 Feb 1860 d. 31 Jul 1940
12
Hugh Jesse Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.8.4]
b. 14 Apr 1862 d. 28 Sep 1941
12
Arthur Talbot Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.8.5]
b. 2 Sep 1863 d. Oct 1960 [
=>
]
11
Anne Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.9]
b. 19 Feb 1832 d. 26 Jun 1934
Selena Lee Chisholm
b. 14 May 1802 d. 7 Jun 1885
11
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.10]
b. 12 Jun 1836
Andrew Bell
b. 1834
12
Helen Eleanor Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.10.1]
b. 1864 d. 3 Jan 1963 [
=>
]
12
Rosalind Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.10.2]
b. 1860
12
Mary A Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.10.3]
b. 1864
12
Margaret Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.10.4]
b. 1867
12
Andrew Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.10.5]
b. 1870
12
Alice Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.10.6]
b. 1874
12
James Bell
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.10.7]
b. 1878
10
Alexander Stewart Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 28 Jul 1796
Anna Pringle
b. 1799 d. Bef 1830
11
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.1]
b. 1819 d. 1832
11
Nancy Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.2]
b. 1821 d. 1832
11
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.3]
b. 1823 d. 1832
Susan Echardt
b. 1796 d. Bef 1861
11
Anne Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.4]
b. 1830
Dr. Hiram Noble
b. 21 Oct 1828
12
Edward Noble
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.4.1]
12
Parker Noble
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.4.2]
12
Herbert Thomson Noble
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.4.3]
b. 21 Sep 1880
12
Frederick Noble
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.4.4]
12
Ambrose Noble
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.4.5]
12
Anna Noble
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.4.6]
11
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.5]
b. 1830
John Fierheller
b. 1818
12
Anne Fierheller
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.5.1]
b. 5 Dec 1850
12
Julian Fierheller
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.5.2]
b. 25 Sep 1852
12
Alexander Fierheller
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.5.3]
b. 1860
12
John W. Fierheller
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.5.4]
b. 8 Nov 1863
12
James Fierheller
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.5.5]
b. 13 Aug 1867
12
George Fierheller
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.5.6]
b. 4 Apr 1870 [
=>
]
12
Nelson Fierheller
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.5.7]
12
Ida Fierheller
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.5.8]
11
George S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.6]
b. 1833
Elizabeth
b. 1838
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.6.1]
b. 1858
12
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.6.2]
b. 1 Aug 1860
12
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.6.3]
b. Oct 1863
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.6.4]
b. 1867
12
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.6.5]
b. 1870
12
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.6.6]
b. 1872
12
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.6.7]
b. 1876
11
Mary Pringle Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.7]
b. 9 May 1835 d. 19 May 1915
John Stephenson
b. 1 May 1834 d. Aft 31 Mar 1901
12
George Stephenson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.7.1]
b. 1 Sep 1859 [
=>
]
12
Anna Euphemia Stephenson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.7.2]
b. 1860 d. 1862
11
Elizabeth Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.8]
b. 1834
Jacob Pingle
b. 1819
12
Cecilia J. Pingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.8.1]
b. 1846
12
Warren H. Pingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.8.2]
b. 18 May 1854 [
=>
]
12
Walter Pingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.8.3]
12
Emily Pingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.8.4]
b. 1857
12
Ida Pingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.8.5]
b. 1862
12
Charles Pingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.8.6]
b. 1867
12
Elizabeth Pingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.8.7]
b. 1880
11
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.9]
b. 1837
11
Alexander Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.10]
b. Abt 1839
Jane Brethour
b. Abt 1855
12
Jay Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.10.1]
10
Archibald John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9]
b. 1 Mar 1799 d. 4 Dec 1875
Margaret Mary Willer
b. 29 May 1802 d. 29 May 1858
11
Archibald P Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.1]
b. 8 Jan 1824 d. 16 Mar 1894
11
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.2]
b. 8 May 1825
Jane Sisson
b. 1 Mar 1832 d. 12 Jul 1854
12
Peter A J Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.2.1]
b. 19 Jun 1852 [
=>
]
11
Joanna Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.3]
b. 18 Aug 1838
John Burgess
12
Alexander Burgess
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.3.1]
b. 1862
12
Margaret Burgess
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.3.2]
b. 1865
12
Archibald Burgess
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.3.3]
b. 1867
12
Janet Burgess
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.3.4]
12
Jessie Burgess
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.3.5]
b. 1872
12
Frank Burgess
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.3.6]
11
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.4]
b. 11 Apr 1827
Stephenson Vatcher
b. 1820
12
Archibald D. Vatcher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.4.1]
b. 1861
12
James E. Vatcher
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.4.2]
b. 1863
11
Alexander Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.5]
b. 6 Jul 1830
Susanna Brown
b. 1828
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.5.1]
12
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.5.2]
12
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.5.3]
b. 1857
12
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.5.4]
b. 1859
12
Dorothy Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.5.5]
11
Andrew Scarlet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.6]
b. 29 Mar 1831
11
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.7]
b. 9 Oct 1835
11
Charles Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.8]
b. 18 Feb 1841
+
Elizabeth Hewitt
b. 1844
11
James Bambie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.9]
b. 24 Jun 1843
+
Katherine Kelly
b. 1838
11
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.10]
b. 22 Nov 1833
Janet Smith
b. 1837 d. Bef 1881
12
Isabella S. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.10.1]
b. 1858
12
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.10.2]
b. 1861 [
=>
]
12
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.10.3]
b. 1862
12
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.10.4]
b. 1864 [
=>
]
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.10.5]
[
=>
]
12
Heber Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.10.6]
b. 1867 [
=>
]
12
Elmita Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.10.7]
+
Sophia
b. 1805
10
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10]
b. 18 May 1801 d. 28 Sep 1840
Lydia Terry
b. 1806 d. 28 Apr 1844
11
Hugh Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.1]
b. 21 Sep 1834 d. 1870
Mary Nicol Sylvester
b. 1838 d. 8 Aug 1922
12
Herbert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.1.1]
b. 5 Feb 1867 d. 12 Jul 1930 [
=>
]
12
Arthur Wellseley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.1.2]
b. 7 Mar 1858
12
George Edgar Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.1.3]
b. 1 Nov 1863 d. 8 Aug 1922
11
Archibald Parshall Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.2]
b. 1 Aug 1824 d. 18 Mar 1894
Barbara Paterson
b. 30 May 1832 d. 4 Aug 1904
12
Isabella Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.2.1]
b. 1853
12
Lydia M. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.2.2]
b. 22 Jun 1857
12
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.2.3]
b. 1858 d. 14 Oct 1887
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.2.4]
b. 1859
12
Rhoda Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.2.5]
b. 14 Dec 1863 d. 19 May 1881
12
Barbara Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.2.6]
b. 1865
12
Charlotte Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.2.7]
b. 1869
11
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3]
b. 9 Nov 1825
Thomas Paterson
b. 1823
12
Archibald Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.1]
12
Thomas Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.2]
12
Charles Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.3]
12
John Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.4]
b. 1852
12
Mary Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.5]
b. 1857
12
Andrew Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.6]
b. 1860
12
George Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.7]
b. 1862
12
Isabella Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.8]
b. 1864
12
James Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.9]
b. 1867
12
Elizabeth Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.10]
b. 1867
12
Harriet Paterson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3.11]
b. 1872
11
Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.4]
b. 18 Jul 1827
11
Edward Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.5]
b. 13 Nov 1828 d. 20 Nov 1911
+
Mary Larway
b. 1838 d. Bef 1881
11
Rhoda Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.6]
b. 15 Aug 1831
11
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.7]
b. 28 Apr 1833
Samuel Thompson
b. 1811
12
Frank Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.7.1]
b. 1874
11
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.8]
b. 24 Jul 1836
11
Alexander Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.9]
b. 16 Jan 1838
Elizabeth V Tuck
b. 1845 d. Bef 1901
12
Elizabeth J Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.9.1]
b. 1864
12
Janet W Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.9.2]
b. 2 Jul 1865
12
David A Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.9.3]
b. 13 Aug 1867
12
John James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.9.4]
b. 1870 d. Bef 1873
12
William N Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.9.5]
b. 1872
12
George H Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.9.6]
b. 1873
12
John James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.9.7]
b. 1873
11
Charles Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.10]
b. 16 Feb 1840 d. Aft 1915
10
Agnes Nancy Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11]
b. 17 Jan 1804 d. 17 Jun 1848
John William Crosby
b. 1798 d. 26 Jan 1875
11
William Archibald Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.1]
b. 12 Apr 1826 d. 8 Jan 1846
11
Marshall B. Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.2]
b. 15 Jul 1828 d. 27 Jul 1876
Louisa Snowdon
b. 5 Mar 1837 d. 26 May 1874
12
Eva Diana Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.2.1]
b. 8 Jul 1870 d. 15 Oct 1870
12
Ada Florence Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.2.2]
b. 15 Nov 1872 d. 6 Jun 1876
12
John William Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.2.3]
b. Abt 1861
12
Louisa Agnes Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.2.4]
b. Abt 1863 d. 22 Feb 1934
11
Adolphus Homer Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.3]
b. 29 Oct 1834 d. 12 Mar 1841
11
Maria T. Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.4]
b. Abt 1828 d. 11 Nov 1907
Benjamin Brayley Stockton Jenkins
b. Abt 1825 d. 3 Feb 1894
12
Agnes Thomson Jenkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.4.1]
b. Abt 1850 d. 1 May 1924 [
=>
]
12
William Jenkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.4.2]
b. Jan 1853 d. 13 Dec 1919 [
=>
]
12
John Crosby Jenkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.4.3]
b. 1855 [
=>
]
12
Mary Helen Jenkins
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.4.4]
b. Jun 1863
11
Ellen Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.5]
11
Matilda Augusta Crosby
[1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.6]
b. 26 Jan 1840 d. 2 Jan 1846
9
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 25 May 1751 d. 7 Aug 1823
Elizabeth (Betty) Borthwick
b. 18 Aug 1765 d. 13 Jul 1789
10
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 1 Dec 1782 d. 19 Nov 1873
+
Nancy Ann Smith
b. 8 Nov 1786 d. 8 Apr 1861
+
Helen Eleanor Thomson
b. 30 Apr 1789 d. 30 Mar 1872
10
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 17 May 1784 d. 1819
10
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. 7 Sep 1788 d. 30 Apr 1789
10
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.4]
10
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.5]
b. 5 Jun 1786
10
Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.6]
10
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.7]
10
Jean Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.8]
b. Sep 1785 d. 30 Apr 1786
Jean Henderson
b. 18 Jul 1771 d. 27 May 1842
10
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.9]
b. 23 Dec 1792
10
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10]
b. 1 Dec 1796 d. 28 Dec 1878
William C. Jones
b. 7 Nov 1794 d. 13 Aug 1857
11
Andrew Thomson Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.1]
b. 1817 d. 26 Apr 1899
+
Sarah Taylor
b. Abt 1825
Sarah Shrubb
b. 24 Feb 1822 d. 8 Dec 1884
12
Richard Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.1.1]
b. Abt 1849
12
Lorenzo Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.1.2]
b. Abt 1855
12
John Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.1.3]
b. Abt 1857
12
Andrew D. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.1.4]
b. Abt 1859
11
John C. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.2]
b. 19 Jul 1828 d. 26 Oct 1893
Caroline Abigail Stephens
b. 1834
12
Ethlindra Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.2.1]
b. 1856
11
Elizabeth Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.3]
b. 1837
Allen Taylor McNutt
b. 1834 d. 22 Apr 1901
12
William Henry McNutt
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.3.1]
b. 6 Jan 1863 d. 22 Jul 1934 [
=>
]
12
Alpheus T. McNutt
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.3.2]
b. 1860
11
Lorenzo Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.4]
b. 25 May 1831 d. 26 Dec 1892
Hannah Irvine
b. 4 Jun 1837 d. 11 Jun 1913
12
William Thomson Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.4.1]
b. 21 Jul 1860 [
=>
]
12
John Westley Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.4.2]
b. 1863
12
David Watson Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.4.3]
b. 1865 [
=>
]
12
Almon Oke Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.4.4]
b. 1867 [
=>
]
12
Mary Jane Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.4.5]
b. 1860 d. 1938 [
=>
]
12
Eleanor Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.4.6]
b. 1862 d. 1939
12
Urias Achum Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.4.7]
11
Archibald Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5]
b. 1829
Miranda Jane McNutt
b. 1839 d. Bef 1881
12
Allan T. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5.1]
b. 1866
12
Mary Melesia Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5.2]
b. 1865
12
William Ferguson Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5.3]
b. 1860
12
George M. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5.4]
b. 1863
12
Emily Janet Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5.5]
b. 1868
Annie McPhee
b. 1850
12
John Wesley Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5.6]
b. 19 May 1883 d. 25 Sep 1918
12
Flora Bell Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5.7]
b. 17 Apr 1890
12
Lorenzo Daniel Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5.8]
b. Abt 1886
12
William Archibald Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.5.9]
b. 19 Oct 1888 d. 12 Apr 1947 [
=>
]
11
Mary Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6]
b. Jul 1824 d. 4 Sep 1871
George N. Hill
b. Jul 1819 d. 26 Sep 1900
12
Martha Jane Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6.1]
b. 14 Oct 1849 d. 11 Mar 1922 [
=>
]
12
John Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6.2]
b. 1847 d. 8 May 1918 [
=>
]
12
Thomas Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6.3]
b. 1843
12
William Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6.4]
b. 1844 d. 10 Dec 1907
12
Andrew Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6.5]
b. 1845
12
Elizabeth A. Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6.6]
b. 1850
12
George N. Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6.7]
b. 1853
12
Lorenzo Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6.8]
b. 1856
12
Janet Z. Hill
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.6.9]
b. 1858
11
Marcy Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.7]
b. 1822
John Miller Stephens
b. 31 Oct 1813 d. 24 Aug 1891
12
Weston James Stephens
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.7.1]
b. 26 Jan 1843 d. 9 Dec 1898 [
=>
]
12
William John Stephens
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.7.2]
b. 2 Jun 1846 d. 5 Dec 1885 [
=>
]
12
Hannah Jennett Stephens
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.7.3]
b. 30 Jun 1847 d. 10 Feb 1937 [
=>
]
12
Mary Ann Stephens
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.7.4]
b. 24 Dec 1849 d. 5 Sep 1903 [
=>
]
11
Sarah Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.8]
b. 1835
+
William Ferguson
b. 15 Nov 1832
11
Charlotte Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.9]
b. 1843 d. Bef 1857
11
Eleanor Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.10]
b. 1846
+
Harris Lotton
11
James Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.11]
b. 1 Mar 1849
Hannah Wilson
b. 19 Sep 1857
12
Frederick Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.11.1]
b. Feb 1876
12
Foster Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.11.2]
b. 13 Dec 1878 d. 5 Oct 1964 [
=>
]
12
Albert Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.11.3]
b. Abt 1882
12
Mabel Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.11.4]
b. Abt 1883
12
Alvin J. Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.10.11.5]
b. Abt 1885
10
William A Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11]
b. 1 Jan 1798 d. 2 Aug 1877
Mary Polly Willer
b. 1802
11
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.1]
b. 25 Mar 1823
11
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.2]
b. 11 Apr 1825
11
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.3]
b. 14 Sep 1826
Mary Diell
b. 1831
12
Sarah Deyell Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.3.1]
b. 1853
12
Martha Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.3.2]
b. 1858
12
William John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.3.3]
b. 1861
11
George W Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.4]
b. 11 Aug 1831 d. 4 Dec 1905
Elizabeth Tudhop
b. 12 Apr 1838 d. 13 Jan 1912
12
William G. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.4.1]
b. 13 Jun 1858 d. 26 Oct 1932 [
=>
]
12
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.4.2]
b. 1 Jul 1860 d. 4 Mar 1902
12
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.4.3]
b. 4 Jun 1863 d. 27 May 1940 [
=>
]
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.4.4]
b. 24 Jul 1866 d. 23 Mar 1941 [
=>
]
12
Elizabeth Weir Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.4.5]
b. 13 Aug 1869 d. 2 Jul 1950 [
=>
]
12
Rev. David Daniel Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.4.6]
b. 15 Mar 1872 d. 10 Oct 1935 [
=>
]
12
Margaret Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.4.7]
b. 22 Feb 1874 d. 22 Jul 1874
12
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.4.8]
b. 18 Sep 1875 d. 12 Sep 1933 [
=>
]
11
Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.5]
b. 8 Oct 1833
11
Helen Tingle Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6]
b. 5 Mar 1835 d. 18 Mar 1911
George Patton
b. 1836 d. 25 Feb 1879
12
Mary Patton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6.1]
b. 8 Jan 1860 d. 24 Mar 1927 [
=>
]
12
Margaret Patton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6.2]
b. 1862 [
=>
]
12
Elizabeth Patton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6.3]
b. 5 Jun 1863 d. 1947 [
=>
]
12
James Patton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6.4]
b. 15 Jul 1865 d. 17 Nov 1965
12
William Patton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6.5]
b. 1867
12
Jane Patton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6.6]
b. 1869 [
=>
]
12
George Patton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6.7]
b. 21 Mar 1871 d. 11 Aug 1908 [
=>
]
12
Ellen Patton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6.8]
b. 20 Feb 1873 d. 3 May 1933
12
Martha Patton
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.6.9]
b. 30 Sep 1875 d. 7 Sep 1976
11
David Graham Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.7]
b. 11 Feb 1837
11
Elizabeth Gilchrist Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.8]
b. 7 Mar 1839
11
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.9]
b. 12 Jul 1848
11
James W. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.10]
b. 1828
Agnes Moyle
b. 1832
12
Letitia J Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.10.1]
b. 1850
12
Mary Elizabeth Tuck Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.10.2]
b. 13 Feb 1852
12
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.10.3]
b. 1854
12
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.10.4]
b. 1856
12
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.11.10.5]
b. 1859
10
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12]
b. 14 May 1800 d. 27 Jul 1875
John Tingle
b. 1789 d. 11 Feb 1877
11
John Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.1]
b. 10 Jul 1837 d. 25 Nov 1915
Eliza Devonish
b. 15 Nov 1845 d. 28 Sep 1909
12
Mary Ellen Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.1.1]
b. 26 Oct 1871 d. 25 Oct 1936 [
=>
]
12
Emily Alice Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.1.2]
b. 2 Jul 1878 [
=>
]
11
Andrew Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.2]
b. 1821 d. 20 Mar 1900
Mary Patton
b. 29 Oct 1837 d. 2 Nov 1918
12
James George Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.2.1]
b. 14 Feb 1871
12
William Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.2.2]
b. 17 Jun 1874 d. 8 Jun 1927
12
Mary Jane Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.2.3]
b. 13 Sep 1877 [
=>
]
12
Robert Kenneth Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.2.4]
b. 7 Aug 1879 d. 9 May 1880
Unknown Tingle
12
John Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.2.5]
b. 1851
12
Elizabeth M. Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.2.6]
b. 1863
11
Jane Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.3]
b. 1826 d. 30 Apr 1870
11
Joseph Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.4]
b. 1 Apr 1840 d. 28 Sep 1917
Christina Hall
b. 1842 d. 26 Jul 1899
12
John Hall Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.4.1]
b. 17 Oct 1876 d. 6 Feb 1877
12
George Albert Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.4.2]
b. 11 Jul 1874 [
=>
]
11
Mary Ann Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.5]
b. May 1834 d. 31 Oct 1886
11
Margaret Amelia Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.6]
b. 1844
Thomas Shanks
b. 1843
12
John Shanks
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.6.1]
b. 20 Jan 1873
12
Ellen Thompson Shanks
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.6.2]
b. 24 Apr 1875
12
Robert Crosby Shanks
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.6.3]
b. 3 Mar 1886
11
Isabella Tingle
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.7]
b. 14 Nov 1835 d. 23 Jul 1923
Thomas Mason
b. Sep 1834 d. 2 Apr 1878
12
Thomas Franklin Mason
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.7.1]
b. 26 Mar 1869 d. 30 Jul 1949 [
=>
]
12
William Mason
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.12.7.2]
b. 6 Aug 1860 d. 4 Feb 1947 [
=>
]
10
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13]
b. 14 May 1800 d. 14 Dec 1876
Christopher Thomson
b. 31 Aug 1796 d. 13 Dec 1879
11
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.1]
b. 5 Sep 1820 d. 30 May 1876
Margaret Dand
b. 4 Feb 1843 d. 24 Mar 1916
12
Marion Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.1.1]
b. 1864 d. 6 Mar 1895 [
=>
]
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.1.2]
b. 1866 d. 1934
12
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.1.3]
b. 15 Jul 1867 d. 1948
12
William Walter Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.1.4]
b. 27 Jul 1869 [
=>
]
12
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.1.5]
b. 15 Oct 1872 [
=>
]
12
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.1.6]
b. 29 Oct 1873 d. 4 Nov 1956 [
=>
]
12
Eleanor Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.1.7]
b. 1874
11
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.2]
b. 24 Jun 1822 d. 26 Dec 1880
11
Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3]
b. 20 Feb 1824
William Nichol
b. Abt 1818
12
Mary Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.1]
b. 27 Jan 1844 d. 23 May 1917 [
=>
]
12
Rachel Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.2]
b. 1 Jan 1846 d. 1 May 1928 [
=>
]
12
Ann Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.3]
b. 1847 [
=>
]
12
David Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.4]
b. 15 Nov 1849 d. 19 Sep 1923 [
=>
]
12
Christopher Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.5]
b. 18 Oct 1852 d. 6 Jun 1933
12
William Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.6]
b. 5 Jan 1855 d. 15 Dec 1916
12
Andrew Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.7]
b. 24 Jan 1856 d. 13 Aug 1926
12
Isabella Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.8]
b. 1860
12
John Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.9]
b. 20 Jan 1863 d. 13 Jan 1926 [
=>
]
12
Jane Nichol
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.3.10]
b. 18 Sep 1866 d. 18 Aug 1926 [
=>
]
11
Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.4]
b. 30 Sep 1825
Ichabod Vanderburgh
b. Abt 1815 d. 28 Jan 1892
12
William Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.4.1]
b. Aug 1850 d. 4 Feb 1896
12
Mary Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.4.2]
b. Abt 1853
12
Christopher Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.4.3]
b. 1855
12
Bradley Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.4.4]
b. Abt 1857 [
=>
]
12
Elizabeth Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.4.5]
b. Abt 1859
12
Annie Vanderburgh
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.4.6]
b. Abt 1866
11
Archibald Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.5]
b. 19 Apr 1827 d. 21 Jan 1894
Ann Hudson
b. 1841 d. Bef 1891
12
Annie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.5.1]
b. 1864
12
Janet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.5.2]
b. 1872
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.5.3]
b. 1874
11
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.6]
b. 14 Feb 1829
+
Charlotte Thompson
b. 1832
11
James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.7]
b. 14 Feb 1829 d. 11 Jun 1906
Mary Ross
b. 9 Oct 1836 d. 11 Nov 1913
12
James Ross Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.7.1]
b. 14 Nov 1867 d. 1953 [
=>
]
12
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.7.2]
b. 5 Jan 1870 d. 1950
12
Susannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.7.3]
b. 23 Aug 1874 d. 1950 [
=>
]
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.7.4]
b. 1862 d. 1 Jun 1926 [
=>
]
12
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.7.5]
b. 20 Sep 1862 d. 1951
12
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.7.6]
b. 11 Aug 1872
12
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.7.7]
b. Jan 1878 d. 15 Mar 1882
11
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.8]
b. 22 Mar 1832 d. 27 Feb 1911
Charlotte Ross
b. 10 Jun 1839 d. 16 Aug 1905
12
Susan Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.8.1]
b. 6 Jun 1863 d. 11 Feb 1920 [
=>
]
12
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.8.2]
b. 1867
12
Ellen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.8.3]
b. 10 Sep 1868 d. 19 Aug 1932 [
=>
]
12
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.8.4]
b. 7 Jan 1871 d. 29 Nov 1937
12
Flora Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.8.5]
b. 1873 [
=>
]
12
Charlotte Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.8.6]
b. 14 Mar 1876 [
=>
]
12
Janet F. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.8.7]
b. 1878
11
Frances Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.9]
b. 23 Dec 1838
James Thompson
12
Fanny Thompson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.9.1]
11
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.10]
b. 20 Dec 1840 d. 22 Jan 1893
11
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.11]
b. 23 Feb 1843 d. 17 May 1917
11
Simon Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.12]
b. 22 Mar 1836 d. 21 Mar 1889
Sarah Scott
b. 1836 d. 2 Apr 1921
12
Christopher William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.12.1]
b. 22 Jun 1867 [
=>
]
12
Frances A Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.12.2]
b. 1871
12
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.12.3]
b. 1869
11
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.13]
b. 1 May 1834 d. Bef 1881
James Main
b. 26 Aug 1827
12
Charles Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.13.1]
b. 1859
12
Mary Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.13.2]
b. 1861
12
Janet Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.13.3]
b. 1863
12
Ann Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.13.4]
b. 20 Nov 1864
12
Elizabeth Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.13.5]
b. 22 Nov 1866
12
Christopher Main
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.13.13.6]
b. 11 Mar 1870 [
=>
]
10
James Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14]
b. 20 Mar 1802 d. 28 Oct 1884
Agnes Paterson
b. 1807 d. 3 Jun 1875
11
Andrew J. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.1]
b. 23 Mar 1825 d. 24 Apr 1895
Elizabeth Bell
b. 1826 d. 24 Nov 1913
12
James William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.1.1]
b. Dec 1848 d. 19 Jan 1856
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.1.2]
b. 1851 d. 18 Feb 1932 [
=>
]
12
Josephine Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.1.3]
b. 4 Jun 1853 d. 12 Dec 1923
12
Agnes Bell Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.1.4]
b. Abt 1855 d. 16 Jul 1883
12
Herber Leslie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.1.5]
b. 30 Apr 1858
11
Thomas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.2]
b. 7 Feb 1827 d. 10 May 1909
Mary Ann Hipkins
b. 30 Sep 1832 d. 15 Jun 1867
12
Mary Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.2.1]
b. 7 Jun 1853 [
=>
]
12
Albert Wales Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.2.2]
b. 1855 [
=>
]
12
Agnes Hood Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.2.3]
b. 12 Apr 1857 d. 10 Nov 1935 [
=>
]
12
James E. R. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.2.4]
b. 1863 d. 1940 [
=>
]
12
William George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.2.5]
b. 31 May 1866 d. 1947 [
=>
]
Louise Jane Newman
b. 20 Oct 1840 d. 20 Feb 1915
12
William Thomas Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.2.6]
b. 6 Apr 1871 d. 22 Mar 1945 [
=>
]
12
Florence Minerva Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.2.7]
b. 27 Sep 1872 d. 23 Jun 1895
12
Andrew Colvin Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.2.8]
b. 18 Jun 1875 d. 1951 [
=>
]
11
Mary Paterson Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.3]
b. 26 Apr 1831 d. 4 Jul 1850
11
Hannah Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4]
b. 7 Apr 1833 d. 14 Oct 1905
John Wakefield
b. 20 Oct 1828 d. 28 Aug 1909
12
Joseph Wakefield
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4.1]
b. 30 Mar 1853
12
Mary I. Wakefield
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4.2]
b. 26 Mar 1855
12
Agnes Wakefield
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4.3]
b. 11 Oct 1858 d. 17 Jan 1926 [
=>
]
12
James S Wakefield
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4.4]
b. Aug 1857 [
=>
]
12
Robert John Wakefield
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4.5]
b. 31 Dec 1862 [
=>
]
12
Andrew Wakefield
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4.6]
b. Abt 1866
12
William Wakefield
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4.7]
b. 30 May 1869 d. 6 Apr 1870
12
Margaret Janet Wakefield
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4.8]
b. 17 Feb 1872 d. 4 Sep 1938 [
=>
]
12
John Wakefield
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.4.9]
b. 17 Jan 1861 d. 1945
11
Robert William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.5]
b. 13 Apr 1835 d. 18 Dec 1877
Helen Jane Tindill
b. 24 Jan 1840 d. 18 Jun 1919
12
Elizabeth Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.5.1]
b. 30 Jul 1860 [
=>
]
12
Agnes Paterson Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.5.2]
b. Abt 1863 d. 19 Aug 1927 [
=>
]
12
James A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.5.3]
b. 1865 d. Bef 1930 [
=>
]
12
Hester E. A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.5.4]
b. 13 Aug 1866 d. Dec 1942
12
George H. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.5.5]
b. Bef 1869 d. Jan 1941
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.5.6]
b. 1872 d. 1872
12
David Cane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.5.7]
b. 1874 d. Oct 1935 [
=>
]
11
Agnes Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.6]
b. 25 Sep 1837 d. Mar 1865
Alexander Muir
b. 3 Apr 1830 d. 26 Jun 1906
12
John George Muir
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.6.1]
b. 30 Jan 1859 d. Jun 1939 [
=>
]
12
James Joseph Muir
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.6.2]
b. 24 Feb 1860 d. Aft 1935
12
Colinetta Campbell Muir
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.6.3]
b. 6 Jul 1863 d. 7 Jan 1931 [
=>
]
11
James George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.7]
b. 25 Jul 1839 d. 16 Nov 1917
Agnes Glendinning
b. 9 Apr 1840 d. 11 Jan 1916
12
Eliza Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.7.1]
b. 18 Mar 1862 d. 17 Sep 1929 [
=>
]
12
William James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.7.2]
b. 1 Sep 1863 d. 6 Dec 1922 [
=>
]
12
Andrew Henderson Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.7.3]
b. 24 Sep 1865 d. 4 Oct 1945 [
=>
]
12
Oliver Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.7.4]
b. 2 Sep 1867 d. 13 Aug 1942 [
=>
]
12
Agnes Ida Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.7.5]
b. 21 Feb 1870 d. 23 Jun 1905 [
=>
]
12
Allan Goodwin Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.7.6]
b. 11 Jul 1883 d. 18 Nov 1953 [
=>
]
11
John Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.8]
b. 5 Jul 1842 d. 14 Sep 1848
11
William Scotland Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.14.9]
b. 27 Jul 1845 d. 8 Sep 1848
10
Andrew A. Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15]
b. 24 Nov 1794 d. 24 May 1873
Hannah Willer
b. Abt 1801 d. 13 Jan 1889
11
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.1]
b. 16 Sep 1826 d. 9 Jun 1899
William Rawson
b. 1834 d. 23 Mar 1868
12
Hannah Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.1.1]
b. 19 Dec 1858 d. 25 May 1909
12
William Jr. Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.1.2]
b. 13 Mar 1861 d. 12 Feb 1938
12
Thomas Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.1.3]
b. 9 Jul 1862 d. 27 Sep 1863
12
Mary Ellen Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.1.4]
b. 3 Feb 1864 d. 4 Mar 1897
12
Thomas Andrew Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.1.5]
b. 18 Aug 1865 d. 27 Jul 1953 [
=>
]
12
Ursula Margaret Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.1.6]
b. 30 May 1868 d. 27 Jul 1938 [
=>
]
11
Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.2]
b. 12 Jun 1822 d. 6 Jul 1849
11
Ann Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.3]
b. 17 May 1825 d. 4 Jul 1856
11
James Alexander Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4]
b. 22 Aug 1831 d. 19 Feb 1907
Mary Ann Sisley
b. 1 Feb 1850 d. 1939
12
Margaret Hannah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.1]
b. 17 Dec 1867 d. 1967 [
=>
]
12
John Wesley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.2]
b. 2 Apr 1870 d. 20 Aug 1952 [
=>
]
12
Ruben Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.3]
b. 15 Jan 1873 d. 23 Dec 1964 [
=>
]
12
James Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.4]
b. 1876 d. 1956 [
=>
]
12
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.5]
b. 1879 d. 7 Jul 1881
12
Francis Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.6]
b. 31 Mar 1881 d. Apr 1973 [
=>
]
12
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.7]
b. 10 Sep 1884 d. 16 Feb 1973 [
=>
]
12
Robert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.8]
b. 16 Jan 1887 d. 1887
12
George Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.9]
b. 10 Feb 1888 d. 1953 [
=>
]
12
Joseph Henry Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.10]
b. 2 Feb 1889 d. 1971
12
Charlotte May Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.11]
b. 29 May 1891 d. 1981 [
=>
]
12
Mary Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.4.12]
b. 16 Jul 1895 d. 1987 [
=>
]
11
Susanna Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5]
b. 2 Aug 1832 d. 2 Jul 1913
Thomas Rawson
b. 2 Feb 1830 d. 6 Jun 1898
12
Mary Ann Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.1]
b. 19 Aug 1854 d. 10 Dec 1883 [
=>
]
12
Joseph Andrew Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.2]
b. 8 Jan 1856 d. 28 Apr 1921 [
=>
]
12
Hannah Jane Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.3]
b. 24 Jul 1857 d. 29 Jul 1940 [
=>
]
12
James Alexander Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.4]
b. 19 Dec 1859 d. 1 Jun 1941 [
=>
]
12
Margaret Isabella Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.5]
b. 4 Mar 1862 d. 20 Feb 1896 [
=>
]
12
Thomas Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.6]
b. 22 Dec 1866 d. 8 Sep 1867
12
Thomson Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.7]
b. 22 Dec 1866 d. 7 Oct 1867
12
William Charles Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.8]
b. 29 Nov 1868 [
=>
]
12
David John Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.9]
b. 30 Oct 1870 d. 18 Nov 1871
12
Martha Musa Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.5.10]
b. 28 Nov 1873 d. 24 Dec 1965
11
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.6]
b. Oct 1839 d. 5 Jun 1914
Charles Rawson
b. Abt 1832 d. 17 Aug 1907
12
Rebecca Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.6.1]
b. Feb 1872
11
Isabella Harriet Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.7]
b. 1839 d. 3 Mar 1862
Charles Rawson
b. Abt 1832 d. 17 Aug 1907
12
Elizabeth Ann Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.7.1]
b. Abt 1861 d. 3 Mar 1901 [
=>
]
12
Isabella Rawson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.7.2]
b. Abt 1862 d. 1887
11
John Wesley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.8]
b. 1843 d. 20 Nov 1849
11
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.9]
b. Oct 1828 d. 5 Nov 1828
11
David Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.10]
b. Abt 1833 d. 18 Jun 1872
Jane McBride
b. Abt 1834 d. 20 Feb 1883
12
John James Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.10.1]
b. Abt 1855 d. 1926
12
Andrew Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.10.2]
b. 1856
12
Hannah Jane Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.10.3]
b. 29 Feb 1856 d. 12 Dec 1926
12
Edmund Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.10.4]
b. 1860
12
David Albert Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.10.5]
b. 28 May 1861 d. 21 Aug 1910
12
William Westley Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.10.6]
b. 25 Dec 1865 d. 6 May 1955
12
Almira Victoria Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.10.7]
b. 20 Oct 1868 d. 21 Jun 1947
11
Pheobe Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.11]
b. 1837
Josiah Hall
b. 1836
12
Sarah E. Hall
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.11.1]
b. 1867 d. 23 Sep 1908
12
Susannah Hall
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.11.2]
b. 1869
12
James Edgar Hall
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.11.3]
b. 1873
11
Jenny Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.12]
11
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.13]
b. Nov 1820 d. 15 Feb 1821
11
Margaret Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.14]
b. 9 Nov 1823 d. 9 Jun 1894
Jobe Jones
b. Dec 1817 d. 18 Nov 1896
12
William Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.14.1]
b. 10 Jun 1843 d. Aft 1901
12
Mary Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.14.2]
b. Abt 1845
12
Andrew Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.14.3]
b. Abt 1846
12
Annie Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.14.4]
b. Aug 1848 d. 29 Oct 1938 [
=>
]
12
Elizabeth Ellen Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.14.5]
b. 5 Jun 1857 d. 17 Nov 1932 [
=>
]
12
Alexander Jones
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.14.6]
b. 1 Jul 1860 d. 27 Mar 1933
11
Sarah Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.15.15]
b. 1835 d. 9 Aug 1841
10
Elizabeth Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.4.16]
b. 1804 d. 21 Sep 1853
9
John Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 13 May 1753 d. 24 Jan 1776
9
Helen Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 1757 d. 1 Jan 1844
Peter Little
b. 1748 d. 19 Jan 1820
10
William Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 9 Jul 1783 d. 8 Sep 1859
Violet Rea
b. 23 Jan 1792 d. 1 Nov 1872
11
Isabella Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.1]
b. 7 Mar 1815
Mr. Dryden
12
Violet Dryden
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.1.1]
b. Jul 1840 d. 1892
Thomas Shiell
b. 1810
12
Elizabeth Shiell
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.1.2]
b. 1845
12
Agnes Shiell
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.1.3]
b. 1847
12
James Shiell
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.1.4]
b. 1852
11
Margaret Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.2]
b. 1817
11
Helen Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.3]
b. 24 Mar 1820
William Cranston
b. 1810
12
James Cranston
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.3.1]
b. 10 Aug 1852
12
Violet Cranston
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.3.2]
b. 28 Apr 1854
12
Janet Mitchell Cranston
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.3.3]
b. 6 Feb 1856
11
Joan Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.4]
b. 29 Jul 1822
11
Archibald Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.5]
b. 27 Nov 1825 d. 21 Dec 1901
Elizabeth Bell
b. 1825 d. 26 Mar 1857
12
Thomas Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.5.1]
12
William Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.5.2]
b. 9 Oct 1854 d. 31 Dec 1926 [
=>
]
11
Thomas Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.6]
b. 1 Nov 1832 d. 12 Nov 1905
10
Thomas Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 14 Feb 1784
11
Thomas Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.1]
b. Abt 1814
11
Walter Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2]
b. Abt 1823
12
Jane Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.2.2.1]
b. Abt 1842
10
Andrew Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 1778 d. 1873
10
Janet Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 29 Apr 1781 d. 30 Jan 1863
John Murray
b. 17 Dec 1777 d. 2 Feb 1809
11
David Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.1]
b. 8 Dec 1804 d. 7 May 1875
11
Peter Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2]
b. 14 Oct 1806 d. 1898
Elizabet Carruthers
b. 7 Nov 1806 d. 1875
12
Mary Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2.1]
b. 19 Jan 1835 d. 26 Aug 1895 [
=>
]
12
John Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2.2]
b. 28 Mar 1836 d. 3 Jun 1911 [
=>
]
12
Thomas Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2.3]
b. 25 Oct 1837
12
Janet Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2.4]
b. 24 Sep 1839 d. 29 Oct 1917 [
=>
]
12
Elizabeth Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2.5]
b. 25 May 1841
12
Isabella Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2.6]
b. 2 Apr 1843 d. 18 Feb 1917 [
=>
]
12
Margaret Little Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2.7]
b. 24 Sep 1847 d. 1 Jul 1892 [
=>
]
12
Peter Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2.8]
b. 23 Aug 1849
12
David Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2.9]
b. 19 Mar 1853 d. 7 Feb 1920 [
=>
]
11
Joan Murray
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3]
b. 19 Mar 1809 d. 26 Dec 1896
William Ritchie
b. 1798 d. 24 Jan 1865
12
Mary Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.1]
b. 3 May 1834 d. 23 Feb 1921 [
=>
]
12
Thomas Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.2]
b. 25 Dec 1835 d. 21 Sep 1877 [
=>
]
12
John L. Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.3]
b. 20 Oct 1837 d. 22 Aug 1917 [
=>
]
12
David Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.4]
b. 16 Feb 1840 d. 7 Nov 1920 [
=>
]
12
William Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.5]
b. 31 Mar 1842 d. 11 Dec 1929 [
=>
]
12
Matida Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.6]
b. 3 Jan 1844 d. 17 Jul 1922 [
=>
]
12
Janet Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.7]
b. 1845
12
Agnes Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.8]
b. 1847
12
James Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.9]
b. 1849 d. Bef 1901 [
=>
]
12
Isaac Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.3.10]
b. 1859 [
=>
]
George Cowan
b. 1772 d. 22 Apr 1830
11
Jane Cowan
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.4]
b. 25 Nov 1814 d. 22 May 1892
12
George Rome
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.4.1]
b. 27 Oct 1834 d. 16 May 1878
12
William Ritchie
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.4.2]
b. 1839 d. 12 Aug 1912 [
=>
]
11
Helen Cowan
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.5]
b. 1816 d. 26 Nov 1899
Thomas Carruthers
b. 1819 d. 3 Jan 1897
12
Andrew Carruthers
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.5.1]
b. 1 May 1847
11
Janet Cowan
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.6]
b. 4 Feb 1819 d. 16 Jul 1892
11
James Cowan
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.7]
b. 7 Mar 1821 d. 9 May 1900
Ann Henderson
12
George Cowan
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.7.1]
b. 1841 [
=>
]
12
Robert Cowan
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.7.2]
b. 1843
12
David Cowan
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.7.3]
b. 1846 [
=>
]
12
Ann Cowan
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.7.4]
b. 19 Oct 1848 d. 22 Jul 1930
11
Gilbert Malcolm Cowan
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.8]
b. 12 Jul 1825 d. 19 Feb 1885
John Glendinning
b. 29 Jan 1772 d. 8 May 1812
11
Andrew Glendinning
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.9]
b. 2 Nov 1811 d. 10 May 1872
10
Isbel Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.5]
b. 23 Dec 1786
10
Archibald Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.6]
b. 22 Jun 1790
10
Betty Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.7]
b. 1792 d. 5 Apr 1845
10
Margaret Little
[1.1.1.1.1.1.1.1.6.8]
b. 1795
9
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 21 Apr 1760 d. 24 Nov 1776
9
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 20 Jul 1755
8
Christopher Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 8 May 1709
8
Richard Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 22 Jul 1711
8
Bessie Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1714
8
William Thomson
[1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 30 Sep 1720
7
David Thomson
[1.1.1.1.1.1.2]
b. 27 Jun 1675 d. Abt 1720
7
Grissil Thomson
[1.1.1.1.1.1.3]
b. 1687 d. 27 Oct 1722
Counts